Actos BORME de Promotora De Inversiones Cupel Sociedad Limitada
09 de Octubre de 2020Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 32846 , F 225, S 8, H M 591305, I/A 9 ( 2.10.20).
18 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apoderado: CASTELLANOS YBARRA JAVIER. Datos registrales. T 32846 , F 225, S 8, H M 591305, I/A 8(11.12.19).
11 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: BUELA FERNANDEZ YAGO;ORGAZ MARTIN PEDRO. Datos registrales. T 32846 , F 224, S 8, H M591305, I/A 7 ( 4.10.17).
19 de Junio de 2017Revocaciones. Apoderado: LLANO ABAITUA MIGUEL. Datos registrales. T 32846 , F 223, S 8, H M 591305, I/A 6 ( 9.06.17).
06 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: ORGAZ MARTIN PEDRO. Datos registrales. T 32846 , F 223, S 8, H M 591305, I/A 5 (29.03.17).
11 de Enero de 2016Nombramientos. Apoderado: ZABALLA BILBAO AMAYA MARIA. Datos registrales. T 32846 , F 223, S 8, H M 591305, I/A 4(30.12.15).
16 de Enero de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ERHARDT ALZAGA ALFONSO;FONTAN ZUBIZARRETA FRANCISCO. Presidente: ERHARDTALZAGA ALFONSO. Secretario: FONTAN ZUBIZARRETA FRANCISCO. Con.Delegado: ERHARDT ALZAGA ALFONSO. Consejero:CASTELLANOS YBARRA JAVIER. Vicepresid.: CASTELLANOS YBARRA JAVIER. Cons.Del.Sol: CASTELLANOS YBARRA JAVIER.Nombramientos. Representan: ERHARDT ALZAGA ALFONSO. Adm. Unico: PROMOTORA DE INVERSIONES FLUMENSOCIEDAD ANONIMA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico.Datos registrales. T 32846 , F 222, S 8, H M 591305, I/A 3 ( 8.01.15).
15 de Diciembre de 2014Cambio de domicilio social. C/ VIA DE LAS DOS CASTILLAS 33 - EDIFICIO 3, 3潞-D (POZUELO DE ALARCON). Datosregistrales. T 32846 , F 222, S 8, H M 591305, I/A 2 ( 5.12.14).
15 de Julio de 2014Nombramientos. Apoderado: ORGAZ MARTIN PEDRO. Datos registrales. T 4742 , F 64, S 8, H BI 37980, I/A 24 ( 3.07.14).
30 de Mayo de 2014Nombramientos. Apoderado: ZABALLA BILBAO AMAYA MARIA. Datos registrales. T 4742 , F 63, S 8, H BI 37980, I/A 22(16.05.14).
Nombramientos. Apoderado: BUELA FERNANDEZ YAGO. Datos registrales. T 4742 , F 63, S 8, H BI 37980, I/A 23 (16.05.14).
04 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apoderado: ORGAZ MARTIN PEDRO. Datos registrales. T 4742 , F 62, S 8, H BI 37980, I/A 20 (21.10.13).
Nombramientos. Apoderado: LLANO ABAITUA MIGUEL. Datos registrales. T 4742 , F 62, S 8, H BI 37980, I/A 21 (21.10.13).
23 de Julio de 2012Nombramientos. Apoderado: BUELA FERNANDEZ YAGO. Datos registrales. T 4742 , F 61, S 8, H BI 37980, I/A 19 ( 5.07.12).
09 de Julio de 2012Revocaciones. Apoderado: ECHANOVE CAMI脩A PEDRO. Datos registrales. T 4742 , F 61, S 8, H BI 37980, I/A 18 (27.06.12).
07 de Marzo de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: CARRASCOSA GARCIA ANGEL. Nombramientos. Apoderado: ZABALLA BILBAO AMAYA. Datosregistrales. T 4742 , F 61, S 8, H BI 37980, I/A 17 (24.02.11).
25 de Febrero de 2010Nombramientos. Apoderado: ECHEVARRIA ZORRILLA JOSE LUIS. Datos registrales. T 4342 , F 204, S 8, H BI 37980, I/A 7 (1.09.06).
Revocaciones. Apoderado: ECHANOVE CAMI脩A PEDRO. Nombramientos. Apoderado: ECHANOVE CAMI脩A PEDRO. Datosregistrales. T 4342 , F 204, S 8, H BI 37980, I/A 8 ( 1.09.06).
Nombramientos. Apoderado: CASTELLANOS YBARRA JAVIER. Datos registrales. T 4742 , F 57, S 8, H BI 37980, I/A 9 ( 1.09.06).
04 de Febrero de 2010Modificaciones estatutarias. 16. Retribuci贸n de los Administradores. . Datos registrales. T 4742 , F 60, S 8, H BI 37980, I/A 16(21.01.10).
27 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: BARRANCO SORIA ANASTASIO. Vicepresid.: BARRANCO SORIA ANASTASIO. Cons.Del.Sol:BARRANCO SORIA ANASTASIO. Nombramientos. Consejero: CASTELLANOS YBARRA JAVIER. Vicepresid.: CASTELLANOSYBARRA JAVIER. Cons.Del.Sol: CASTELLANOS YBARRA JAVIER. Datos registrales. T 4742 , F 60, S 8, H BI 37980, I/A 14
Revocaciones. Apoderado: BARRANCO SORIA ANASTASIO. Datos registrales. T 4742 , F 60, S 8, H BI 37980, I/A 15 (14.02.09).