Actos BORME de Promotora De Minicentrales Sa
18 de Agosto de 2023Reelecciones. Consejero: OTALMA SA. Presidente: OTALMA SA. Cons.Del.Sol: OTALMA SA. Consejero: GOMEZ FERNANDEZJOSE MIGUEL;CORES RAMON MARIA ELENA. Vicepresid.: CORES RAMON MARIA ELENA. Secretario: GOMEZ FERNANDEZJOSE MIGUEL. Cons.Del.Sol: CORES RAMON MARIA ELENA. Con.Delegado: GOMEZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL. Cambio dedomicilio social. PLAZA DE CASTILLA NUMERO 3 BIS (MADRID). Datos registrales. T 35601 , F 5, S 8, H M 59707, I/A 32(10.08.23).
19 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: CORES ARIAS EMILIANO;DIAZ GALINDO JOSE IGNACIO. Secretario: DIAZ GALINDO JOSEIGNACIO. Cons.Del.Sol: DIAZ GALINDO JOSE IGNACIO. Vicepresid.: CORES ARIAS EMILIANO. Representan: DIAZ GALINDOJOSE IGNACIO. Nombramientos. Representan: GOMEZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL. Consejero: GOMEZ FERNANDEZ JOSEMIGUEL;CORES RAMON MARIA ELENA. Vicepresid.: CORES RAMON MARIA ELENA. Secretario: GOMEZ FERNANDEZ JOSE
Nombramientos. Apoderado: IBAÑEZ LOPEZ MARIA JESUS. Datos registrales. T 35601 , F 5, S 8, H M 59707, I/A 31 (12.09.18).
24 de Mayo de 2018Ampliación de capital. Suscrito: 63.345,40 Euros. Desembolsado: 63.345,40 Euros. Resultante Suscrito: 1.132.043,70 Euros.Resultante Desembolsado: 1.132.043,70 Euros. Datos registrales. T 35601 , F 3, S 8, H M 59707, I/A 29 (16.05.18).
21 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: GOMEZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 35601 , F 1, S 8, H M 59707, I/A 28(10.05.18).
21 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Representan: PALACIO GARCIA ANTONIO. Nombramientos. Representan: DIAZ GALINDO JOSE IGNACIO.Reelecciones. Consejero: OTALMA SA;DIAZ GALINDO JOSE IGNACIO. Presidente: OTALMA SA. Secretario: DIAZ GALINDO JOSEIGNACIO. Cons.Del.Sol: OTALMA SA;DIAZ GALINDO JOSE IGNACIO. Vicepresid.: CORES ARIAS EMILIANO. Datos registrales. T3540 , F 21, S 8, H M 59707, I/A 27 (13.02.17).
17 de Marzo de 2015Revocaciones. Apoderado: SOTO BONELO MANUEL. Nombramientos. Apoderado: IBAÑEZ LOPEZ MARIA JESUS. Datosregistrales. T 3540 , F 21, S 8, H M 59707, I/A 26 (10.03.15).
25 de Noviembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ ITIEL JUAN. Vicepresid.: GOMEZ ITIEL JUAN. Nombramientos. Consejero: CORESARIAS EMILIANO. Vicepresid.: CORES ARIAS EMILIANO. Datos registrales. T 3540 , F 20, S 8, H M 59707, I/A 25 (18.11.14).
10 de Enero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: VERDES DE LA RIVA JAVIER. Con.Delegado: VERDES DE LA RIVA JAVIER. Consejero:CASANOVA ESCORIHUELA OCTAVIO. Secretario: CASANOVA ESCORIHUELA OCTAVIO. Presidente: VERDES DE LA RIVAJAVIER. Vicepresid.: OTALMA SA. Representan: FREI SANDRO. Nombramientos. Consejero: DIAZ GALINDO JOSEIGNACIO;GOMEZ ITIEL JUAN. Presidente: OTALMA SA. Vicepresid.: GOMEZ ITIEL JUAN. Secretario: DIAZ GALINDO JOSEIGNACIO. Cons.Del.Sol: OTALMA SA;DIAZ GALINDO JOSE IGNACIO. Representan: PALACIO GARCIA ANTONIO. Reelecciones.Consejero: OTALMA SA. Datos registrales. T 3540 , F 18, S 8, H M 59707, I/A 22 (29.12.11).
Nombramientos. Apoderado: SOTO BONELO MANUEL. Datos registrales. T 3540 , F 19, S 8, H M 59707, I/A 23 (29.12.11).
Cambio de domicilio social. C/ JUAN HURTADO DE MENDOZA 19 - 1º B (MADRID). Datos registrales. T 3540 , F 20, S 8, H M59707, I/A 24 (29.12.11).
01 de Julio de 2009Cambio de domicilio social. C/ CONDE DE ARANDA 20-2º (MADRID). Datos registrales. T 3540 , F 18, S 8, H M 59707, I/A 21(19.06.09).