Buscador CIF Logo

Actos BORME Promoziona Noroeste Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Promoziona Noroeste Sl

Actos BORME Promoziona Noroeste Sl - B84144146

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Promoziona Noroeste Sl con CIF B84144146

馃敊 Perfil de Promoziona Noroeste Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Promoziona Noroeste Sl

13 de Octubre de 2022
Cambio de domicilio social. C/ JOSE ANTONIO FERNANDEZ ORDO脩EZ 40 - OFICINA 10 (MADRID). Datos registrales. T 33987, F 52, S 8, H M 365011, I/A 22 ( 5.10.22).

17 de Junio de 2021
Nombramientos. Apoderado: GUILLAMON CRIADO PABLO. Datos registrales. T 33987 , F 51, S 8, H M 365011, I/A 21 (10.06.21).

11 de Junio de 2021
Revocaciones. Apoderado: GARCIA-VALCARCEL GONZALEZ MARTA;MATEOS LOPEZ SUSANA. Datos registrales. T 33987 , F51, S 8, H M 365011, I/A 20 ( 5.06.21).

15 de Enero de 2020
Nombramientos. Apoderado: ESTEBAN MARTIN JORGE. Datos registrales. T 33987 , F 51, S 8, H M 365011, I/A 19 ( 8.01.20).

27 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ ESTEFANIA ANA. Datos registrales. T 33987 , F 50, S 8, H M 365011, I/A 18 (20.11.17).

12 de Julio de 2016
Cambio de domicilio social. C/ QUINTANAVIDES 19 - EDIFICO 4, 3潞 E (MADRID). Datos registrales. T 33987 , F 50, S 8, H M365011, I/A 17 ( 5.07.16).

16 de Noviembre de 2015
Cambio de domicilio social. C/ QUINTANAVIDES 17 - EDIFICIO 3, 2& PLANTA, OFICI (MADRID). Datos registrales. T 20617 , F191, S 8, H M 365011, I/A 14 ( 5.11.15).

Revocaciones. Apoderado: SAEZ ACHAERANDIO NATALIA. Datos registrales. T 20617 , F 191, S 8, H M 365011, I/A 15 (5.11.15).

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ESTEFANIA ANA. Datos registrales. T 20617 , F 191, S 8, H M 365011, I/A 16 ( 5.11.15).

10 de Abril de 2015
Nombramientos. Apoderado: MATEOS LOPEZ SUSANA. Datos registrales. T 20617 , F 191, S 8, H M 365011, I/A 13 (30.03.15).

16 de Marzo de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA VALCARCEL GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Presidente: GARCIA VALCARCELGONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: GARCIA VALCARCEL GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Consejero: GARCIA-VALCARCEL GONZALEZ MARTA;CALVO ESTEBAN ENRIQUE. Cons.Del.Sol: GARCIA-VALCARCEL GONZALEZ MARTA;CALVOESTEBAN ENRIQUE. Secretario: GARCIA-VALCARCEL GONZALEZ MARTA. Nombramientos. Adm. Unico: GARCIA VALCARCELGONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 20617 , F 188, S 8, H M 365011, I/A 10 ( 9.03.15).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA-VALCARCEL GONZALEZ MARTA. Datos registrales. T 20617 , F 188, S 8, H M 365011, I/A11 ( 9.03.15).

Nombramientos. Apoderado: SAEZ ACHAERANDIO NATALIA. Datos registrales. T 20617 , F 190, S 8, H M 365011, I/A 12 (9.03.15).

04 de Abril de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 150.003,00 Euros. Resultante Suscrito: 155.043,00 Euros. Datos registrales. T 20617 , F 188, S 8,H M 365011, I/A 9 (26.03.14).

27 de Noviembre de 2013
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GESTILAR GESTION SL. Datos registrales. T 20617 , F 187, S 8, H M 365011, I/A8 (19.11.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n