Actos BORME de Prompapel Sl
22 de Octubre de 2020Cambio de domicilio social. AV DE CERDANYOLA NUM.79-81 P.4 OFICINA 9 (SANT CUGAT DEL VALLES). Datos registrales. T36631 , F 158, S 8, H B 280682, I/A 11 ( 9.10.20).
22 de Noviembre de 2018Modificaciones estatutarias. ADICION DEL ARTICULO 20 BIS A LOS ESTATUTOS SOCIALES. REMUNERACION DE LOSADMINISTRADORES. Datos registrales. T 36631 , F 158, S 8, H B 280682, I/A 10 (13.11.18).
18 de Septiembre de 2014Revocaciones. APODERADO: VIVES ALIJA BASILIO. Datos registrales. T 36631 , F 158, S 8, H B 280682, I/A 9 ( 8.09.14).
06 de Septiembre de 2011Nombramientos. APODERADO: VIVES ALIJA BASILIO. Datos registrales. T 36631 , F 158, S 8, H B 280682, I/A 8 (25.08.11).
01 de Septiembre de 2011Revocaciones. ADM.UNICO: LLOR PLANAS MARIA PILAR. Nombramientos. ADM.UNICO: ROVIRA LLOR ALBERT MAGNE.Modificaciones estatutarias. ART.13:USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES SOCIALES. Datos registrales. T 36631 , F 157, S 8, HB 280682, I/A 7 (23.08.11).
10 de Agosto de 2011Revocaciones. APODERADO: VIVES ALIJA BASILIO. Datos registrales. T 36631 , F 157, S 8, H B 280682, I/A 6 ( 1.08.11).