Actos BORME de Prorevosa Sl
27 de Abril de 2022Nombramientos. Apoderado: RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 36020 , F 187, S 8, H M 91671, I/A 39 (20.04.22).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GIMENO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 36020 , F 190, S 8, H M 91671, I/A40 (20.04.22).
03 de Enero de 2022Ampliacion del objeto social. , GESTIONAR, ARRENDAR, PIGNORAR, HIPOTECAR, BIENES MUEBLES O INMUEBLES, accionesy valores y dem谩s titulos de frafico mercantil, asi como la promocion y comercializacion de sus correspondientes productos. Fusi贸npor absorci贸n. Sociedades absorbidas: TIRTE SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 36020 , F 184, S 8, H M 91671, I/A 38(27.12.21).
16 de Abril de 2021Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ RANERO JUAN CARLOS;SANCHEZ RANERO JUAN CARLOS. Apo.Man.Soli: SANCHEZRANERO JUAN-CARLOS. Otros conceptos: Revocaci贸n de poder a don Juan Carlos S谩nchez Ranero, que caus贸 la inscripci贸n 32陋.Datos registrales. T 36020 , F 184, S 8, H M 91671, I/A 37 ( 9.04.21).
15 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: MORALES MORALES ALFONSO;DE BORBON DOS SICILIAS Y DE ORLEANS PEDRO JUAN;DEBORBON DOS SICILIAS Y DE ORLEANS PEDRO JUAN;MORALES MORALES ALFONSO. Apoderado: DE BORBON DOS SICILIASY DE ORLEANS PEDRO JUAN. Datos registrales. T 36020 , F 183, S 8, H M 91671, I/A 35 ( 4.12.20).
Cambio de domicilio social. C/ SANTA SABINA NUMERO 8 - 2陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 36020 , F 183, S 8, H M91671, I/A 36 ( 4.12.20).
14 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: REVOREDO DELVECCHIO HELENA IRENE. Nombramientos. Adm. Unico: GUBEL SL.Representan: GUT REVOREDO BARBARA. Datos registrales. T 36020 , F 183, S 8, H M 91671, I/A 34 ( 3.01.20).
03 de Agosto de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUERRA GARCIA FRANCISCO JAVIER;FERNANDEZ ALONSO LORENZO. Datos registrales. T5602 , F 201, S 8, H M 91671, I/A 33 (27.07.17).
31 de Octubre de 2014Otros conceptos: Subsanaci贸n de la inscripci贸n 31& de esta hoja. Datos registrales. T 5602 , F 198, S 8, H M 91671, I/A 32(24.10.14).
23 de Julio de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: GIMENO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER;SANCHEZ RANERO JUAN-CARLOS. Datosregistrales. T 5602 , F 195, S 8, H M 91671, I/A 31 (15.07.14).
19 de Diciembre de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: DE BORBON DOS SICILIAS Y DE ORLEANS PEDRO JUAN;MORALES MORALES ALFONSO. Datosregistrales. T 5602 , F 195, S 8, H M 91671, I/A 29 (11.12.12).
Nombramientos. Apoderado: DE BORBON DOS SICILIAS Y DE ORLEANS PEDRO JUAN. Datos registrales. T 5602 , F 195, S 8,H M 91671, I/A 30 (11.12.12).
15 de Diciembre de 2011Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GUBEL SL. Datos registrales. T 5602 , F 194, S 8, H M 91671, I/A 28 ( 1.12.11).
07 de Diciembre de 2011Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA, 140 11 B (MADRID). Datos registrales. T 5602 , F 194, S 8, H M91671, I/A 27 (24.11.11).
05 de Noviembre de 2010Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA NUMERO 140, 10潞 B (MADRID). Datos registrales. T 5602 , F 194, S 8,H M 91671, I/A 26 (25.10.10).
23 de Marzo de 2010Revocaciones. Apoderado: LOPEZ IBOR ALCOCER JAIME. Nombramientos. Apoderado: EGIDO VOLLANDT INES. Datosregistrales. T 5602 , F 190, S 8, H M 91671, I/A 25 (11.03.10).