Actos BORME de Prosegur Gestion De Activos International Sl
20 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREA ARRANZ PEDRO PABLO. Datos registrales. T 41465 , F 206, S 8, H M 593893, I/A 60(13.12.23).
01 de Diciembre de 2023Ceses/Dimisiones. Representan: CABRERIZO BARRERA FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Representan: RODRIGUEZSEDANO MAITE. Datos registrales. T 41465 , F 205, S 8, H M 593893, I/A 59 (25.11.23).
28 de Julio de 2023Revocaciones. Apoderado: RUBIO MERINO ANTONIO. Apo.Manc.: RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 41465 , F205, S 8, H M 593893, I/A 58 (21.07.23).
12 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: GARCIA GARCIA JOSE ANGEL. Datos registrales. T 41465 , F 205, S 8, H M 593893, I/A 57 ( 5.05.23).
11 de Abril de 2023Nombramientos. Apoderado: GARCIA MATEOS ANGEL. Datos registrales. T 41465 , F 204, S 8, H M 593893, I/A 55 (30.03.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANZ LOSADA JOSE MARIA. Datos registrales. T 41465 , F 204, S 8, H M 593893, I/A 56(30.03.23).
28 de Febrero de 2023Revocaciones. Apoderado: SUAREZ-CANTON PE脩A NICOLAS;RUIZ MORENO JAVIER;GIMENO MARTINEZ FRANCISCOJAVIER;RODRIGUEZ COCA GERARDO;LEAL DE CARLOS MARIA JOSE. Datos registrales. T 41465 , F 203, S 8, H M 593893, I/A54 (21.02.23).
17 de Enero de 2023Nombramientos. Apoderado: MARTIN DONAIRE FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 41465 , F 202, S 8, H M 593893, I/A53 (10.01.23).
27 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: COUTO FARIA GONCALVES PAULO ALEXANDRE. Datos registrales. T 41465 , F 202, S 8, H M593893, I/A 52 (19.12.22).
13 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: COUTO FARIA GONCALVES PAULO ALEXANDRE. Datos registrales. T 41465 , F 201, S 8, H M593893, I/A 51 ( 2.12.22).
27 de Octubre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR. Apoderado: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR. Datosregistrales. T 41465 , F 201, S 8, H M 593893, I/A 50 (20.10.22).
30 de Mayo de 2022Revocaciones. Apoderado: ULLOA DELGADO GUILLERMO. Datos registrales. T 41465 , F 200, S 8, H M 593893, I/A 49(23.05.22).
26 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: SOBRINO POUSA DIEGO. Datos registrales. T 41465 , F 200, S 8, H M 593893, I/A 48 (19.05.22).
13 de Mayo de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANTOS IGLESIAS ALBERTO. Datos registrales. T 41465 , F 199, S 8, H M 593893, I/A 47 (6.05.22).
24 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: GARCIA SALIDO JOSE RICARDO. Datos registrales. T 41465 , F 199, S 8, H M 593893, I/A 46(17.02.22).
25 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PROSEGUR SOLUCIONES SA. Representan: CABRERIZO BARRERA FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. Adm. Unico: PROSEGUR GESTION DE ACTIVOS SL. Representan: CABRERIZO BARRERA FRANCISCOJAVIER. Datos registrales. T 41465 , F 198, S 8, H M 593893, I/A 45 (18.10.21).
22 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABRERIZO BARRERA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 41465 , F 196, S 8, H M593893, I/A 44 (15.10.21).
14 de Octubre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: RENTEA RENTEA DIANA. Datos registrales. T 41465 , F 196, S 8, H M 593893, I/A 43 ( 6.10.21).
29 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 41465 , F 194, S 8, H M 593893, I/A 42(22.09.21).
24 de Agosto de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: GESTAL LOPEZ DAVID JOSE. Datos registrales. T 41465 , F 193, S 8, H M 593893, I/A 41(17.08.21).
04 de Agosto de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 41465 , F 191, S 8, H M 593893, I/A 40(28.07.21).
14 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ DE COS ANDRES;ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA;LOZANO SANCHEZALBERTO;DIAZ HERVAS PEDRO. Datos registrales. T 32993 , F 225, S 8, H M 593893, I/A 39 ( 7.05.21).
12 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Otros conceptos: HA CAUSADO BAJA EL PODER CONFERIDOA DO脩A MARTA ERMITAS MALLO FERNANDEZ EL 20 DE ENERO DE 2021, POR HABER SIDO OTORGADO POR ERROR. Datosregistrales. T 32993 , F 225, S 8, H M 593893, I/A 38 ( 5.05.21).
30 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Datos registrales. T 32993 , F 225, S 8, H M 593893, I/A 37(23.03.21).
19 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ DE COS ANDRES;ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA. Datos registrales. T 32993 ,F 224, S 8, H M 593893, I/A 36 (12.02.21).
17 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Datos registrales. T 32993 , F 223, S 8, H M 593893, I/A 35(10.02.21).
18 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA PRIETO ALVARO. Apo.Manc.: RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 32993 , F222, S 8, H M 593893, I/A 34 (11.12.20).
09 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR;ULLOA DELGADO GUILLERMO. Datos registrales. T 32993 ,F 221, S 8, H M 593893, I/A 33 (30.11.20).
03 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR;RENTEA RENTEA DIANA. Datos registrales. T 32993 , F 220, S8, H M 593893, I/A 32 (26.11.20).
14 de Agosto de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: BERRAL REINA FRANCISCO JOSE. Apo.Sol.: BERRAL REINA FRANCISCO JOSE. Datos
30 de Julio de 2020Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ-PORTAL GEMA;PE脩A MELLADO ROBERTO. Apo.Man.Soli: MU脩OZ VALDESRAFAEL. Datos registrales. T 32993 , F 219, S 8, H M 593893, I/A 30 (23.07.20).
24 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 32993 , F 218, S 8, H M 593893, I/A 29(17.07.20).
24 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: MONZON HIDALGO ENRIQUE CARLOS. Datos registrales. T 32993 , F 217, S 8, H M 593893, I/A 28(17.12.19).
04 de Julio de 2019Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ BARBE SAGRARIO;FERNANDEZ BARBE SAGRARIO. Datos registrales. T 32993 , F217, S 8, H M 593893, I/A 27 (27.06.19).
13 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: SAAVEDRA LLANO JULIO. Datos registrales. T 32993 , F 217, S 8, H M 593893, I/A 26 ( 6.06.19).
10 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: SOLER RUIZ BOADA MIGUEL. Nombramientos. Representan: CABRERIZO BARRERA
25 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREA ARRANZ PEDRO PABLO. Datos registrales. T 32993 , F 214, S 8, H M 593893, I/A 24(16.04.19).
07 de Agosto de 2018Revocaciones. Apoderado: BANDRES GUTIERREZ MIGUEL. Datos registrales. T 32993 , F 214, S 8, H M 593893, I/A 23(31.07.18).
10 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONZON HIDALGO ENRIQUE CARLOS. Datos registrales. T 32993 , F 213, S 8, H M 593893, I/A22 ( 3.05.18).
10 de Enero de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 750.003,00 Euros. Datos registrales. T 32993 , F 212, S 8, H M593893, I/A 21 ( 3.01.18).
24 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: SCHOOFS CHRISTOPH. Datos registrales. T 32993 , F 211, S 8, H M 593893, I/A 20 (11.10.17).
11 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: MONZON HIDALGO ENRIQUE-CARLOS. Datos registrales. T 32993 , F 211, S 8, H M 593893, I/A19 ( 1.09.17).
26 de Julio de 2017Revocaciones. Apoderado: GARCIA MATEOS ANGEL;MONTERO LOPEZ JUAN;NOGAL VELEZ ANTONIO;SOLER RUIZ BOADAMIGUEL;RUBIO MERINO ANTONIO;ILLANA GARCIA JOSE LUIS;SAENZ ANDRES LUIS HORACIO;PEREZ MOSSO JOSE-MARIA;VELAZQUEZ BARROSO JUAN;ESPA脩A CONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T 32993 , F 210, S 8, H M 593893, I/A18 (17.07.17).
12 de Junio de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 750.002,00 Euros. Datos registrales. T 32993 , F 210, S 8, H M593893, I/A 17 ( 2.06.17).
21 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA PRIETO ALVARO. Datos registrales. T 32993 , F 208, S 8, H M 593893, I/A 16 (10.03.17).
02 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apoderado: SOLER RUIZ-BOADA MIGUEL;FERNANDEZ BARBE SAGRARIO;BANDRES GUTIERREZMIGUEL;RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 32993 , F 206, S 8, H M 593893, I/A 15 (21.10.16).
03 de Agosto de 2016Otros conceptos: SUBSANACION DE LA ESCRITURA AUTORIZADA POR LA NOTARIO DE MADRID, D陋 ELOISA LOPEZ-MONISGALLEGO, EL DIA 04.04.2016, CON EL NUM. 526 DE SU PROTOCOLO, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 12陋, EN CUANTO AL
31 de Mayo de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 750.001,00 Euros. Datos registrales. T 32993 , F 205, S 8, H M593893, I/A 13 (23.05.16).
26 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 32993 , F 203, S 8, H M 593893, I/A 11(15.04.16).
Nombramientos. Apoderado: ESPA脩A CONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T 32993 , F 204, S 8, H M 593893, I/A 12(18.04.16).
21 de Abril de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.265,13 Euros. Resultante Suscrito: 750.000,00 Euros. Datos registrales. T 32993 , F203, S 8, H M 593893, I/A 10 (14.04.16).
04 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA JOSE ANGEL;DOMINGUEZ PEREZ DIEGO MARIA. Datos registrales. T 32993 , F203, S 8, H M 593893, I/A 9 (26.02.16).
28 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: MU脩OZ VALDES RAFAEL. Datos registrales. T 32993 , F 201, S 8, H M 593893, I/A 8 (18.12.15).
14 de Diciembre de 2015Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: PROSEGUR GESTION DE ACTIVOS SL. Datos registrales. T32993 , F 201, S 8, H M 593893, I/A 7 ( 4.12.15).