Actos BORME de Prosegur Gestion De Activos Sl
20 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apoderado: PEREA ARRANZ PEDRO PABLO. Datos registrales. T 43115 , F 57, S 8, H M 505088, I/A 132(13.12.23).
07 de Diciembre de 2023Ceses/Dimisiones. Representan: CABRERIZO BARRERA FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Representan: RODRIGUEZSEDANO MAITE. Datos registrales. T 43115 , F 56, S 8, H M 505088, I/A 131 (29.11.23).
27 de Octubre de 2023Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 43115 , F 56, S 8, H M 505088, I/A 130 (22.10.23).
23 de Octubre de 2023Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: PROSEGUR USAP INTERNATIONAL SL. Datos registrales. T 43115 , F 54, S 8, HM 505088, I/A 129 (16.10.23).
08 de Junio de 2023Nombramientos. Apoderado: MANSOA ARIAS JOSE. Datos registrales. T 43115 , F 53, S 8, H M 505088, I/A 126 ( 1.06.23).
17 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: GARCIA GARCIA JOSE ANGEL. Datos registrales. T 43115 , F 52, S 8, H M 505088, I/A 125 ( 9.05.23).
11 de Abril de 2023Nombramientos. Apoderado: GARCIA MATEOS ANGEL. Datos registrales. T 43115 , F 51, S 8, H M 505088, I/A 123 (30.03.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANZ LOSADA JOSE MARIA. Datos registrales. T 43115 , F 52, S 8, H M 505088, I/A 124(30.03.23).
22 de Febrero de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: REINA CANO EMILIO;REINA CANO EMILIO. Datos registrales. T 43115 , F 51, S 8, H M 505088, I/A122 (15.02.23).
21 de Febrero de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ JIMENEZ FRUCTUOSO. Datos registrales. T 43115 , F 51, S 8, H M 505088, I/A 121(14.02.23).
17 de Enero de 2023Nombramientos. Apoderado: MARTIN DONAIRE FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 43115 , F 50, S 8, H M 505088, I/A120 (10.01.23).
03 de Enero de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA ESPINEL JOSE DANIEL. Datos registrales. T 43115 , F 49, S 8, H M 505088, I/A 118(27.12.22).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MATEOS ANGEL. Datos registrales. T 43115 , F 49, S 8, H M 505088, I/A 119 (27.12.22).
27 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: COUTO FARIA GONCALVES PAULO ALEXANDRE. Datos registrales. T 43115 , F 49, S 8, H M505088, I/A 117 (19.12.22).
13 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ JAIME BORJA. Datos registrales. T 43115 , F 47, S 8, H M 505088, I/A 114 ( 2.12.22).
Nombramientos. Apoderado: TEJEDOR TRANCA MARIA DOLORES. Datos registrales. T 43115 , F 47, S 8, H M 505088, I/A 115 (2.12.22).
Nombramientos. Apoderado: COUTO FARIA GONCALVES PAULO ALEXANDRE. Datos registrales. T 43115 , F 48, S 8, H M505088, I/A 116 ( 2.12.22).
21 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: GUISADO FERRANDIZ ISABEL;MARTINEZ AGGIO VIVIAN. Datos registrales. T 43115 , F 46, S 8, H M505088, I/A 113 (14.11.22).
27 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: PEDRAZA LAYNEZ MAR. Apo.Sol.: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR. Apoderado: PEDRAZALAYNEZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 43115 , F 46, S 8, H M 505088, I/A 112 (20.10.22).
30 de Mayo de 2022Revocaciones. Apoderado: ULLOA DELGADO GUILLERMO. Datos registrales. T 43115 , F 46, S 8, H M 505088, I/A 111(23.05.22).
26 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: SOBRINO POUSA DIEGO. Datos registrales. T 43115 , F 45, S 8, H M 505088, I/A 110 (19.05.22).
13 de Mayo de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANTOS IGLESIAS ALBERTO. Datos registrales. T 43115 , F 44, S 8, H M 505088, I/A 109 (6.05.22).
04 de Mayo de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: TRASCASA ESPINOSA PAULA. Datos registrales. T 43115 , F 44, S 8, H M 505088, I/A 108 (26.04.22).
03 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: BLAZQUEZ HERNANDEZ OSCAR SALVADOR. Datos registrales. T 43115 , F 43, S 8, H M 505088,I/A 107 (25.04.22).
29 de Abril de 2022Otros conceptos: INSCRIPCION DE LA TOTALIDAD DE LA FACULTAD 53 DE SUSTITUCION DE PODER CONFERIDA A FAVORDE D.JAIME RON ALPA脩ES. Datos registrales. T 43115 , F 43, S 8, H M 505088, I/A 106 (22.04.22).
11 de Marzo de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: RON ALPA脩ES JAIME. Datos registrales. T 43115 , F 40, S 8, H M 505088, I/A 104 ( 4.03.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA ESPINEL JOSE DANIEL. Datos registrales. T 43115 , F 42, S 8, H M 505088, I/A 105 (4.03.22).
08 de Marzo de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: ABOS PUEYO FERNANDO SIRO. Datos registrales. T 43115 , F 40, S 8, H M 505088, I/A 103 (1.03.22).
24 de Febrero de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: SAAVEDRA LLANO JULIO. Apoderado: SAAVEDRA LLANO JULIO. Datos registrales. T 38890 , F 225, S8, H M 505088, I/A 102 (17.02.22).
15 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Representan: RUBIO MERINO ANTONIO. Nombramientos. Representan: CABRERIZO BARRERAFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 38890 , F 225, S 8, H M 505088, I/A 101 ( 8.02.22).
22 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABRERIZO BARRERA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 38890 , F 222, S 8, H M505088, I/A 99 (15.10.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ-TAGLE MAINE JOSE JORGE. Datos registrales. T 38890 , F 225, S 8, H M 505088, I/A 100(15.10.21).
14 de Octubre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: RENTEA RENTEA DIANA. Datos registrales. T 38890 , F 222, S 8, H M 505088, I/A 98 ( 6.10.21).
28 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: VELAZQUEZ BARROSO JUAN. Datos registrales. T 38890 , F 222, S 8, H M 505088, I/A 97(21.09.21).
04 de Agosto de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 38890 , F 220, S 8, H M 505088, I/A 96(28.07.21).
20 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Apo.Manc.: GARCIA PRIETO ALVARO;RUBIO MERINO ANTONIO.Datos registrales. T 38890 , F 218, S 8, H M 505088, I/A 95 (13.07.21).
12 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Otros conceptos: HA CAUSADO BAJA EL PODER CONFERIDOA DO脩A MARTA ERMITAS MALLO FERNANDEZ EL 20 DE ENERO DE 2021, POR HABER SIDO OTORGADO POR ERROR. Datosregistrales. T 38890 , F 218, S 8, H M 505088, I/A 94 ( 5.05.21).
04 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: GESTAL LOPEZ DAVID JOSE. Datos registrales. T 38890 , F 217, S 8, H M 505088, I/A 93(26.04.21).
31 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: RUBIO MERINO ANTONIO. Presidente: RUBIO MERINO ANTONIO. Consejero: VELAZQUEZBARROSO JUAN;CABRERIZO BARRERA FRANCISCO JAVIER. SecreNoConsj: PEREA ARRANZ PEDRO PABLO.Nombramientos. Adm. Unico: PROSEGUR COMPA脩IA DE SEGURIDAD SA. Representan: RUBIO MERINO ANTONIO. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 38890 , F217, S 8, H M 505088, I/A 92 (24.03.21).
30 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Datos registrales. T 38890 , F 216, S 8, H M 505088, I/A 91(23.03.21).
03 de Marzo de 2021Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 38890 , F 216, S 8, H M 505088, I/A 90 (24.02.21).
19 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ DE COS ANDRES;ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA. Datos registrales. T 38890 ,F 215, S 8, H M 505088, I/A 89 (12.02.21).
17 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Datos registrales. T 38890 , F 214, S 8, H M 505088, I/A 88(10.02.21).
21 de Diciembre de 2020Cambio de objeto social. 1. La realizaci贸n de todo tipo de actividades de car谩cter inmobiliario, en especial, las relativas a laadquisici贸n; tenencia, arrendamiento, enajenaci贸n, promoci贸n, rehabilitaci贸n y explotaci贸n por cualquier t铆tulo de toda clase de bienesinmuebles. 2. La prestaci贸n de servicios de.... Datos registrales. T 38890 , F 213, S 8, H M 505088, I/A 87 (14.12.20).
10 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: GARCIA PRIETO ALVARO;RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 38890 , F 212, S 8, H M505088, I/A 85 ( 1.12.20).
Revocaciones. Apoderado: SILVA NAVARRETE FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 38890 , F 213, S 8, H M 505088, I/A 86( 1.12.20).
09 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR;ULLOA DELGADO GUILLERMO. Datos registrales. T 38890 ,F 211, S 8, H M 505088, I/A 84 (30.11.20).
03 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR;RENTEA RENTEA DIANA. Datos registrales. T 38890 , F 211, S8, H M 505088, I/A 83 (26.11.20).
23 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ VALLEJO MARCO ANTONIO. Datos registrales. T 38890 , F 210, S 8, H M 505088, I/A 82(16.11.20).
14 de Agosto de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: BERRAL REINA FRANCISCO JOSE. Apo.Sol.: BERRAL REINA FRANCISCO JOSE. Datosregistrales. T 38890 , F 210, S 8, H M 505088, I/A 81 ( 7.08.20).
11 de Agosto de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ SANCHEZ PORTAL MARIA GEMA;PE脩A MELLADO ROBERTO;MU脩OZ VALDESRAFAEL. Apoderado: GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO. Apo.Man.Soli: GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO;GRANDE PARDOENRIQUE PEDRO. Datos registrales. T 38890 , F 209, S 8, H M 505088, I/A 80 ( 4.08.20).
10 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA;LOZANO SANCHEZ ALBERTO;SANCHEZ DE COSANDRES;DIAZ HERVAS PEDRO;ZAHARIEVA ZORINA;RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 38890 , F 208, S 8, H M505088, I/A 79 ( 3.08.20).
20 de Febrero de 2020Fe de erratas: Se public贸 por error en la Inscripci贸n 35陋 el nombramiento como APODERADO de MELENDEZ VALDES MU脩OZRAFAEL, siendo lo correcto MU脩OZ VALDES RAFAEL. Datos registrales. T 27989 , F 133, S 8, H M 505088, I/A 35 (18.12.15).
11 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: GRANDE DE RODA PABLO;FERNANDEZ-TAGLE MAINE JOSE JORGE. Datos registrales. T 38890 , F208, S 8, H M 505088, I/A 78 (29.11.19).
18 de Septiembre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: SANTOS IGLESIAS ALBERTO. Datos registrales. T 38890 , F 207, S 8, H M 505088, I/A 76 (11.09.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ FERNANDEZ ROSA ANA. Datos registrales. T 38890 , F 207, S 8, H M 505088, I/A 77(11.09.19).
17 de Septiembre de 2019Nombramientos. Apoderado: PEREA ARRANZ PEDRO PABLO. Datos registrales. T 38890 , F 204, S 8, H M 505088, I/A 74(10.09.19).
Nombramientos. Apoderado: GIL MATAIX RAMON. Datos registrales. T 38890 , F 207, S 8, H M 505088, I/A 75 (10.09.19).
02 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Secretario: SOLER RUIZ-BOADA MIGUEL. Nombramientos. SecreNoConsj: PEREA ARRANZ PEDROPABLO. Datos registrales. T 38890 , F 204, S 8, H M 505088, I/A 73 (26.07.19).
24 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: SOLER RUIZ-BOADA MIGUEL. Nombramientos. Consejero: CABRERIZO BARRERA FRANCISCOJAVIER. Datos registrales. T 38890 , F 203, S 8, H M 505088, I/A 72 (17.05.19).
23 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABRERIZO BARRERA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 34269 , F 160, S 8, H M505088, I/A 71 (16.05.19).
13 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: PEDRAZA LAYNEZ MAR. Datos registrales. T 34269 , F 160, S 8, H M 505088, I/A 70 ( 6.03.19).
05 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANTOS IGLESIAS ALBERTO. Datos registrales. T 34269 , F 159, S 8, H M 505088, I/A 69(26.02.19).
29 de Enero de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: JIMENEZ DE PABLO MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 34269 , F 158, S 8, H M 505088, I/A68 (22.01.19).
28 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: REINA CANO EMILIO;GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO;GONZALEZ JIMENEZ FRUCTUOSO.
16 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: BASTIDA MARTIN DANIEL. Datos registrales. T 34269 , F 156, S 8, H M 505088, I/A 66 ( 8.11.18).
05 de Septiembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: BLAZQUEZ HERNANDEZ OSCAR SALVADOR. Datos registrales. T 34269 , F 155, S 8, H M 505088,I/A 64 (29.08.18).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ BARBE SAGRARIO;FERNANDEZ BARBE SAGRARIO. Datos registrales. T 34269 , F156, S 8, H M 505088, I/A 65 (29.08.18).
07 de Agosto de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: BANDRES GUTIERREZ MIGUEL ANGEL;BANDRES GUTIERREZ MIGUEL ANGEL. Datosregistrales. T 34269 , F 155, S 8, H M 505088, I/A 63 (31.07.18).
24 de Julio de 2018Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 34269 , F 155, S 8, H M 505088, I/A 62 (17.07.18).
10 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONZON HIDALGO ENRIQUE CARLOS. Datos registrales. T 34269 , F 154, S 8, H M 505088, I/A61 ( 3.05.18).
23 de Febrero de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: ARRANZ MARTINEZ EDUARDO. Datos registrales. T 34269 , F 154, S 8, H M 505088, I/A 60(16.02.18).
28 de Diciembre de 2017Nombramientos. Apoderado: ABOS PUEYO FERNANDO SIRO. Datos registrales. T 34269 , F 150, S 8, H M 505088, I/A 58(19.12.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO. Datos registrales. T 34269 , F 153, S 8, H M 505088, I/A 59(19.12.17).
22 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: SILVA NAVARRETE FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 34269 , F 149, S 8, H M 505088, I/A57 (14.11.17).
20 de Noviembre de 2017Otros conceptos: Mediante diligencia presentada, se modifica el segundo apellido del apoderado, siendo su nombre correctocompleto, DON JULIO SAAVEDRA LLANO. Datos registrales. T 34269 , F 148, S 8, H M 505088, I/A 56 ( 8.11.17).
24 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: BARRANCO AMARO PEDRO LUIS;POZO BARGUE脩O ESTEBAN;GIL MATAIX RAMON. Datosregistrales. T 34269 , F 148, S 8, H M 505088, I/A 55 (11.10.17).
17 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: SCHOOFS CHRISTOPH;RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 34269 , F 146, S 8, H M505088, I/A 54 ( 6.10.17).
11 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: MONZON HIDALGO ENRIQUE-CARLOS. Datos registrales. T 34269 , F 146, S 8, H M 505088, I/A53 ( 1.09.17).
24 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: SAAVEDRA LLANA JULIO. Datos registrales. T 34269 , F 145, S 8, H M 505088, I/A 52 ( 9.08.17).
26 de Julio de 2017Revocaciones. Apoderado: SOLER RUIZ-BOADA MIGUEL. Apo.Man.Soli: ESPA脩A CONTRERAS ANTONIO. Apoderado: ESPA脩ACONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T 34269 , F 145, S 8, H M 505088, I/A 51 (17.07.17).
29 de Mayo de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 29.952.588,00 Euros. Datos registrales. T 34269 , F 145, S 8, H M505088, I/A 50 (19.05.17).
22 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: SAAVEDRA LLANA JULIO. Datos registrales. T 34269 , F 144, S 8, H M 505088, I/A 49 (13.03.17).
21 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA PRIETO ALVARO. Datos registrales. T 34269 , F 143, S 8, H M 505088, I/A 48 (10.03.17).
25 de Noviembre de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 2,00 Euros. Resultante Suscrito: 29.952.587,00 Euros. Datos registrales. T 34269 , F 142, S 8, H M505088, I/A 47 (17.11.16).
03 de Agosto de 2016Otros conceptos: SUBSANACION DE LA ESCRITURA AUTORIZADA POR LA NOTARIO DE MADRID, D陋 ELOISA LOPEZ-MONISGALLEGO, EL DIA 04.04.2016, CON EL NUM. 526 DE SU PROTOCOLO, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 41陋, EN CUANTO ALLIMITE DE LA ACTUACION MANCOMUNADA DEL APODERADO D. ANTONIO ESPA脩A CONTRERAS. Datos registrales. T 34269, F 141, S 8, H M 505088, I/A 46 (22.07.16).
26 de Julio de 2016Nombramientos. Apoderado: GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO. Datos registrales. T 27989 , F 225, S 8, H M 505088, I/A 45(15.07.16).
21 de Junio de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARRANZ MARTINEZ EDUARDO. Datos registrales. T 27989 , F 224, S 8, H M 505088, I/A 44(13.06.16).
15 de Junio de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: RAMOS GONZALEZ MARIA EMMA. Datos registrales. T 27989 , F 224, S 8, H M 505088, I/A 43 (7.06.16).
30 de Mayo de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: SOLER RUIZ-BOADA MIGUEL;FERNANDEZ BARBE SAGRARIO;BANDRES GUTIERREZ MIGUELANGEL. Datos registrales. T 27989 , F 221, S 8, H M 505088, I/A 42 (20.05.16).
26 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 27989 , F 220, S 8, H M 505088, I/A 40(15.04.16).
Nombramientos. Apoderado: ESPA脩A CONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T 27989 , F 220, S 8, H M 505088, I/A 41(18.04.16).
31 de Marzo de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 29.952.585,00 Euros. Datos registrales. T 27989 , F 219, S 8, H M505088, I/A 39 (21.03.16).
09 de Marzo de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 29.952.584,00 Euros. Datos registrales. T 27989 , F 136, S 8, H M505088, I/A 38 (26.02.16).
04 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA JOSE ANGEL;DOMINGUEZ PEREZ DIEGO MARIA. Datos registrales. T 27989 , F136, S 8, H M 505088, I/A 37 (26.02.16).
29 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 27989 , F 134, S 8, H M 505088, I/A 36 (18.12.15).
28 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: MELENDEZ VALDES MU脩OZ RAFAEL. Datos registrales. T 27989 , F 133, S 8, H M 505088, I/A35 (18.12.15).
16 de Diciembre de 2015Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 2 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Cambiode objeto social. LA REALIZACION DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES DE CARACTER INMOBILIARIO, EN ESPECIAL, LASRELATIVAS A LA ADQUISICION, TENENCIA, ARRENDAMIENTO, ENAJENACION, PROMOCION, REHABILITACION YEXPLOTACION POR CUALQUIER TITULO DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES... Datos registrales. T 27989 , F 132, S 8, HM 505088, I/A 34 ( 4.12.15).
27 de Noviembre de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 29.952.583,00 Euros. Datos registrales. T 27989 , F 131, S 8, H M505088, I/A 33 (19.11.15).
02 de Julio de 2015Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27989 , F 131, S 8, H M 505088, I/A 32 (25.06.15).
15 de Abril de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: REINA CANO EMILIO. Datos registrales. T 27989 , F 128, S 8, H M 505088, I/A 30 ( 7.04.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RAMOS GONZALEZ MARIA EMMA. Datos registrales. T 27989 , F 129, S 8, H M 505088, I/A 31 (7.04.15).
04 de Marzo de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ MOSSO JOSE-MARIA. Datos registrales. T 27989 , F 128, S 8, H M 505088, I/A 29(24.02.15).
03 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN CARRERA JUAN LUIS. Datos registrales. T 27989 , F 127, S 8, H M 505088, I/A 28(24.02.15).
03 de Febrero de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: SUAREZ CANTON NICOLAS. Apo.Sol.: SUAREZ CANTON NICOLAS. Datos registrales. T 27989 , F126, S 8, H M 505088, I/A 26 (26.01.15).
Revocaciones. Apo.Sol.: LEAL DE CARLOS MARIA JOSE. Apo.Man.Soli: LEAL DE CARLOS MARIA JOSE. Datos registrales. T27989 , F 127, S 8, H M 505088, I/A 27 (27.01.15).
28 de Enero de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ COCA GERARDO. Datos registrales. T 27989 , F 126, S 8, H M 505088, I/A 25(20.01.15).
26 de Enero de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: JUSTE VELASCO FELIPE RAMON. Datos registrales. T 27989 , F 126, S 8, H M 505088, I/A 24(19.01.15).
27 de Agosto de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: GIMENO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 27989 , F 126, S 8, H M 505088, I/A23 (19.08.14).
13 de Agosto de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESPA脩A CONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T 27989 , F 125, S 8, H M 505088, I/A 22 (5.08.14).
14 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: SUAREZ-CANTON PE脩A NICOLAS. Nombramientos. Consejero: VELAZQUEZ BARROSO JUAN.Datos registrales. T 27989 , F 125, S 8, H M 505088, I/A 21 ( 7.08.13).
18 de Junio de 2013Revocaciones. Apoderado: SAGUAR DUE脩AS ESTRELLA ISABEL. Datos registrales. T 27989 , F 125, S 8, H M 505088, I/A 20(10.06.13).
17 de Junio de 2013Nombramientos. Apoderado: RUBIO MERINO ANTONIO;MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 27989 , F 123,S 8, H M 505088, I/A 19 ( 7.06.13).
14 de Junio de 2013Nombramientos. Apoderado: GARCIA SALIDO JOSE RICARDO. Datos registrales. T 27989 , F 123, S 8, H M 505088, I/A 17 (6.06.13).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA SALIDO JOSE RICARDO. Datos registrales. T 27989 , F 123, S 8, H M 505088, I/A 18 (6.06.13).
06 de Febrero de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: COROMINAS MENENDEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 27989 , F 123, S 8, H M 505088, I/A16 (21.01.13).
22 de Noviembre de 2012Nombramientos. Apoderado: GARCIA MATEOS ANGEL. Datos registrales. T 27989 , F 122, S 8, H M 505088, I/A 15 (12.11.12).
05 de Octubre de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: LEAL DE CARLOS MARIA JOSE. Datos registrales. T 27989 , F 121, S 8, H M 505088, I/A 14(25.09.12).
02 de Octubre de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 29.902.582,00 Euros. Resultante Suscrito: 29.952.582,00 Euros. Segregaci贸n. Beneficiarios de lasegregaci贸n: PROSEGUR GESTION DE ACTIVOS SL. Datos registrales. T 27989 , F 119, S 8, H M 505088, I/A 13 (19.09.12).
16 de Julio de 2012Nombramientos. Apoderado: SAGUAR DUE脩AS ESTRELLA ISABEL. Datos registrales. T 27989 , F 118, S 8, H M 505088, I/A 12 (4.07.12).
14 de Abril de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: JUSTE VELASCO FELIPE RAMON. Datos registrales. T 27989 , F 118, S 8, H M 505088, I/A 11 (4.04.11).
08 de Marzo de 2011Revocaciones. Apoderado: LAORGA GUERRERO DAVID. Datos registrales. T 27989 , F 118, S 8, H M 505088, I/A 10 (24.02.11).
07 de Marzo de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ SANCHEZ PORTAL MARIA GEMA;GARCIA SALIDO JOSE RICARDO;PE脩A MELLADOROBERTO. Datos registrales. T 27989 , F 115, S 8, H M 505088, I/A 9 (22.02.11).
22 de Febrero de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: SUAREZ CANTON NICOLAS;LEAL DE CARLOS MARIA JOSE. Datos registrales. T 27989 , F 115, S 8,H M 505088, I/A 8 ( 8.02.11).
08 de Febrero de 2011Nombramientos. Apoderado: LAORGA GUERRERO DAVID. Datos registrales. T 27989 , F 114, S 8, H M 505088, I/A 7 (27.01.11).
18 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apoderado: SOLER RUIZ-BOADA MIGUEL. Datos registrales. T 27989 , F 110, S 8, H M 505088, I/A 6 ( 4.11.10).
06 de Septiembre de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ BARBE SAGRARIO;COROMINAS MENENDEZ ALEJANDRO;BANDRES GUTIERREZMIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 28030 , F 15, S 8, H M 505088, I/A 2 (25.08.10).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA MATEOS ANGEL;NOGAL VELEZ ANTONIO;GIMENO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER.Datos registrales. T 28030 , F 18, S 8, H M 505088, I/A 3 (25.08.10).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ COCA GERARDO;SUAREZ CANTON NICOLAS;GARCIA SALIDO JOSE RICARDO.Datos registrales. T 28030 , F 19, S 8, H M 505088, I/A 4 (25.08.10).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ MOSSO JOSE-MARIA;VELAZQUEZ BARROSO JUAN. Datos registrales. T 27989 , F 110,S 8, H M 505088, I/A 5 (25.08.10).
30 de Agosto de 2010Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 16.07.10. Objeto social: LA REALIZACION DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES DECARACTER INMOBILIARIO, EN ESPECIAL, LAS RELATIVAS A LA ADQUISICION, TENENCIA, ARRENDAMIENTO.... Domicilio: C/PAJARITOS 24 (MADRID). Capital: 50.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: PROSEGUR COMPA脩IA DESEGURIDAD SA. Nombramientos. Consejero: RUBIO MERINO ANTONIO. Presidente: RUBIO MERINO ANTONIO. Consejero:SOLER RUIZ-BOADA MIGUEL. Secretario: SOLER RUIZ-BOADA MIGUEL. Consejero: SUAREZ-CANTON PE脩A NICOLAS. Datosregistrales. T 28030 , F 11, S 8, H M 505088, I/A 1 (19.08.10).