Actos BORME de Prosegur Global Alarmas Sl
15 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apoderado: PEREA ARRANZ PEDRO PABLO. Datos registrales. T 42009 , F 185, S 8, H M 411755, I/A 111 (9.12.23).
26 de Octubre de 2023Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 42009 , F 185, S 8, H M 411755, I/A 110 (19.10.23).
26 de Julio de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUBIO MERINO ANTONIO. Apoderado: RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 42009 , F185, S 8, H M 411755, I/A 109 (19.07.23).
18 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: GARCIA GARCIA JOSE ANGEL. Datos registrales. T 42009 , F 185, S 8, H M 411755, I/A 108(10.05.23).
20 de Abril de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ BARBE SAGRARIO. Datos registrales. T 42009 , F 184, S 8, H M 411755, I/A 107(13.04.23).
04 de Abril de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA MATEOS ANGEL. Datos registrales. T 42009 , F 183, S 8, H M 411755, I/A 105 (28.03.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANZ LOSADA JOSE MARIA. Datos registrales. T 42009 , F 184, S 8, H M 411755, I/A 106(28.03.23).
13 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: LANZUELA DE ALVARO FRANCISCO. Datos registrales. T 42009 , F 183, S 8, H M 411755, I/A 104 (6.03.23).
24 de Febrero de 2023Otros conceptos: RARIFICACION DEL OTORGAMIENTO DE LA FACULTAD 53 A DON FRANCISCO LANZUELA DE ALVAROPOR LA INSRIPCION 94陋. Datos registrales. T 42009 , F 183, S 8, H M 411755, I/A 103 (16.02.23).
21 de Febrero de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ JIMENEZ FRUCTUOSO. Datos registrales. T 42009 , F 183, S 8, H M 411755, I/A 102(14.02.23).
19 de Enero de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN DONAIRE FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 42009 , F 182, S 8, H M 411755, I/A101 (12.01.23).
11 de Enero de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: REINA CANO EMILIO;REINA CANO EMILIO. Datos registrales. T 42009 , F 182, S 8, H M 411755,I/A 100 ( 3.01.23).
23 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: COUTO FARIA GONCALVES PAULO ALEXANDRE. Datos registrales. T 42009 , F 180, S 8, H M411755, I/A 99 (16.12.22).
20 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: COUTO FARIA GONCALVES PAULO ALEXANDRE. Datos registrales. T 42009 , F 180, S 8, H M411755, I/A 98 (13.12.22).
19 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: TEJEDOR TRANCA MARIA DOLORES. Datos registrales. T 42009 , F 179, S 8, H M 411755, I/A 97(12.12.22).
14 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ JAIME BORJA. Datos registrales. T 42009 , F 179, S 8, H M 411755, I/A 96 ( 5.12.22).
18 de Octubre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR;PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 42009 ,F 179, S 8, H M 411755, I/A 95 (10.10.22).
11 de Octubre de 2022Nombramientos. Apoderado: LANZUELA DE ALVARO FRANCISCO. Datos registrales. T 42009 , F 177, S 8, H M 411755, I/A 94 (4.10.22).
02 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: BENEDICTE MONET LAURA. Datos registrales. T 42009 , F 175, S 8, H M 411755, I/A 93 (26.07.22).
30 de Mayo de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: ULLOA DELGADO GUILLERMO. Datos registrales. T 42009 , F 175, S 8, H M 411755, I/A 92 (23.05.22).
26 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: SOBRINO POUSA DIEGO. Datos registrales. T 42009 , F 174, S 8, H M 411755, I/A 91 (19.05.22).
24 de Mayo de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: DOBRINO POUSA DIEGO. Datos registrales. T 42009 , F 174, S 8, H M 411755, I/A 90 (17.05.22).
19 de Abril de 2022Otros conceptos: Rectificaci贸n de la inscripci贸n 87陋, en cuanto a la fecha y n煤mero de protocolo del poder revocado a Do帽a DianaRentea Rentea, siendo la fecha correcta 15 de octubre de 2020, n煤mero 2181.- Datos registrales. T 42009 , F 173, S 8, H M 411755,I/A 89 ( 8.04.22).
24 de Febrero de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: SAAVEDRA LLANO JULIO. Apoderado: SAAVEDRA LLANO JULIO. Datos registrales. T 42009 , F 173, S8, H M 411755, I/A 88 (17.02.22).
24 de Enero de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: RENTEA RENTEA DIANA. Datos registrales. T 42009 , F 173, S 8, H M 411755, I/A 87 (17.01.22).
13 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apoderado: GUT REVOREDO CHRISTIAN. Datos registrales. T 42009 , F 173, S 8, H M 411755, I/A 86 ( 2.12.21).
25 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PROSEGUR INTERNATIONAL ALARMAS SL. Representan: RUBIO MERINO ANTONIO.Nombramientos. Adm. Unico: PROSEGUR COMPA脩IA DE SEGURIDAD SA. Representan: CABRERIZO BARRERA FRANCISCOJAVIER. Datos registrales. T 42009 , F 173, S 8, H M 411755, I/A 85 (18.10.21).
22 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABRERIZO BARRERA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 42009 , F 170, S 8, H M411755, I/A 84 (15.10.21).
06 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 36199 , F 51, S 8, H M 411755, I/A 82(29.09.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 36199 , F 53, S 8, H M 411755, I/A 83(29.09.21).
24 de Septiembre de 2021Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 36199 , F 51, S 8, H M 411755, I/A 81 (17.09.21).
02 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Otros conceptos: Ha causado baja el poder conferido en favor deDo帽a Marta Ermitas Mallo Fern谩ndez, el 20 de enero de 2021, que caus贸 la precedente inscripci贸n 77陋, por haber sido otorgado porerror. Datos registrales. T 36199 , F 51, S 8, H M 411755, I/A 80 (26.05.21).
28 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: GESTAL LOPEZ DAVID JOSE. Datos registrales. T 36199 , F 50, S 8, H M 411755, I/A 79(21.04.21).
17 de Marzo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Datos registrales. T 36199 , F 49, S 8, H M 411755, I/A 78 (10.03.21).
15 de Febrero de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Datos registrales. T 36199 , F 47, S 8, H M 411755, I/A 76 (8.02.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA;SANCHEZ DE COS ANDRES. Datos registrales. T 36199 , F49, S 8, H M 411755, I/A 77 ( 8.02.21).
03 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR;RENTEA RENTEA DIANA. Datos registrales. T 36199 , F 45, S 8,H M 411755, I/A 73 (26.11.20).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANTOS IGLESIAS ALBERTO. Datos registrales. T 36199 , F 46, S 8, H M 411755, I/A 74(26.11.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: ULLOA DELGADO GUILLERMO;PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 36199 , F47, S 8, H M 411755, I/A 75 (26.11.20).
20 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: MU脩OZ VALLEJO MARCO ANTONIO. Datos registrales. T 36199 , F 44, S 8, H M 411755, I/A 71(14.11.20).
Revocaciones. Apoderado: BERROCAL IGLESIAS ALFONSO. Datos registrales. T 36199 , F 45, S 8, H M 411755, I/A 72(14.11.20).
11 de Agosto de 2020Revocaciones. Apoderado: PE脩A MELLADO ROBERTO. Apo.Man.Soli: MU脩OZ VALDES RAFAEL;GRANDE PARDO ENRIQUEPEDRO;GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO. Datos registrales. T 36199 , F 44, S 8, H M 411755, I/A 70 ( 4.08.20).
10 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: BERRAL REINA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 36199 , F 43, S 8, H M 411755, I/A 69 (3.08.20).
03 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: GARCIA PRIETO ALVARO. Datos registrales. T 36199 , F 42, S 8, H M 411755, I/A 68 (27.07.20).
23 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: LOPEZ-HUERTA MARTIN FRANCISCO-JAVIER. Datos registrales. T 36199 , F 38, S 8, H M 411755,I/A 65 (16.07.20).
Nombramientos. Apoderado: ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA;LOZANO SANCHEZ ALBERTO;SANCHEZ DE COSANDRES;DIAZ HERVAS PEDRO;ZAHARIEVA ZORINA;RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 36199 , F 40, S 8, H M
Nombramientos. Apoderado: ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA;SANCHEZ DE COS ANDRES. Datos registrales. T 36199 ,F 42, S 8, H M 411755, I/A 67 (16.07.20).
25 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: BASTIDA MARTIN DANIEL. Datos registrales. T 36199 , F 38, S 8, H M 411755, I/A 64 (17.07.19).
04 de Julio de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ BARBE SAGRARIO. Datos registrales. T 36199 , F 38, S 8, H M 411755, I/A 63 (27.06.19).
12 de Junio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: SANTOS IGLESIAS ALBERTO. Datos registrales. T 36199 , F 37, S 8, H M 411755, I/A 62 ( 5.06.19).
24 de Mayo de 2019Nombramientos. Apoderado: PEREA ARRANZ PEDRO PABLO. Datos registrales. T 36199 , F 35, S 8, H M 411755, I/A 61(17.05.19).
15 de Marzo de 2019Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 36199 , F 34, S 8, H M 411755, I/A 60 ( 8.03.19).
27 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: REINA CANO EMILIO;GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO;GONZALEZ JIMENEZ FRUCTUOSO.Datos registrales. T 36199 , F 33, S 8, H M 411755, I/A 59 (19.11.18).
05 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ BARBE SAGRARIO. Datos registrales. T 36199 , F 33, S 8, H M 411755, I/A 58(29.08.18).
10 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONZON HIDALGO ENRIQUE CARLOS. Datos registrales. T 36199 , F 32, S 8, H M 411755, I/A57 ( 3.05.18).
21 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: BERROCAL IGLESIAS ALFONSO. Datos registrales. T 36199 , F 32, S 8, H M 411755, I/A 56(13.11.17).
20 de Noviembre de 2017Otros conceptos: Mediante diligencia presentada, se modifica el segundo apellido del apoderado, siendo su nombre correctocompleto, DON JULIO SAAVEDRA LLANO. Datos registrales. T 36199 , F 32, S 8, H M 411755, I/A 55 ( 8.11.17).
24 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: BARRANCO AMARO PEDRO LUIS;POZO BARGUE脩O ESTEBAN;GIL MATAIX RAMON. Datosregistrales. T 36199 , F 31, S 8, H M 411755, I/A 54 (11.10.17).
18 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: SCHOOFS CHRISTOPH. Datos registrales. T 36199 , F 29, S 8, H M 411755, I/A 53 ( 9.10.17).
11 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: MONZON HIDALGO ENRIQUE-CARLOS. Datos registrales. T 36199 , F 29, S 8, H M 411755, I/A 52( 1.09.17).
31 de Agosto de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA SALIDO JOSE-RICARDO. Datos registrales. T 36199 , F 28, S 8, H M 411755, I/A 51(23.08.17).
24 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: SAAVEDRA LLANA JULIO. Datos registrales. T 26948 , F 165, S 8, H M 411755, I/A 50 ( 9.08.17).
27 de Julio de 2017Revocaciones. Apoderado: O脩A LOPEZ MARIA DEL MAR;ESPA脩A CONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T 26948 , F 165,S 8, H M 411755, I/A 49 (20.07.17).
05 de Junio de 2017Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 26948 , F 165, S 8, H M 411755, I/A 48 (26.05.17).
29 de Mayo de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.000.004,00 Euros. Datos registrales. T 26948 , F 164, S 8, H M411755, I/A 47 (19.05.17).
22 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: SAAVEDRA LLANA JULIO. Datos registrales. T 26948 , F 164, S 8, H M 411755, I/A 46 (13.03.17).
21 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA PRIETO ALVARO. Datos registrales. T 26948 , F 163, S 8, H M 411755, I/A 45 (10.03.17).
16 de Febrero de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO. Datos registrales. T 26948 , F 161, S 8, H M 411755, I/A 43 (8.02.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: REINA CANO EMILIO. Datos registrales. T 26948 , F 162, S 8, H M 411755, I/A 44 ( 8.02.17).
31 de Enero de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.000.003,00 Euros. Datos registrales. T 26948 , F 160, S 8, H M411755, I/A 42 (23.01.17).
03 de Agosto de 2016Otros conceptos: SUBSANACION DE LA ESCRITURA AUTORIZADA POR LA NOTARIO DE MADRID, D陋 ELOISA LOPEZ-MONISGALLEGO, EL DIA 04.04.2016, CON EL NUM. 526 DE SU PROTOCOLO, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 40陋, EN CUANTO ALLIMITE DE LA ACTUACION MANCOMUNADA DEL APODERADO D. ANTONIO ESPA脩A CONTRERAS. Datos registrales. T 26948, F 160, S 8, H M 411755, I/A 41 (22.07.16).
26 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 26948 , F 158, S 8, H M 411755, I/A 39(15.04.16).
Nombramientos. Apoderado: ESPA脩A CONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T 26948 , F 159, S 8, H M 411755, I/A 40(18.04.16).
29 de Marzo de 2016Otros conceptos: Subsanada la inscripci贸n n煤mero 33 en cuanto a la valoraci贸n del 100% de las participaciones de "ProsegurInternational Alarmas SL", realizado para el desembolso de la participaci贸n social 2.000.001 m谩s la prima de emisi贸n, siendo el valorcorrecto 14.874.698 euros. Datos registrales. T 26948 , F 157, S 8, H M 411755, I/A 38 (17.03.16).
04 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: O脩A LOPEZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 26948 , F 157, S 8, H M 411755, I/A 36(25.02.16).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA JOSE ANGEL;DOMINGUEZ PEREZ DIEGO MARIA. Datos registrales. T 26948 , F157, S 8, H M 411755, I/A 37 (26.02.16).
28 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: MU脩OZ VALDES RAFAEL. Datos registrales. T 26948 , F 155, S 8, H M 411755, I/A 35 (18.12.15).
19 de Octubre de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: SOLER RUIZ-BOADA MIGUEL;FERNANDEZ BARBE SAGRARIO. Datos registrales. T 26948 , F 155, S8, H M 411755, I/A 34 ( 9.10.15).
01 de Septiembre de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 2,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.000.002,00 Euros. Datos registrales. T 26948 , F 154, S 8, H M411755, I/A 33 (24.08.15).
08 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GUT REVOREDO CHRISTIAN;BANDRES GUTIERREZ MIGUEL. Nombramientos. Adm.Unico: PROSEGUR INTERNATIONAL ALARMAS SL. Representan: RUBIO MERINO ANTONIO. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 26948 , F 154, S 8, H M411755, I/A 32 (30.06.15).