Actos BORME de Prosegur Global Sis Row Sl
18 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apoderado: PEREA ARRANZ PEDRO PABLO. Datos registrales. T 40177 , F 154, S 8, H M 603124, I/A 83(11.12.23).
13 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Representan: CABRERIZO BARRERA FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Representan: ABOS PUEYOFERNANDO SIRO. Datos registrales. T 40177 , F 153, S 8, H M 603124, I/A 82 ( 5.11.23).
30 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO. Datos registrales. T 40177 , F 153, S 8, H M 603124, I/A 81(23.10.23).
26 de Octubre de 2023Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 40177 , F 153, S 8, H M 603124, I/A 80 (19.10.23).
26 de Julio de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUBIO MERINO ANTONIO;RUBIO MERINO ANTONIO;RUBIO MERINO ANTONIO. Datosregistrales. T 40177 , F 153, S 8, H M 603124, I/A 79 (19.07.23).
12 de Junio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA MATEOS ANGEL. Datos registrales. T 40177 , F 152, S 8, H M 603124, I/A 78 ( 2.06.23).
18 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: GARCIA GARCIA JOSE ANGEL. Datos registrales. T 40177 , F 152, S 8, H M 603124, I/A 77(10.05.23).
04 de Mayo de 2023Nombramientos. Apoderado: TEJEDOR TRANCA MARIA DOLORES. Datos registrales. T 40177 , F 152, S 8, H M 603124, I/A 76(25.04.23).
30 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ JIMENEZ FRUCTUOSO. Datos registrales. T 40177 , F 151, S 8, H M 603124, I/A 75(23.03.23).
02 de Enero de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: REINA CANO EMILIO;REINA CANO EMILIO. Datos registrales. T 40177 , F 151, S 8, H M 603124,I/A 73 (23.12.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN DONAIRE FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 40177 , F 151, S 8, H M 603124, I/A74 (23.12.22).
22 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: COUTO FARIA GONCALVES PAULO ALEXANDRE. Datos registrales. T 40177 , F 149, S 8, H M603124, I/A 71 (15.12.22).
Nombramientos. Apoderado: COUTO FARIA GONCALVES PAULO ALEXANDRE. Datos registrales. T 40177 , F 149, S 8, H M603124, I/A 72 (15.12.22).
09 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ JAIME BORJA. Datos registrales. T 40177 , F 148, S 8, H M 603124, I/A 70 (30.11.22).
08 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apoderado: ABOS PUEYO FERNANDO SIRO. Datos registrales. T 40177 , F 145, S 8, H M 603124, I/A 69(31.10.22).
21 de Octubre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR. Apoderado: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR. Datosregistrales. T 40177 , F 145, S 8, H M 603124, I/A 68 (14.10.22).
12 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: ULLOA DELGADO GUILLERMO. Datos registrales. T 40177 , F 145, S 8, H M 603124, I/A 67 (5.08.22).
11 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: SOBRINO POUSA DIEGO. Datos registrales. T 40177 , F 145, S 8, H M 603124, I/A 66 ( 4.08.22).
02 de Agosto de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: BENEDICTE MONET LAURA. Apo.Sol.: BENEDICTE MONET LAURA. Datos registrales. T 40177 , F143, S 8, H M 603124, I/A 65 (26.07.22).
13 de Mayo de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANTOS IGLESIAS ALBERTO. Datos registrales. T 40177 , F 142, S 8, H M 603124, I/A 64 (6.05.22).
24 de Febrero de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: SAAVEDRA LLANO JULIO. Apoderado: SAAVEDRA LLANO JULIO. Datos registrales. T 40177 , F 142, S8, H M 603124, I/A 63 (17.02.22).
22 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABRERIZO BARRERA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 40177 , F 140, S 8, H M603124, I/A 62 (15.10.21).
18 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Representan: PENA RODRIGUEZ JOSE MARIA. Nombramientos. Representan: CABRERIZO BARRERAFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 40177 , F 139, S 8, H M 603124, I/A 61 ( 8.10.21).
14 de Octubre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: RENTEA RENTEA DIANA. Datos registrales. T 40177 , F 139, S 8, H M 603124, I/A 60 ( 6.10.21).
31 de Agosto de 2021Nombramientos. Apoderado: BASTIDA MARTIN DANIEL. Datos registrales. T 40177 , F 139, S 8, H M 603124, I/A 59 (24.08.21).
30 de Agosto de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 40177 , F 137, S 8, H M 603124, I/A 58(23.08.21).
09 de Agosto de 2021Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 40177 , F 137, S 8, H M 603124, I/A 57 ( 2.08.21).
30 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 40177 , F 135, S 8, H M 603124, I/A 56(23.07.21).
12 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Otros conceptos: HA CAUSADO BAJA EL PODER CONFERIDOA DO脩A MARTA ERMITAS MALLO FERNANDEZ EL 20 DE ENERO DE 2021, POR HABER SIDO OTORGADO POR ERROR. Datosregistrales. T 40177 , F 135, S 8, H M 603124, I/A 55 ( 5.05.21).
04 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: GESTAL LOPEZ DAVID JOSE. Datos registrales. T 40177 , F 134, S 8, H M 603124, I/A 54(26.04.21).
30 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Datos registrales. T 40177 , F 133, S 8, H M 603124, I/A 53(23.03.21).
19 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ DE COS ANDRES;ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA. Datos registrales. T 40177 ,F 133, S 8, H M 603124, I/A 52 (12.02.21).
17 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Datos registrales. T 40177 , F 131, S 8, H M 603124, I/A 51(10.02.21).
13 de Enero de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA PRIETO ALVARO;RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 40177 , F 130, S 8, HM 603124, I/A 50 ( 5.01.21).
09 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR;ULLOA DELGADO GUILLERMO. Datos registrales. T 40177 ,F 130, S 8, H M 603124, I/A 49 (30.11.20).
03 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR;RENTEA RENTEA DIANA. Datos registrales. T 40177 , F 129, S8, H M 603124, I/A 48 (26.11.20).
23 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ VALLEJO MARCO ANTONIO. Datos registrales. T 40177 , F 129, S 8, H M 603124, I/A 47(16.11.20).
14 de Agosto de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: BERRAL REINA FRANCISCO JOSE. Apo.Sol.: BERRAL REINA FRANCISCO JOSE. Datosregistrales. T 40177 , F 128, S 8, H M 603124, I/A 46 ( 7.08.20).
10 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA;LOZANO SANCHEZ ALBERTO;SANCHEZ DE COSANDRES;DIAZ HERVAS PEDRO;ZAHARIEVA ZORINA;RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 40177 , F 126, S 8, H M603124, I/A 45 ( 3.08.20).
03 de Agosto de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ SANCHEZ-PORTAL GEMA;PE脩A MELLADO ROBERTO. Apo.Sol.: PE脩A MELLADOROBERTO. Apo.Man.Soli: MU脩OZ VALDES RAFAEL;GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO. Datos registrales. T 40177 , F 126, S 8,H M 603124, I/A 44 (27.07.20).
04 de Mayo de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ-HUERTA MARTIN FRANCISCO-JAVIER. Datos registrales. T 36199 , F 122, S 8, H M603124, I/A 42 (24.04.20).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 36199 , F 124, S 8, H M 603124, I/A 43 (24.04.20).
30 de Abril de 2020Ceses/Dimisiones. Representan: RUBIO MERINO ANTONIO. Nombramientos. Representan: PENA RODRIGUEZ JOSE MARIA.Datos registrales. T 36199 , F 121, S 8, H M 603124, I/A 41 (22.04.20).
09 de Marzo de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: TABERNERO DA VEIGA JAVIER. Datos registrales. T 36199 , F 121, S 8, H M 603124, I/A 40 (2.03.20).
04 de Febrero de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTIN RIVALS CARLOS. Datos registrales. T 36199 , F 118, S 8, H M 603124, I/A 38 (28.01.20).
Nombramientos. Apoderado: DOS REIS MARUJO PINA PAULO JORGE. Datos registrales. T 36199 , F 119, S 8, H M 603124, I/A39 (28.01.20).
24 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ BARBE SAGRARIO. Datos registrales. T 36199 , F 118, S 8, H M 603124, I/A 37(17.12.19).
22 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: SANTOS IGLESIAS ALBERTO. Datos registrales. T 36199 , F 118, S 8, H M 603124, I/A 36(15.07.19).
24 de Mayo de 2019Nombramientos. Apoderado: PEREA ARRANZ PEDRO PABLO. Datos registrales. T 36199 , F 115, S 8, H M 603124, I/A 35(17.05.19).
27 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: REINA CANO EMILIO;GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO;GONZALEZ JIMENEZ FRUCTUOSO.Datos registrales. T 36199 , F 114, S 8, H M 603124, I/A 34 (20.11.18).
06 de Agosto de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: BANDRES GUTIERREZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 36199 , F 114, S 8, H M 603124, I/A33 (30.07.18).
14 de Diciembre de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN RIVALS CARLOS. Datos registrales. T 36199 , F 112, S 8, H M 603124, I/A 32 ( 1.12.17).
20 de Noviembre de 2017Otros conceptos: Mediante diligencia presentada, se modifica el segundo apellido del apoderado, siendo su nombre correctocompleto, DON JULIO SAAVEDRA LLANO. Datos registrales. T 36199 , F 112, S 8, H M 603124, I/A 31 ( 8.11.17).
24 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: BARRANCO AMARO PEDRO LUIS;POZO BARGUE脩O ESTEBAN;GIL MATAIX RAMON. Datosregistrales. T 36199 , F 111, S 8, H M 603124, I/A 30 (11.10.17).
18 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: SCHOOFS CHRISTOPH. Datos registrales. T 36199 , F 110, S 8, H M 603124, I/A 29 ( 9.10.17).
24 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: SAAVEDRA LLANA JULIO. Datos registrales. T 33174 , F 144, S 8, H M 603124, I/A 28 ( 9.08.17).
12 de Julio de 2017Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 33174 , F 143, S 8, H M 603124, I/A 27 ( 4.07.17).
14 de Junio de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTIN CARRERA JUAN LUIS. Apoderado: ESPA脩A CONTRERAS ANTONIO;O脩A LOPEZ MARIADEL MAR;ESPA脩A CONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T 33174 , F 143, S 8, H M 603124, I/A 26 ( 6.06.17).
29 de Mayo de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 2,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.009,00 Euros. Datos registrales. T 33174 , F 142, S 8, H M603124, I/A 25 (19.05.17).
22 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: SAAVEDRA LLANA JULIO. Datos registrales. T 33174 , F 142, S 8, H M 603124, I/A 24 (13.03.17).
16 de Febrero de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO. Datos registrales. T 33174 , F 141, S 8, H M 603124, I/A 22 (8.02.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: REINA CANO EMILIO. Datos registrales. T 33174 , F 141, S 8, H M 603124, I/A 23 ( 8.02.17).
26 de Octubre de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.007,00 Euros. Datos registrales. T 33174 , F 140, S 8, H M603124, I/A 21 (18.10.16).
03 de Agosto de 2016Otros conceptos: SUBSANACION DE LA ESCRITURA AUTORIZADA POR LA NOTARIO DE MADRID, D陋 ELOISA LOPEZ-MONISGALLEGO, EL DIA 04.04.2016, CON EL NUM. 526 DE SU PROTOCOLO, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 16陋, EN CUANTO ALLIMITE DE LA ACTUACION MANCOMUNADA DEL APODERADO D. ANTONIO ESPA脩A CONTRERAS. Datos registrales. T 33174, F 140, S 8, H M 603124, I/A 20 (22.07.16).
29 de Julio de 2016Nombramientos. Apoderado: GARCIA MATEOS ANGEL. Datos registrales. T 33174 , F 139, S 8, H M 603124, I/A 18 (20.07.16).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.006,00 Euros. Datos registrales. T 33174 , F 139, S 8, H M603124, I/A 19 (21.07.16).
26 de Julio de 2016Nombramientos. Apoderado: MONZON HIDALGO ENRIQUE CARLOS. Datos registrales. T 33174 , F 138, S 8, H M 603124, I/A 17(15.07.16).
26 de Abril de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 33174 , F 137, S 8, H M 603124, I/A 15(15.04.16).
Nombramientos. Apoderado: ESPA脩A CONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T 33174 , F 137, S 8, H M 603124, I/A 16(18.04.16).
07 de Marzo de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.005,00 Euros. Datos registrales. T 33174 , F 136, S 8, H M603124, I/A 14 (26.02.16).
04 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: O脩A LOPEZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 33174 , F 135, S 8, H M 603124, I/A 12(25.02.16).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA JOSE ANGEL;DOMINGUEZ PEREZ DIEGO MARIA. Datos registrales. T 33174 , F136, S 8, H M 603124, I/A 13 (26.02.16).
20 de Enero de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.004,00 Euros. Datos registrales. T 33174 , F 135, S 8, H M603124, I/A 11 (13.01.16).
30 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: ESPA脩A CONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T 33174 , F 133, S 8, H M 603124, I/A 9(21.12.15).
28 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: MU脩OZ VALDES RAFAEL. Datos registrales. T 33174 , F 132, S 8, H M 603124, I/A 8 (18.12.15).
17 de Diciembre de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.003,00 Euros. Datos registrales. T 33174 , F 131, S 8, H M603124, I/A 7 ( 9.12.15).
27 de Noviembre de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 2,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.002,00 Euros. Datos registrales. T 33174 , F 130, S 8, H M603124, I/A 6 (19.11.15).
09 de Julio de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: SOLER RUIZ BOADA MIGUEL;FERNANDEZ BARBE SAGRARIO;BANDRES GUTIERREZ MIGUELANGEL;TABERNERO DA VEIGA JAVIER. Datos registrales. T 33507 , F 26, S 8, H M 603124, I/A 2 ( 1.07.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ SANCHEZ-PORTAL GEMA;MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL;GARCIA SALIDO JOSERICARDO;RUBIO MERINO ANTONIO;PE脩A MELLADO ROBERTO;GARCIA PRIETO ALVARO. Datos registrales. T 33507 , F 28, S8, H M 603124, I/A 3 ( 1.07.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: PE脩A MELLADO ROBERTO;GARCIA SALIDO JOSE RICARDO. Datos registrales. T 33507 , F 30, S 8,H M 603124, I/A 4 ( 1.07.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: NOGAL VELEZ ANTONIO;MONZON HIDALGO ENRIQUE CARLOS;MARTIN CARRERA JUANLUIS;GARCIA MATEOS ANGEL. Datos registrales. T 33507 , F 31, S 8, H M 603124, I/A 5 ( 1.07.15).
11 de Junio de 2015Nombramientos. Apoderado: SOLER RUIZ-BOADA MIGUEL. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA CONSTITUCION, ELNOMBRAMIENTO COMO APODERADO DE DON MIGUEL SOLER RUIZ-BOADA. Datos registrales. T 33507 , F 22, S 8, H M603124, I/A 1 (22.05.15).
01 de Junio de 2015Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 8.05.15. Objeto social: 1. La realizaci贸n de los siguientes servicios y actividades, directa oindirectamente, mediante la participaci贸n en cualesquiera otras sociedades o empresas de objeto id茅ntico o an谩logo, con sujeci贸n a lalegislaci贸n aplicable en cada caso: (i) Vigilancia y protecci贸n de bienes, establecimientos, es. Domicilio: C/ PAJARITOS 24 (MADRID).Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: PROSEGUR COMPA脩IA DE SEGURIDAD SA.Nombramientos. Adm. Unico: PROSEGUR COMPA脩IA DE SEGURIDAD SA. Representan: RUBIO MERINO ANTONIO. Datosregistrales. T 33507 , F 22, S 8, H M 603124, I/A 1 (22.05.15).