Actos BORME de Prosegur International Alarmas Sl
15 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apoderado: PEREA ARRANZ PEDRO PABLO. Datos registrales. T 41510 , F 158, S 8, H M 527771, I/A 71 (9.12.23).
26 de Julio de 2023Revocaciones. Apoderado: RUBIO MERINO ANTONIO;RUBIO MERINO ANTONIO;RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales.T 41510 , F 158, S 8, H M 527771, I/A 70 (19.07.23).
17 de Julio de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: GUTIERREZ GONZALEZ LEONARDO EZEQUIEL. Datos registrales. T 41510 , F 157, S 8, H M 527771,I/A 69 (10.07.23).
18 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: GARCIA GARCIA JOSE ANGEL. Datos registrales. T 41510 , F 157, S 8, H M 527771, I/A 68(10.05.23).
04 de Abril de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA MATEOS ANGEL. Datos registrales. T 41510 , F 156, S 8, H M 527771, I/A 66 (28.03.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANZ LOSADA JOSE MARIA. Datos registrales. T 41510 , F 156, S 8, H M 527771, I/A 67(28.03.23).
22 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Representan: LANZUELA DE ALVARO FRANCISCO. Nombramientos. Representan: GARCIA PRIETOALVARO. Datos registrales. T 41510 , F 155, S 8, H M 527771, I/A 65 (14.03.23).
19 de Enero de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN DONAIRE FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 41510 , F 155, S 8, H M 527771, I/A64 (12.01.23).
23 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: COUTO FARIA GONCALVES PAULO ALEXANDRE. Datos registrales. T 41510 , F 153, S 8, H M527771, I/A 63 (16.12.22).
20 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: COUTO FARIA GONCALVES PAULO ALEXANDRE. Datos registrales. T 41510 , F 153, S 8, H M527771, I/A 62 (13.12.22).
18 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR. Apo.Sol.: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR. Datosregistrales. T 41510 , F 153, S 8, H M 527771, I/A 61 (10.10.22).
02 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: BENEDICTE MONET LAURA. Datos registrales. T 41510 , F 151, S 8, H M 527771, I/A 60 (26.07.22).
12 de Julio de 2022Otros conceptos: Se ratifica el poder que caus贸 la inscripci贸n 54陋 y se inscribe su facultad 53陋.- Datos registrales. T 41510 , F 151,S 8, H M 527771, I/A 59 ( 5.07.22).
30 de Mayo de 2022Revocaciones. Apoderado: ULLOA DELGADO GUILLERMO. Datos registrales. T 41510 , F 151, S 8, H M 527771, I/A 58(23.05.22).
26 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: SOBRINO POUSA DIEGO. Datos registrales. T 41510 , F 150, S 8, H M 527771, I/A 57 (19.05.22).
13 de Mayo de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANTOS IGLESIAS ALBERTO. Datos registrales. T 41510 , F 149, S 8, H M 527771, I/A 56 (6.05.22).
16 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Representan: PEREA ARRANZ PEDRO PABLO. Adm. Mancom.: PROSEGUR SOLUCIONES SA;FORMACIONSELECCION Y CONSULTORIA SA. Representan: MARTIN CARRERA JUAN LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: PROSEGURGLOBAL ALARMAS SL. Representan: LANZUELA DE ALVARO FRANCISCO. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores mancomunados a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 41510 , F 149, S 8, H M 527771, I/A 55 (9.12.21).
22 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABRERIZO BARRERA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 41510 , F 146, S 8, H M527771, I/A 54 (15.10.21).
14 de Octubre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: RENTEA RENTEA DIANA. Datos registrales. T 41510 , F 146, S 8, H M 527771, I/A 53 ( 6.10.21).
04 de Agosto de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 41510 , F 144, S 8, H M 527771, I/A 52(28.07.21).
26 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 41510 , F 142, S 8, H M 527771, I/A 51(19.07.21).
15 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: GESTAL LOPEZ DAVID JOSE. Datos registrales. T 41510 , F 142, S 8, H M 527771, I/A 50 (8.07.21).
14 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ DE COS ANDRES;ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA;LOZANO SANCHEZALBERTO;DIAZ HERVAS PEDRO. Datos registrales. T 41510 , F 140, S 8, H M 527771, I/A 49 ( 7.05.21).
12 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Otros conceptos: HA CAUSADO BAJA EL PODER CONFERIDOA DO脩A MARTA ERMITAS MALLO FERNANDEZ EL 20 DE ENERO DE 2021, POR HABER SIDO OTORGADO POR ERROR. Datosregistrales. T 41510 , F 140, S 8, H M 527771, I/A 48 ( 5.05.21).
30 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Datos registrales. T 29319 , F 199, S 8, H M 527771, I/A 47(23.03.21).
19 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ DE COS ANDRES;ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA. Datos registrales. T 29319 ,F 197, S 8, H M 527771, I/A 45 (12.02.21).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA PRIETO ALVARO;RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 29319 , F 198, S 8, H M527771, I/A 46 (12.02.21).
17 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Datos registrales. T 29319 , F 196, S 8, H M 527771, I/A 44(10.02.21).
15 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: RENTEA RENTEA DIANA;PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 29319 , F 195, S8, H M 527771, I/A 43 ( 4.12.20).
10 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apoderado: BERROCAL IGLESIAS ALFONSO. Datos registrales. T 29319 , F 195, S 8, H M 527771, I/A 42 (1.12.20).
09 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR;ULLOA DELGADO GUILLERMO. Datos registrales. T 29319 ,F 195, S 8, H M 527771, I/A 41 (30.11.20).
14 de Agosto de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: BERRAL REINA FRANCISCO JOSE. Apo.Sol.: BERRAL REINA FRANCISCO JOSE. Datosregistrales. T 29319 , F 194, S 8, H M 527771, I/A 40 ( 7.08.20).
29 de Julio de 2020Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ-PORTAL GEMA;PE脩A MELLADO ROBERTO. Apo.Man.Soli: MU脩OZ VALDESRAFAEL. Datos registrales. T 29319 , F 194, S 8, H M 527771, I/A 39 (22.07.20).
24 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 29319 , F 192, S 8, H M 527771, I/A 38(17.07.20).
27 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: PEREA ARRANZ PEDRO PABLO. Datos registrales. T 29319 , F 190, S 8, H M 527771, I/A 37(20.03.20).
07 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Representan: FERNANDEZ BARBE SAGRARIO. Nombramientos. Representan: MARTIN CARRERA JUANLUIS. Datos registrales. T 29319 , F 189, S 8, H M 527771, I/A 36 (31.01.20).
25 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: BASTIDA MARTIN DANIEL. Datos registrales. T 29319 , F 189, S 8, H M 527771, I/A 35 (17.07.19).
10 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: SOLER RUIZ BOADA MIGUEL. Nombramientos. Representan: PEREA ARRANZ PEDROPABLO. Datos registrales. T 29319 , F 188, S 8, H M 527771, I/A 34 ( 3.06.19).
04 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ BARBE SAGRARIO;FERNANDEZ BARBE SAGRARIO. Datos registrales. T 29319 , F188, S 8, H M 527771, I/A 33 (28.08.18).
06 de Agosto de 2018Revocaciones. Apoderado: BANDRES GUTIERREZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 29319 , F 188, S 8, H M 527771, I/A 32(30.07.18).
21 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: BERROCAL IGLESIAS ALFONSO. Datos registrales. T 29319 , F 188, S 8, H M 527771, I/A 31(13.11.17).
18 de Octubre de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: SCHOOFS CHRISTOPH. Datos registrales. T 29319 , F 186, S 8, H M 527771, I/A 30 (10.10.17).
14 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: SOLER RUIZ BOADA MIGUEL;FERNANDEZ BARBE SAGRARIO. Datos registrales. T 29319 , F184, S 8, H M 527771, I/A 29 ( 4.08.17).
27 de Julio de 2017Revocaciones. Apoderado: RUIZ SAN JUAN GUILLERMO;PALAO TIRADO YAGO;ESPA脩A CONTRERAS ANTONIO. Datosregistrales. T 29319 , F 184, S 8, H M 527771, I/A 28 (20.07.17).
05 de Julio de 2017Cambio de objeto social. Vigilancia y protecci贸n de bienes, establecimientos, espect谩culos, cert谩menes o convenciones. Datosregistrales. T 29319 , F 183, S 8, H M 527771, I/A 27 (27.06.17).
21 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA PRIETO ALVARO. Datos registrales. T 29319 , F 182, S 8, H M 527771, I/A 26 (10.03.17).
17 de Febrero de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 500.002,00 Euros. Datos registrales. T 29319 , F 182, S 8, H M527771, I/A 25 (10.02.17).
03 de Agosto de 2016Otros conceptos: SUBSANACION DE LA ESCRITURA AUTORIZADA POR LA NOTARIO DE MADRID, D陋 ELOISA LOPEZ-MONISGALLEGO, EL DIA 04.04.2016, CON EL NUM. 526 DE SU PROTOCOLO, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 22陋, EN CUANTO ALLIMITE DE LA ACTUACION MANCOMUNADA DEL APODERADO D. ANTONIO ESPA脩A CONTRERAS. Datos registrales. T 29319, F 181, S 8, H M 527771, I/A 24 (22.07.16).
20 de Mayo de 2016Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-. Cambio de objeto social. 1. La realizaci贸n de los siguientesservicios y actividades, directa o indirectamente, mediante la participaci贸n en cualesquiera otras sociedades o empresas de objetoid茅ntico o an谩logo, con sujeci贸n a la legislaci贸n aplicable en cada caso. Datos registrales. T 29319 , F 181, S 8, H M 527771, I/A 23(11.05.16).
26 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 29319 , F 179, S 8, H M 527771, I/A 21(15.04.16).
Nombramientos. Apoderado: ESPA脩A CONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T 29319 , F 179, S 8, H M 527771, I/A 22(18.04.16).
04 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA JOSE ANGEL;DOMINGUEZ PEREZ DIEGO MARIA. Datos registrales. T 29319 , F179, S 8, H M 527771, I/A 20 (26.02.16).
05 de Febrero de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ GONZALEZ LEONARDO EZEQUIEL. Datos registrales. T 29319 , F 178, S 8, H M527771, I/A 19 (28.01.16).
30 de Diciembre de 2015Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: PROSEGUR GLOBAL ALARMAS SL. Datos registrales. T 29319 ,F 178, S 8, H M 527771, I/A 18 (21.12.15).
28 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: MU脩OZ VALDES RAFAEL. Datos registrales. T 29319 , F 176, S 8, H M 527771, I/A 17 (18.12.15).
27 de Noviembre de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 500.001,00 Euros. Datos registrales. T 29319 , F 175, S 8, H M527771, I/A 16 (20.11.15).