Buscador CIF Logo

Actos BORME Prosegur Soluciones Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Prosegur Soluciones Sa

Actos BORME Prosegur Soluciones Sa - A82693391

Tenemos registrados 95 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Prosegur Soluciones Sa con CIF A82693391

🔙 Perfil de Prosegur Soluciones Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Prosegur Soluciones Sa

15 de Diciembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: PEREA ARRANZ PEDRO PABLO. Datos registrales. T 41739 , F 215, S 8, H M 259373, I/A 165 (9.12.23).

30 de Octubre de 2023
Revocaciones. Apoderado: LUZON SANCHEZ JOSE;LOPEZ TOUZON JAVIER;SANTISTEBAN LOPEZ JUAN MARCOS;GODO YGARDA ALEXIX;MONTERO DE BLAS LAURA. Apo.Sol.: GARCIA AGUSTIN JUAN ANDRES;LOPEZ MASCARAQUE FRANCISCOJAVIER. Apoderado: GARCIA GARCIA JOSE ANGEL;BLANCO ORTIZ FABIAN;SUAREZ CANTON NICOLAS. Apo.Man.Soli:RODRIGUEZ COCA GERARDO;GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO. Datos registrales. T 41739 , F 215, S 8, H M 259373, I/A 164(23.10.23).

27 de Julio de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: RUBIO MERINO ANTONIO. Apoderado: RUBIO MERINO ANTONIO;RUBIO MERINO ANTONIO.Apo.Manc.: RUBIO MERINO ANTONIO;RUBIO MERINO ANTONIO. Apoderado: RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T41739 , F 215, S 8, H M 259373, I/A 163 (20.07.23).

08 de Junio de 2023
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ SEDANO MAITE;GARCIA PRIETO ALVARO;RUBIO MERINO ANTONIO. Datosregistrales. T 41739 , F 213, S 8, H M 259373, I/A 162 ( 1.06.23).

17 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apoderado: GARCIA GARCIA JOSE ANGEL. Datos registrales. T 41739 , F 213, S 8, H M 259373, I/A 161 (9.05.23).

21 de Abril de 2023
Revocaciones. Apoderado: COZAR EIROA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 41739 , F 213, S 8, H M 259373, I/A 160(14.04.23).

04 de Abril de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA MATEOS ANGEL. Datos registrales. T 41739 , F 212, S 8, H M 259373, I/A 158 (28.03.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANZ LOSADA JOSE MARIA. Datos registrales. T 41739 , F 212, S 8, H M 259373, I/A 159(28.03.23).

23 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apoderado: COZAR EIROA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 41739 , F 212, S 8, H M 259373, I/A 157(16.02.23).

21 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ JIMENEZ FRUCTUOSO. Datos registrales. T 41739 , F 211, S 8, H M 259373, I/A 156(14.02.23).

30 de Enero de 2023
Ceses/Dimisiones. Representan: GARCIA LOPEZ ENRIQUE. Nombramientos. Representan: SALDAÑA DIAZ FERNANDO.Datos registrales. T 41739 , F 211, S 8, H M 259373, I/A 155 (23.01.23).

19 de Enero de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN DONAIRE FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 41739 , F 210, S 8, H M 259373, I/A154 (12.01.23).

11 de Enero de 2023
Revocaciones. Apoderado: REINA CANO EMILIO. Apo.Man.Soli: REINA CANO EMILIO. Datos registrales. T 41739 , F 210, S 8, HM 259373, I/A 153 ( 3.01.23).

23 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: COUTO FARIA GONCALVES PAULO ALEXANDRE. Datos registrales. T 41739 , F 209, S 8, H M259373, I/A 152 (16.12.22).

20 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: COUTO FARIA GONCALVES PAULO ALEXANDRE. Datos registrales. T 41739 , F 208, S 8, H M259373, I/A 151 (13.12.22).

14 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ JAIME BORJA. Datos registrales. T 41739 , F 208, S 8, H M 259373, I/A 150 ( 5.12.22).

28 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 41739 , F 208, S 8, H M 259373, I/A 149 (21.11.22).

07 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: TEJEDOR TRANCA MARIA DOLORES. Datos registrales. T 41739 , F 207, S 8, H M 259373, I/A 148(28.10.22).

18 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR. Apoderado: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR. Datosregistrales. T 41739 , F 207, S 8, H M 259373, I/A 147 (10.10.22).

06 de Octubre de 2022
Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 41739 , F 207, S 8, H M 259373, I/A 146 (29.09.22).

02 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apoderado: BENEDICTE MONET LAURA. Datos registrales. T 41739 , F 205, S 8, H M 259373, I/A 145(26.07.22).

12 de Julio de 2022
Otros conceptos: Se ratifica el poder que causó la inscripción 136ª y se inscribe su facultad 53.- Datos registrales. T 41739 , F 205,S 8, H M 259373, I/A 144 ( 5.07.22).

30 de Mayo de 2022
Revocaciones. Apoderado: ULLOA DELGADO GUILLERMO. Datos registrales. T 41739 , F 205, S 8, H M 259373, I/A 143(23.05.22).

26 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apoderado: SOBRINO POUSA DIEGO. Datos registrales. T 41739 , F 205, S 8, H M 259373, I/A 142 (19.05.22).

13 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANTOS IGLESIAS ALBERTO. Datos registrales. T 41739 , F 204, S 8, H M 259373, I/A 141 (6.05.22).

14 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apoderado: DIGON MARTINEZ ALEX. Datos registrales. T 41739 , F 203, S 8, H M 259373, I/A 140 ( 7.03.22).

24 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: SAAVEDRA LLANO JULIO. Apoderado: SAAVEDRA LLANO JULIO. Datos registrales. T 41739 , F 203, S8, H M 259373, I/A 139 (17.02.22).

26 de Octubre de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LANZUELA DE ALVARO FRANCISCO. Datos registrales. T 41739 , F 203, S 8, H M 259373, I/A 138(19.10.21).

25 de Octubre de 2021
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS SL. Datos registrales. T41739 , F 203, S 8, H M 259373, I/A 137 (18.10.21).

22 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABRERIZO BARRERA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 41739 , F 200, S 8, H M259373, I/A 136 (15.10.21).

15 de Octubre de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LANZUELA DE ALVARO FRANCISCO. Nombramientos. Adm. Unico: MOVISTAR PROSEGURALARMAS SL. Representan: GARCIA LOPEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 41739 , F 200, S 8, H M 259373, I/A 135 ( 7.10.21).

14 de Octubre de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: RENTEA RENTEA DIANA. Datos registrales. T 42261 , F 199, S 8, H M 259373, I/A 134 ( 6.10.21).

04 de Agosto de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 34350 , F 199, S 8, H M 259373, I/A 133(28.07.21).

14 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ DE COS ANDRES;ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA;LOZANO SANCHEZALBERTO;DIAZ HERVAS PEDRO. Datos registrales. T 34350 , F 198, S 8, H M 259373, I/A 132 ( 7.05.21).

12 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Otros conceptos: HA CAUSADO BAJA EL PODER CONFERIDOA DOÑA MARTA ERMITAS MALLO FERNANDEZ EL 20 DE ENERO DE 2021, POR HABER SIDO OTORGADO POR ERROR. Datosregistrales. T 34350 , F 197, S 8, H M 259373, I/A 131 ( 5.05.21).

04 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GESTAL LOPEZ DAVID JOSE. Datos registrales. T 34350 , F 197, S 8, H M 259373, I/A 130(26.04.21).

30 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Datos registrales. T 34350 , F 196, S 8, H M 259373, I/A 129(23.03.21).

19 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ DE COS ANDRES;ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA. Datos registrales. T 34350 ,F 195, S 8, H M 259373, I/A 128 (12.02.21).

17 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apoderado: MONTALBAN BELLOSO BELEN. Datos registrales. T 34350 , F 194, S 8, H M 259373, I/A 127(10.02.21).

05 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apoderado: COZAR EIROA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 34350 , F 194, S 8, H M 259373, I/A 126(29.01.21).

15 de Enero de 2021
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 34350 , F 194, S 8, H M 259373, I/A 125 ( 8.01.21).

15 de Diciembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ MARTINEZ MANUEL FRANCISCO;MURGA APRAIZ PEDRO IGNACIO. Datos registrales.T 34350 , F 193, S 8, H M 259373, I/A 124 ( 4.12.20).

09 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR;ULLOA DELGADO GUILLERMO. Datos registrales. T 34350 ,F 193, S 8, H M 259373, I/A 123 (30.11.20).

03 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: PEDRAZA LAYNEZ MARIA DEL MAR;RENTEA RENTEA DIANA. Datos registrales. T 34350 , F 192, S8, H M 259373, I/A 122 (26.11.20).

23 de Noviembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ VALLEJO MARCO ANTONIO. Datos registrales. T 34350 , F 192, S 8, H M 259373, I/A 121(16.11.20).

26 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: GUILLAMON CARNENERO ALEJANDRO. Datos registrales. T 34350 , F 191, S 8, H M 259373, I/A 120(19.10.20).

24 de Julio de 2020
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ SEDANO MAITE. Datos registrales. T 34350 , F 190, S 8, H M 259373, I/A 119(17.07.20).

09 de Junio de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA SL. Representan: LANZUELA DE ALVARO FRANCISCO.Nombramientos. Adm. Unico: LANZUELA DE ALVARO FRANCISCO. Datos registrales. T 34350 , F 187, S 8, H M 259373, I/A 114( 2.06.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA PRIETO ALVARO;ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA;LOZANO SANCHEZALBERTO;SANCHEZ DE COS ANDRES;DIAZ HERVAS PEDRO;ZAHARIEVA ZORINA. Apo.Manc.: RUBIO MERINOANTONIO;ZAHARIEVA ZORINA;DIAZ HERVAS PEDRO;SANCHEZ DE COS ANDRES;LOZANO SANCHEZ ALBERTO;ERMITASMALLO FERNANDEZ MARTA;GARCIA PRIETO ALVARO. Datos registrales. T 34350 , F 187, S 8, H M 259373, I/A 115 ( 2.06.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA;SANCHEZ DE COS ANDRES. Datos registrales. T 34350 , F189, S 8, H M 259373, I/A 116 ( 2.06.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: BERRAL REINA FRANCISCO JOSE. Apo.Manc.: BERRAL REINA FRANCISCO JOSE. Datosregistrales. T 34350 , F 189, S 8, H M 259373, I/A 117 ( 2.06.20).

Revocaciones. Apoderado: PEÑA MELLADO ROBERTO. Apo.Sol.: PEÑA MELLADO ROBERTO. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZPORTAL MARIA GEMA. Apo.Man.Soli: MUÑOZ VALDES RAFAEL. Apoderado: GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO. Apo.Man.Soli:GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO. Datos registrales. T 34350 , F 190, S 8, H M 259373, I/A 118 ( 2.06.20).

23 de Marzo de 2020
Revocaciones. Apoderado: CASASECA USERO ISRAEL. Datos registrales. T 34350 , F 187, S 8, H M 259373, I/A 113 (16.03.20).

02 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apoderado: HUERTA SANCHEZ DAVID. Datos registrales. T 34350 , F 185, S 8, H M 259373, I/A 112 (24.02.20).

20 de Febrero de 2020
Fe de erratas: Se publicó por error en la Inscripción 76ª el nombramiento como APODERADO de MELENDEZ VALDES MUÑOZRAFAEL, siendo lo correcto MUÑOZ VALDES RAFAEL. Datos registrales. T 27002 , F 77, S 8, H M 259373, I/A 76 (18.12.15).

09 de Agosto de 2019
Revocaciones. Apoderado: CHECA SAENZ JOSE;GUTIERREZ GONZALEZ LEONARDO EZEQUIEL. Apo.Sol.: BAIDEZ SIMONOSCAR RAFAEL. Datos registrales. T 34350 , F 184, S 8, H M 259373, I/A 111 ( 2.08.19).

25 de Julio de 2019
Nombramientos. Apoderado: BASTIDA MARTIN DANIEL. Datos registrales. T 34350 , F 184, S 8, H M 259373, I/A 110 (17.07.19).

05 de Julio de 2019
Revocaciones. Apoderado: ALAMINOS BAENA EDUARDO. Datos registrales. T 34350 , F 184, S 8, H M 259373, I/A 109(28.06.19).

12 de Junio de 2019
Nombramientos. Apoderado: PEREA ARRANZ PEDRO PABLO. Datos registrales. T 34350 , F 181, S 8, H M 259373, I/A 107 (5.06.19).

Nombramientos. Apoderado: SANTOS IGLESIAS ALBERTO. Datos registrales. T 34350 , F 184, S 8, H M 259373, I/A 108 (5.06.19).

28 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: REINA CANO EMILIO;GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO;GONZALEZ JIMENEZ FRUCTUOSO.Datos registrales. T 34350 , F 180, S 8, H M 259373, I/A 106 (20.11.18).

27 de Septiembre de 2018
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 34350 , F 180, S 8, H M 259373, I/A 105 (20.09.18).

03 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GIL MATAIX RAMON. Datos registrales. T 34350 , F 179, S 8, H M 259373, I/A 103 (27.08.18).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ BARBE SAGRARIO. Apoderado: FERNANDEZ BARBE SAGRARIO. Datos registrales.T 34350 , F 180, S 8, H M 259373, I/A 104 (27.08.18).

06 de Junio de 2018
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS. Datos registrales. T 34350 , F 178, S 8, H M 259373, I/A 102(30.05.18).

10 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONZON HIDALGO ENRIQUE CARLOS. Datos registrales. T 34350 , F 177, S 8, H M 259373, I/A101 ( 3.05.18).

21 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: COZAR EIROA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 34350 , F 177, S 8, H M 259373, I/A 100(13.12.17).

20 de Noviembre de 2017
Otros conceptos: Mediante diligencia presentada, se modifica el segundo apellido del apoderado, siendo su nombre correctocompleto, DON JULIO SAAVEDRA LLANO. Datos registrales. T 34350 , F 177, S 8, H M 259373, I/A 99 ( 8.11.17).

31 de Octubre de 2017
Nombramientos. Apoderado: SCHOOFS CHRISTOPH. Apo.Manc.: RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 34350 , F 176,S 8, H M 259373, I/A 98 (20.10.17).

25 de Octubre de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ORTIZ VAZQUEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 34350 , F 175, S 8, H M 259373, I/A 97(17.10.17).

28 de Septiembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ESPAÑA CONTRERAS ANTONIO;LANZUELA DE ALVARO FRANCISCO. Nombramientos.Adm. Unico: PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA SL. Representan: LANZUELA DE ALVARO FRANCISCO. Otros conceptos: Cambiodel Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único. Datos registrales. T 34350 , F 175, S 8, H M

26 de Septiembre de 2017
Modificaciones estatutarias. APROBACION DE UN NUEVO TEXTO DE LOS ESTATUOS. Datos registrales. T 34350 , F 172, S 8,H M 259373, I/A 95 (19.09.17).

11 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: MONZON HIDALGO ENRIQUE-CARLOS. Datos registrales. T 34350 , F 172, S 8, H M 259373, I/A94 ( 1.09.17).

24 de Agosto de 2017
Nombramientos. Apoderado: SAAVEDRA LLANA JULIO. Datos registrales. T 34350 , F 171, S 8, H M 259373, I/A 93 ( 9.08.17).

18 de Julio de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GUT REVOREDO CHRISTIAN. Apoderado: VELAZQUEZ BARROSO JUAN. Apo.Man.Soli: ESPAÑACONTRERAS ANTONIO. Apoderado: ESPAÑA CONTRERAS ANTONIO;ESPAÑA CONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T34350 , F 171, S 8, H M 259373, I/A 92 (10.07.17).

22 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: SAAVEDRA LLANA JULIO. Datos registrales. T 34350 , F 171, S 8, H M 259373, I/A 91 (13.03.17).

21 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA PRIETO ALVARO. Datos registrales. T 34350 , F 169, S 8, H M 259373, I/A 90 (10.03.17).

08 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LANZUELA DE ALVARO FRANCISCO. Datos registrales. T 34350 , F 168, S 8, H M 259373, I/A 89(28.02.17).

16 de Febrero de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO. Datos registrales. T 34350 , F 167, S 8, H M 259373, I/A 88 (8.02.17).

05 de Septiembre de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: ABAD SANZ RUTH. Datos registrales. T 34350 , F 167, S 8, H M 259373, I/A 87 (26.08.16).

03 de Agosto de 2016
Otros conceptos: SUBSANACION DE LA ESCRITURA AUTORIZADA POR LA NOTARIO DE MADRID, Dª ELOISA LOPEZ-MONISGALLEGO, EL DIA 04.04.2016, CON EL NUM. 526 DE SU PROTOCOLO, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 82ª, EN CUANTO ALLIMITE DE LA ACTUACION MANCOMUNADA DEL APODERADO D. ANTONIO ESPAÑA CONTRERAS. Datos registrales. T 34350, F 167, S 8, H M 259373, I/A 86 (22.07.16).

26 de Julio de 2016
Nombramientos. Apoderado: GRANDE PARDO ENRIQUE PEDRO. Datos registrales. T 34350 , F 166, S 8, H M 259373, I/A 85(15.07.16).

22 de Junio de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: BAIDEZ SIMON OSCAR RAFAEL. Datos registrales. T 34350 , F 166, S 8, H M 259373, I/A 84(14.06.16).

20 de Mayo de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ENRIQUE ALONSO ENRIQUE. Datos registrales. T 34350 , F 166, S 8, H M 259373, I/A 83(12.05.16).

26 de Abril de 2016
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 27002 , F 81, S 8, H M 259373, I/A 81(15.04.16).

Nombramientos. Apoderado: ESPAÑA CONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T 27002 , F 81, S 8, H M 259373, I/A 82(18.04.16).

04 de Marzo de 2016
Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA JOSE ANGEL;DOMINGUEZ PEREZ DIEGO MARIA. Datos registrales. T 27002 , F80, S 8, H M 259373, I/A 80 (26.02.16).

05 de Febrero de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ENRIQUE ALONSO ENRIQUE. Datos registrales. T 27002 , F 80, S 8, H M 259373, I/A 79(28.01.16).

03 de Febrero de 2016
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: PROSEGUR GLOBAL ALARMAS ROW SL. Datos registrales. T27002 , F 79, S 8, H M 259373, I/A 78 (19.01.16).

30 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: ESPAÑA CONTRERAS ANTONIO. Datos registrales. T 27002 , F 78, S 8, H M 259373, I/A 77(21.12.15).

28 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MELENDEZ VALDES MUÑOZ RAFAEL. Datos registrales. T 27002 , F 77, S 8, H M 259373, I/A 76(18.12.15).

18 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 27002 , F 74, S 8, H M 259373, I/A 74 (11.12.15).

Nombramientos. Apoderado: MURGA APRAIZ PEDRO IGNACIO. Datos registrales. T 27002 , F 76, S 8, H M 259373, I/A 75(11.12.15).

09 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ GONZALEZ LEONARDO EZEQUIEL. Datos registrales. T 27002 , F 74, S 8, H M259373, I/A 73 (30.11.15).

03 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: BLAZQUEZ HERNANDEZ OSCAR SALVADOR. Datos registrales. T 27002 , F 73, S 8, H M 259373,I/A 72 (25.11.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información