Actos BORME de Prosnor Xxi Sa
21 de Enero de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: CALDES LLOPIS MIGUEL ANGEL. Presidente: CALDES LLOPIS MIGUEL ANGEL. Consejero:SCALS SICHAR MARIA DE LOS ANGELES;MARTIN DEL MORAL BEATRIZ;CALDES LLOPIS JUAN;CANADELL FERNANDEZ JUANLUIS;SARASOLA SANCHO FERNANDO. Con.Delegado: CANADELL FERNANDEZ JUAN LUIS. SecreNoConsj: LINARES SEIRUL-LO MARIA CINTA. Nombramientos. Liquidador: URIOL REGALES JOSEP MARIA. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datosregistrales. T 22449 , F 33, S 8, H M 261395, I/A 17 (11.01.13).
13 de Noviembre de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 360.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.240.000,00 Euros. Datos registrales. T 22449 ,F 32, S 8, H M 261395, I/A 16 (30.10.12).
22 de Mayo de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.600.000,00 Euros. Datos registrales. T 22449, F 31, S 8, H M 261395, I/A 15 ( 9.05.12).
15 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: JIMENEZ APARICIO EMILIO. Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ APARICIO EMILIO.Nombramientos. SecreNoConsj: LINARES SEIRUL-LO MARIA CINTA. Datos registrales. T 22449 , F 31, S 8, H M 261395, I/A 14 (5.04.11).
15 de Febrero de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 400.000,00 Euros. Desembolsado: 400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.000.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 4.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 22449 , F 30, S 8, H M 261395, I/A 13 ( 4.02.10).
09 de Febrero de 2010Reelecciones. Consejero: CALDES LLOPIS MIGUEL ANGEL. Presidente: CALDES LLOPIS MIGUEL ANGEL. Consejero: SCALSSICHAR MARIA DE LOS ANGELES;MARTIN DEL MORAL BEATRIZ;CALDES LLOPIS JUAN;CANADELL FERNANDEZ JUANLUIS;SARASOLA SANCHO FERNANDO. Con.Delegado: CANADELL FERNANDEZ JUAN LUIS. SecreNoConsj: JIMENEZ APARICIOEMILIO. Datos registrales. T 22449 , F 29, S 8, H M 261395, I/A 12 (29.01.10).