Buscador CIF Logo

Actos BORME Proteccion De La Naturaleza Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Proteccion De La Naturaleza Sa

Actos BORME Proteccion De La Naturaleza Sa - A79331153

Tenemos registrados 12 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Proteccion De La Naturaleza Sa con CIF A79331153

馃敊 Perfil de Proteccion De La Naturaleza Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Proteccion De La Naturaleza Sa

24 de Enero de 2014
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 22074 , F 203, S 8, H M 99578, I/A 86 (14.01.14).

06 de Junio de 2013
Reelecciones. Consejero: LIDTH DE JEUDE ALAIN VAN. Datos registrales. T 22074 , F 202, S 8, H M 99578, I/A 85 (29.05.13).

Otros conceptos: "PROTECCION DE LA NATURALEZA, S.A" CIF A-79331153, inscritaen el Registro Mercantil de Madrid, tomo6098 de la secci贸n8&, folio 173, hoja M-99.578. Datos registrales. T 6098 , F 173, S 8, H M 99578, I/A 26M (29.05.13).

19 de Septiembre de 2011
Reelecciones. Consejero: TRAVESEDO BISBAL JESUS CARLOS. Presidente: TRAVESEDO BISBAL JESUS CARLOS. Datosregistrales. T 22074 , F 202, S 8, H M 99578, I/A 84 ( 6.09.11).

28 de Marzo de 2011
Cambio de domicilio social. AVDA MAR MEDITERRANEO 1 (SAN FERNANDO DE HENARES). Datos registrales. T 22074 , F202, S 8, H M 99578, I/A 83 (15.03.11).

28 de Septiembre de 2010
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: PI脩EL RUBIO AUGUSTO. Secretario: RIVERA ROMERO RAMIRO TOMAS. Nombramientos.Secretario: GAVIRA RUIZ MARIA BELEN. Datos registrales. T 22074 , F 201, S 8, H M 99578, I/A 82 ( 3.09.10).

06 de Mayo de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: EVORA JOSE. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ SANCHEZ ROBERTO. Datos registrales.T 22074 , F 201, S 8, H M 99578, I/A 80 (21.04.09).

Nombramientos. Apoderado: RUIZ LOPEZ JOSE-MANUEL. Datos registrales. T 22074 , F 201, S 8, H M 99578, I/A 81 (21.04.09).

29 de Abril de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: WEBSTER PETER VALENTINE. Datos registrales. T 22074 , F 201, S 8, H M 99578, I/A 78(17.04.09).

Otros conceptos: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACUERDA MODIFICAR EL NUMERODE MIEMBROS DEL CONSEJODE ADMINISTRACION, QUE EN ADELANTE ESTARA COMPUESTO POR UN TOTAL DE TRES MIEMBROS. Datos registrales. T22074 , F 201, S 8, H M 99578, I/A 79 (17.04.09).

16 de Marzo de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: TRAVESEDO BISBAL JESUS CARLOS;EVORA JOSE;GAVIRA RUIZ MARIA BELEN. Datos registrales.T 22074 , F 198, S 8, H M 99578, I/A 76 ( 4.03.09).

Revocaciones. Apoderado: FLOREZ RUIZ ENRIQUE;CARNEROS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER;CARRASCO CORRALESGRACIANO;ALCANTARA GARCIA MIGUEL ANGEL. Apo.Sol.: PINAR HORCAJADA BELEN ALMUDENA;LOPEZ MASCARAQUEMANUEL. Apo.Man.Soli: RIOS MARTINEZ PEDRO;ASENJO LECETA ADOLFO;HERNANDO LEAL MARIA ARANTZAZU;VELASCOALVAREZ MARIA GEMA;MARTIN SERRANO JORGE. Apoderado: ESTEPA SARO ESTHER;ASENJO LECETAADOLFO;HERNANDO LEAL MARIA ARANTZAZU;RIOS MARTINEZ PEDRO;EVORA JOSE. Nombramientos. Apoderado: DIBARTOLO PRISCILA;SANCHEZ SANCHEZ ROBERTO;MIGUEL MAZO MARIA VICTORIA;ESTELRICH IZQUIERDO MIGUEL. Datosregistrales. T 22074 , F 199, S 8, H M 99578, I/A 77 ( 4.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n