Buscador CIF Logo

Actos BORME Proteccion De Patrimonios Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Proteccion De Patrimonios Sa

Actos BORME Proteccion De Patrimonios Sa - A61486981

Tenemos registrados 31 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Proteccion De Patrimonios Sa con CIF A61486981

🔙 Perfil de Proteccion De Patrimonios Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Proteccion De Patrimonios Sa

27 de Septiembre de 2022
Nombramientos. ADM.UNICO: RIGOL GORGA EDUARD. Datos registrales. T 45232 , F 13, S 8, H B 173462, I/A 64 (20.09.22).

04 de Febrero de 2022
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: VALLCORBA PLANA MAGI. AUDITOR SUP.: NORBERTO BAYONA ENRIC. Datos registrales.T 45232 , F 13, S 8, H B 173462, I/A 63 (28.01.22).

22 de Diciembre de 2020
Revocaciones. APOD.MANCOMU: SEGARRA PONS MARIA EVA. APOD.SOL/MAN: SEGARRA PONS MARIA EVA. Datosregistrales. T 45232 , F 12, S 8, H B 173462, I/A 61 (10.12.20).

Nombramientos. APOD.SOL/MAN: ANDRADA SANCHEZ RICARD. Datos registrales. T 45232 , F 12, S 8, H B 173462, I/A 62(10.12.20).

29 de Enero de 2019
Nombramientos. AUDITOR TIT.: VALLCORBA PLANA MAGI. AUDITOR SUP.: NORBERTO BAYONA ENRIC. Datos registrales. T45232 , F 12, S 8, H B 173462, I/A 60 (22.01.19).

25 de Julio de 2018
Revocaciones. APOD.SOL/MAN: KORTAZAR HERNANDEZ ZIGOR. Datos registrales. T 45232 , F 12, S 8, H B 173462, I/A 59(17.07.18).

22 de Mayo de 2018
Revocaciones. APOD.SOL/MAN: DE PABLO NAVARRO JAVIER. Datos registrales. T 45232 , F 11, S 8, H B 173462, I/A 57(11.05.18).

Nombramientos. APODERAD.SOL: KORTAZAR HERNANDEZ ZIGOR. Datos registrales. T 45232 , F 11, S 8, H B 173462, I/A 58(11.05.18).

22 de Marzo de 2018
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: SEGARRA PONS MARIA EVA. Datos registrales. T 45232 , F 11, S 8, H B 173462, I/A 56(14.03.18).

28 de Diciembre de 2017
Nombramientos. ADM.UNICO: RIGOL GORGA EDUARDO. Datos registrales. T 45232 , F 10, S 8, H B 173462, I/A 55 (14.12.17).

17 de Mayo de 2017
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: NAVARRO SAMA JESUS CARLOS. Datos registrales. T 45232 , F 10, S 8, H B 173462, I/A 53( 5.05.17).

Revocaciones. APOD.SOL/MAN: LOPEZ COLOMINAS DAVID. Datos registrales. T 45232 , F 10, S 8, H B 173462, I/A 54 (5.05.17).

07 de Julio de 2016
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: KORTAZAR HERNANDEZ ZIGOR. Datos registrales. T 45232 , F 9, S 8, H B 173462, I/A 52(29.06.16).

22 de Junio de 2016
Revocaciones. APODERAD.SOL: DOMINGUEZ GOMEZ CRISTINA MARIA;DOMINGUEZ GOMES CRISTINA MARIA. Datosregistrales. T 45232 , F 9, S 8, H B 173462, I/A 51 (10.06.16).

18 de Mayo de 2016
Revocaciones. APOD.SOL/MAN: MUÑIZ ALVAREZ MANUEL. APODERAD.SOL: MUÑIZ ALVAREZ MANUEL. APOD.SOL/MAN:ARCE VALLE JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 45232 , F 9, S 8, H B 173462, I/A 50 ( 6.05.16).

03 de Marzo de 2016
Cambio de domicilio social. RD JEAN MONNET 248-252 BAJOS (SABADELL). Datos registrales. T 45232 , F 8, S 8, H B 173462,I/A 49 (24.02.16).

29 de Octubre de 2015
Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ GOMEZ JAVIER. Datos registrales. T 21886 , F 219, S 8, H M 346880, I/A 39 (22.10.15).

17 de Octubre de 2014
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ GOMEZ JAVIER. Datos registrales. T 21886 , F 219, S 8, H M 346880, I/A 38 ( 9.10.14).

13 de Agosto de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ COLOMINAS DAVID. Datos registrales. T 21886 , F 218, S 8, H M 346880, I/A 36 (4.08.14).

07 de Mayo de 2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MAHADEVA MORROS RENE. Datos registrales. T 21886 , F 218, S 8, H M 346880, I/A 35(28.04.14).

17 de Mayo de 2013
Ampliacion del objeto social. PROTECCION DE PERSONAS DETERMINADAS PREVIA LA AUTORIZACIONCORRESPONDIENTE. Datos registrales. T 21886 , F 218, S 8, H M 346880, I/A 34 ( 9.05.13).

06 de Marzo de 2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RIGOL GORGA EDUARD. Nombramientos. Adm. Unico: RIGOL GORGA EDUARD. Datosregistrales. T 21886 , F 218, S 8, H M 346880, I/A 33 (26.02.13).

14 de Febrero de 2012
Nombramientos. Apoderado: DE PABLO NAVARRO JAVIER. Datos registrales. T 21886 , F 217, S 8, H M 346880, I/A 32 (3.02.12).

12 de Abril de 2011
Nombramientos. Apoderado: DOMINGUEZ GOMEZ CRISTINA MARIA. Datos registrales. T 21886 , F 216, S 8, H M 346880, I/A 31(30.03.11).

13 de Septiembre de 2010
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MAHADEVA MORROS RENE. Datos registrales. T 21886 , F 215, S 8, H M 346880, I/A 30(26.08.10).

07 de Julio de 2010
Nombramientos. Auditor: VALLCORBA PLANA MAGI. Aud.Supl.: NORBERTO BAYONA ENRIC. Datos registrales. T 21886 , F214, S 8, H M 346880, I/A 28 (25.06.10).

Nombramientos. Apoderado: FERRAN BAYES RICARD. Datos registrales. T 21886 , F 215, S 8, H M 346880, I/A 29 (25.06.10).

08 de Abril de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: TORTOSA PAPASEIT MIREIA. Datos registrales. T 21886 , F 214, S 8, H M 346880, I/A 26 (24.03.10).

Revocaciones. Apo.Manc.: ALONSO MARTINEZ JAVIER. Datos registrales. T 21886 , F 214, S 8, H M 346880, I/A 27 (24.03.10).

31 de Julio de 2009
Nombramientos. Apoderado: ARCE VALLE JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 21886 , F 213, S 8, H M 346880, I/A 25(22.07.09).

19 de Junio de 2009
Revocaciones. Apoderado: ERRAIZ ALONSO LUIS MARIA;ERRAIZ ALONSO LUIS MARIA. Datos registrales. T 21886 , F 213, S8, H M 346880, I/A 24 ( 5.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información