Buscador CIF Logo

Actos BORME Provisur General Ship Chandler Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Provisur General Ship Chandler Sl

Actos BORME Provisur General Ship Chandler Sl - B21502307

Tenemos registrados 42 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Provisur General Ship Chandler Sl con CIF B21502307

馃敊 Perfil de Provisur General Ship Chandler Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Provisur General Ship Chandler Sl

27 de Octubre de 2020
Revocaciones. REP.ADM.CONC: GRAS SAGRERA JORDI. Nombramientos. REP.ADM.CONC: FERNANDEZ BOZAL MARIA DELPILAR. Otros conceptos: JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSOVOLUNTARIO 470/2015, FIRME DE FECHA 09/07/2020,CESE Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE PERSONA FISICA DELADMINISTRADOR CONCURSAL. Datos registrales. T 44280 , F 213, S 8, H B 423210, I/A 42 (20.10.20).

17 de Octubre de 2016
Revocaciones. ADM.UNICO: SUNET GUTIERREZ JUAN. Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA,PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 470/2015, AUTOS FIRMES DE FECHAS: 25/04/2016, APERTURA DE LA FASE DELIQUIDACION LA SOCIEDAD Y 6/07/2016, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION. Disoluci贸n. Judicial. Datos registrales. T44280 , F 212, S 8, H B 423210, I/A 41 ( 7.10.16).

21 de Julio de 2015
Nombramientos. ADM.CONCURS.: ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP. REP.ADM.CONC: GRAS SAGRERA JORDI. Otrosconceptos: JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 470/2015,AUTO FIRME DE FECHA 02/06/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO. Datos registrales. T 44280 , F 211, S 8, H B423210, I/A 40 (14.07.15).

11 de Junio de 2015
Revocaciones. APODERAD.SOL: GUASCH REPULLES GLORIA. APODERADO: ALVAREZ ESPINOSA TEODORO. Datosregistrales. T 44280 , F 211, S 8, H B 423210, I/A 39 ( 3.06.15).

23 de Febrero de 2015
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ABANTE PICH AUDITORES SLP. Datos registrales. T 44280 , F 211, S 8, H B 423210, I/A 38(13.02.15).

29 de Diciembre de 2014
Revocaciones. APODERADO: PEREZ CUADRA JUAN. Datos registrales. T 44280 , F 211, S 8, H B 423210, I/A 37 (18.12.14).

03 de Noviembre de 2014
Revocaciones. APODERAD.SOL: GARCIA VALES ISMAEL ORLANDO. Datos registrales. T 44280 , F 211, S 8, H B 423210, I/A 36(24.10.14).

01 de Abril de 2014
Nombramientos. APODERAD.SOL: GUASCH REPULLES GLORIA. Datos registrales. T 43352 , F 60, S 8, H B 423210, I/A 34(24.03.14).

Revocaciones. APODERADO: CALERO GUTIERREZ ANTONIO. Datos registrales. T 44280 , F 211, S 8, H B 423210, I/A 35(24.03.14).

14 de Marzo de 2014
Nombramientos. APODERAD.SOL: CANO RIVAS JUAN MANUEL. Datos registrales. T 43352 , F 60, S 8, H B 423210, I/A 33 (6.03.14).

26 de Febrero de 2014
Revocaciones. CONSEJERO: BOTELLO HERNANDEZ ENRIQUE JAVIER. PRESIDENTE: BOTELLO HERNANDEZ ENRIQUEJAVIER. CONSEJERO: BOTELLO HERNANDEZ SERGIO;SUNET GUTIERREZ JUAN. SECRETARIO: SUNET GUTIERREZ JUAN.CONS. DELEG.: SUNET GUTIERREZ JUAN. Nombramientos. ADM.UNICO: SUNET GUTIERREZ JUAN. Datos registrales. T43352 , F 59, S 8, H B 423210, I/A 30 (12.02.14).

20 de Febrero de 2014
Revocaciones. APODERADO: GARCIA VALES ISMAEL ORLANDO. Datos registrales. T 43352 , F 59, S 8, H B 423210, I/A 31(12.02.14).

Nombramientos. APODERAD.SOL: GARCIA VALES ISMAEL ORLANDO. Datos registrales. T 43352 , F 59, S 8, H B 423210, I/A32 (12.02.14).

17 de Enero de 2014
Revocaciones. APODERADO: BOTELLO HERNANDEZ ENRIQUE JAVIER. Datos registrales. T 43352 , F 59, S 8, H B 423210, I/A29 ( 9.01.14).

27 de Agosto de 2013
Otros conceptos: CAMBIO DE SOCIO UNICO.NUEVO SOCIO UNICO:UMUSOL SA. Datos registrales. T 43352 , F 59, S 8, H B423210, I/A 28 (20.08.13).

24 de Junio de 2013
Nombramientos. APODERAD.SOL: PORRAS SALDA脩A SANTIAGO DAVID. Datos registrales. T 43352 , F 58, S 8, H B 423210,I/A 27 (14.06.13).

08 de Marzo de 2013
Nombramientos. APODERADO: MARA脩ON PARDO SANTIAGO. Datos registrales. T 43352 , F 57, S 8, H B 423210, I/A 25(28.02.13).

Nombramientos. APODERADO: CANO RIVAS JUAN MANUEL. Datos registrales. T 43352 , F 58, S 8, H B 423210, I/A 26(28.02.13).

28 de Febrero de 2013
Nombramientos. APODERADO: GONZALEZ GARCIA JORGE LUIS. Datos registrales. T 43352 , F 56, S 8, H B 423210, I/A 22(21.02.13).

Nombramientos. APODERADO: OCHOA BLANCO YOLANDA. Datos registrales. T 43352 , F 56, S 8, H B 423210, I/A 23(21.02.13).

Nombramientos. APODERADO: GONZALEZ VENERAS JAVIER. Datos registrales. T 43352 , F 57, S 8, H B 423210, I/A 24(21.02.13).

06 de Febrero de 2013
Nombramientos. APODERADO: CARRERAS GONZALEZ ESTHER. Datos registrales. T 43352 , F 55, S 8, H B 423210, I/A 19(30.01.13).

Nombramientos. APODERADO: CARRERAS GONZALEZ ANA. Datos registrales. T 43352 , F 55, S 8, H B 423210, I/A 20(30.01.13).

Nombramientos. APODERADO: GONZALEZ CORDEIRO CARLOS. Datos registrales. T 43352 , F 55, S 8, H B 423210, I/A 21(30.01.13).

28 de Enero de 2013
Modificaciones estatutarias. ART.14:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales.T 43352 , F 54, S 8, H B 423210, I/A 18 (18.01.13).

19 de Noviembre de 2012
Nombramientos. APODERADO: CALERO GUTIERREZ ANTONIO. Datos registrales. T 43352 , F 54, S 8, H B 423210, I/A 17 (6.11.12).

05 de Octubre de 2012
Nombramientos. APODERADO: LOPETEGUI LOGARTE MARIA JESUS. Datos registrales. T 43352 , F 52, S 8, H B 423210, I/A 14(26.09.12).

Nombramientos. APODERADO: GARCIA VALES ISMAEL ORLANDO. Datos registrales. T 43352 , F 52, S 8, H B 423210, I/A 15(26.09.12).

Nombramientos. APODERADO: LASA DORRONSORO JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 43352 , F 53, S 8, H B 423210, I/A 16(26.09.12).

23 de Agosto de 2012
Nombramientos. APODERADO: RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 43352 , F 51, S 8, H B 423210, I/A 12(13.08.12).

Nombramientos. APODERADO: ARES CAMERINO VICTORIA. Datos registrales. T 43352 , F 51, S 8, H B 423210, I/A 13(13.08.12).

08 de Agosto de 2012
Nombramientos. APODERADO: PEREZ CUADRA JUAN. Datos registrales. T 43131 , F 133, S 8, H B 423210, I/A 11 (27.07.12).

25 de Julio de 2012
Nombramientos. APODERADO: FERRE COSERNAU ESMERALDA. Datos registrales. T 43131 , F 132, S 8, H B 423210, I/A 10(16.07.12).

12 de Julio de 2012
Nombramientos. APODERADO: GRAI脩O ORDO脩EZ MARIA DOLORES. Datos registrales. T 43131 , F 132, S 8, H B 423210, I/A9 ( 3.07.12).

11 de Mayo de 2012
Nombramientos. APODERADO: HERNANDEZ CASANOVA FELIPE. Datos registrales. T 43131 , F 131, S 8, H B 423210, I/A 8 (2.05.12).

08 de Mayo de 2012
Nombramientos. APODERADO: ALVAREZ ESPINOSA TEODORO. Datos registrales. T 43131 , F 128, S 8, H B 423210, I/A 5(24.04.12).

Nombramientos. APODERADO: RIVAS SEOANE RAMON. Datos registrales. T 43131 , F 129, S 8, H B 423210, I/A 6 (24.04.12).

Nombramientos. APODERADO: PUIG ESPASA MARTI. Datos registrales. T 43131 , F 130, S 8, H B 423210, I/A 7 (24.04.12).

27 de Abril de 2012
Ampliaci贸n de capital. Capital: 200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 203.010,00 Euros. Cambio de domicilio social. CLENERGIA 15 25 NAVES 1 Y 2 (GAVA). Datos registrales. T 43131 , F 127, S 8, H B 423210, I/A 4 (17.04.12).

16 de Marzo de 2012
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: MANEGA HOLDING SARL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico:BOTELLO HERNANDEZ ENRIQUE JAVIER. Nombramientos. Consejero: BOTELLO HERNANDEZ ENRIQUE JAVIER. Presidente:BOTELLO HERNANDEZ ENRIQUE JAVIER. Consejero: SUNET GUTIERREZ JUAN. Secretario: SUNET GUTIERREZ JUAN.Consejero: BOTELLO HERNANDEZ SERGIO. Con.Delegado: SUNET GUTIERREZ JUAN. Modificaciones estatutarias. Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 956 , F 54, S 8, H H 19364,H , I/ 2.(23.02.12).

Nombramientos. Apoderado: BOTELLO HERNANDEZ ENRIQUE JAVIER. Datos registrales. T 956 , F 54, S 8, H H 19364,H , I/ 3.(23.02.12).

22 de Agosto de 2011
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 15.07.11. Objeto social: El comercio, comercializaci贸n, distribuci贸n, representaci贸n yalmacenaje de toda clase de mercancias ejercido directamente o por cuenta de terceros yen especial la importaci贸n y exportaci贸n detoda clase de productos alimenticios, cigarrillos, bebidas, perfumes y en general cualquier producto desti. Domicilio: MUELL DELEVANTE S/N (HUELVA). Capital: 3.010,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: BOTELLO HERNANDEZENRIQUE JAVIER. Nombramientos. Adm. Unico: BOTELLO HERNANDEZ ENRIQUE JAVIER. Datos registrales. T 956 , F 50, S 8,

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n