Actos BORME de Proyecon Galicia Sa
26 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apoderado: MADRI脩AN JORGE FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 928 , F 97, S 8, H OR 146, I/A 39(18.09.23).
06 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: COBAS PENA ANGEL. Datos registrales. T 928 , F 96, S 8, H OR 146, I/A 37 (27.06.22).
Nombramientos. Apoderado: MADRI脩AN JORGE FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 928 , F 97, S 8, H OR 146, I/A 38(27.06.22).
28 de Abril de 2022Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: COBAS PENA ANGEL. Consejero: COBAS PENA ANGEL. Datos registrales. T 928 , F 96, S 8, HOR 146, I/A 36 (19.04.22).
15 de Febrero de 2022Reelecciones. Auditor: APUMAR AUDITORES SLP. Datos registrales. T 928 , F 96, S 8, H OR 146, I/A 35 ( 9.02.22).
23 de Diciembre de 2021Cambio de objeto social. La construcci贸n, mantenimiento y reparaci贸n de toda clase de obras. Movimientos de tierras, excavacionesen general, perforaciones, desmontes y vaciados, explanaciones, canteras, pozos, galer铆as y t煤neles. La realizaci贸n de cimentacionesespeciales, sondeos, tablestacados, inyecciones y pilotajes. L. Datos registrales. T 928 , F 96, S 8, H OR 146, I/A 34 (13.12.21).
21 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO. Presidente: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO. Consejero:SOTO DIAZ GERMAN. Secretario: SOTO DIAZ GERMAN. Consejero: GONZALEZ RODRIGUEZ FELISINDO;COBAS PENAANGEL;SOTO FERNANDEZ XERMAN ALBERTE. Cons.Del.Sol: COBAS PENA ANGEL;SOTO FERNANDEZ XERMAN ALBERTE.Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO. Presidente: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO. Consejero:SOTO DIAZ GERMAN. Secretario: SOTO DIAZ GERMAN. Consejero: GONZALEZ RODRIGUEZ FELISINDO;SOTO FERNANDEZXERMAN ALBERTE. Cons.Del.Sol: SOTO FERNANDEZ XERMAN ALBERTE. Consejero: COBAS PENA ANGEL. Cons.Del.Sol:COBAS PENA ANGEL. Datos registrales. T 746 , F 160, S 8, H OR 146, I/A 33 ( 9.04.21).
16 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: APUMAR AUDITORES SLP. Datos registrales. T 746 , F 160, S 8, H OR 146, I/A 32 ( 2.01.19).
02 de Octubre de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 3.000.000,00 Euros. Desembolsado: 3.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.600.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 3.600.000,00 Euros. Datos registrales. T 746 , F 159, S 8, H OR 146, I/A 31 (24.09.18).
21 de Agosto de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: SANTOS IGLESIAS JESUS;DIEGUEZ OTERO ALBERTO LUIS. Datos registrales. T 746 , F 159, S 8, HOR 146, I/A 30 ( 1.08.18).
26 de Enero de 2016Nombramientos. Auditor: APUMAR AUDITORES SLP. Datos registrales. T 746 , F 159, S 8, H OR 146, I/A 29 (15.01.16).
23 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO;GONZALEZ RODRIGUEZ FELISINDO;COBAS PENAANGEL;RODRIGUEZ SEGADE JAVIER;SOTO DIAZ GERMAN. Presidente: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO. Cons.Del.Sol:COBAS PENA ANGEL. Secretario: COBAS PENA ANGEL. Cons.Del.Sol: RODRIGUEZ SEGADE JAVIER. Nombramientos.Consejero: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO. Presidente: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO. Consejero: SOTO DIAZ GERMAN.Secretario: SOTO DIAZ GERMAN. Consejero: GONZALEZ RODRIGUEZ FELISINDO;COBAS PENA ANGEL;SOTO FERNANDEZXERMAN ALBERTE. Cons.Del.Sol: COBAS PENA ANGEL;SOTO FERNANDEZ XERMAN ALBERTE. Datos registrales. T 746 , F158, S 8, H OR 146, I/A 28 (12.06.15).
09 de Diciembre de 2013Reelecciones. Auditor: AUDITORES DE FINANZAS ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 746 , F 158, S 8, H OR 146, I/A 27(26.11.13).
04 de Febrero de 2013Reelecciones. Auditor: AUDITORES DE FINANZAS ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 746 , F 158, S 8, H OR 146, I/A 26(23.01.13).
31 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Secretario: SOTO DIAZ GERMAN. Cons.Del.Sol: SOTO DIAZ GERMAN. Nombramientos. Secretario: COBASPENA ANGEL. Cons.Del.Sol: RODRIGUEZ SEGADE JAVIER. Datos registrales. T 746 , F 158, S 8, H OR 146, I/A 25 (21.05.12).
10 de Noviembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO. Presidente: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO. Consejero:SOTO DIAZ GERMAN. Secretario: SOTO DIAZ GERMAN. Consejero: GONZALEZ RODRIGUEZ FELISINDO. Cons.Del.Sol:RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO;SOTO DIAZ GERMAN. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ GARCIAFRANCISCO;GONZALEZ RODRIGUEZ FELISINDO;COBAS PENA ANGEL;RODRIGUEZ SEGADE JAVIER;SOTO DIAZ GERMAN.Presidente: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO. Secretario: SOTO DIAZ GERMAN. Cons.Del.Sol: COBAS PENA ANGEL;SOTO DIAZGERMAN. Otros conceptos: Modificaci贸n del art铆culo 22 de los Estatutos Sociales referente a que el cargo de conserjera ser谩retribuido. Datos registrales. T 746 , F 157, S 8, H OR 146, I/A 24 (24.10.11).
30 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apoderado: PEREZ BERNARDEZ MARIA DOLORES. Datos registrales. T 746 , F 157, S 8, H OR 146, I/A 23(17.11.10).
12 de Febrero de 2010Revocaciones. Auditor: NU脩EZ COELLO ALFONSO. Aud.Supl.: SERVIA SANTOS FRANCISCO. Nombramientos. Auditor:AUDITORES DE FINANZAS ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 746 , F 156, S 8, H OR 146, I/A 22 (22.01.10).
24 de Diciembre de 2009Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO. Presidente: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO. Consejero: SOTODIAZ GERMAN. Secretario: SOTO DIAZ GERMAN. Consejero: GONZALEZ RODRIGUEZ FELISINDO. Cons.Del.Sol: RODRIGUEZGARCIA FRANCISCO;SOTO DIAZ GERMAN. Otros conceptos: Modificaci贸n del art铆culo 19潞 de los Estatutos Sociales, enel sentidode que la duraci贸n del cargo de Consejero ser谩 de SEIS A脩OS. Datos registrales. T 746 , F 156, S 8, H OR 146, I/A 21 (14.12.09).
05 de Febrero de 2009Reelecciones. Auditor: NU脩EZ COELLO ALFONSO. Aud.Supl.: SERVIA SANTOS FRANCISCO. Datos registrales. T 746 , F 156, S8, H OR 146, I/A 20 (15.01.09).