Actos BORME de Proyectos De Ingenieria Beiramar Sa
18 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Liquidador: GARCIA COSTAS JOSE. Consejero: GARCIA COSTAS JOSE. Presidente: GARCIA COSTAS JOSE.Con.Delegado: GARCIA COSTAS JOSE. Consejero: SILVEIRA CORREA RAIMUNDO. Secretario: SILVEIRA CORREA RAIMUNDO.Consejero: PEREZ COSTAS FERNANDO. Vicepresid.: PEREZ COSTAS FERNANDO. Nombramientos. Liquidador: GARCIACOSTAS JOSE. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 2117, L 2117, F 115, S 8, H PO 21259, I/A 14 ( 9.10.19).
24 de Septiembre de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 167.982,88 Euros. Desembolsado: 167.982,88 Euros. Resultante Suscrito: 238.000,79 Euros.Resultante Desembolsado: 238.000,79 Euros. Datos registrales. T 2117, L 2117, F 115, S 8, H PO 21259, I/A 13 (17.09.18).
06 de Septiembre de 2018Nombramientos. Auditor: DE LA CALLE AMARO MIGUEL RAMON. Aud.Supl.: EUDITA-AUDITEC TECNICOS AUDITORESSOCIEDAD LIMITAD. Datos registrales. T 2117, L 2117, F 115, S 8, H PO 21259, I/A 12 (29.08.18).
27 de Julio de 2018Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: GARCIA COSTAS JOSE;PEREZ COSTAS FERNANDO;SILVEIRACORREA RAIMUNDO. Presidente: GARCIA COSTAS JOSE. Con.Delegado: GARCIA COSTAS JOSE. Vicepresid.: PEREZ COSTASFERNANDO. Secretario: SILVEIRA CORREA RAIMUNDO. Nombramientos. Consejero: GARCIA COSTAS JOSE. Presidente:GARCIA COSTAS JOSE. Con.Delegado: GARCIA COSTAS JOSE. Consejero: SILVEIRA CORREA RAIMUNDO. Secretario:SILVEIRA CORREA RAIMUNDO. Consejero: PEREZ COSTAS FERNANDO. Vicepresid.: PEREZ COSTAS FERNANDO. Datosregistrales. T 2117, L 2117, F 114, S 8, H PO 21259, I/A 11 (19.07.18).
06 de Marzo de 2018P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.pdibeiramar.com. Datos registrales. T 2117, L 2117, F114, S 8, H PO 21259, I/A 10 (27.02.18).
21 de Febrero de 2018Otros conceptos: Se modifican los estatutos sociales y se REFUNDEN en un nuevo texto. Datos registrales. T 2117, L 2117, F111, S 8, H PO 21259, I/A 9 (13.02.18).
02 de Junio de 2016Revocaciones. Apoderado: SILVEIRA CORREA RAIMUNDO. Datos registrales. T 2117, L 2117, F 111, S 8, H PO 21259, I/A 8(25.05.16).
30 de Octubre de 2014Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 30.050,60 Euros. Datos registrales. T 2117, L 2117, F 110, S 8, H PO 21259,I/A 6 (22.10.14).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 9.916,70 Euros. Desembolsado: 9.916,70 Euros. Resultante Suscrito: 70.017,91 Euros. ResultanteDesembolsado: 70.017,91 Euros. Datos registrales. T 2117, L 2117, F 111, S 8, H PO 21259, I/A 7 (22.10.14).
12 de Julio de 2013Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: GARCIA COSTAS JOSE;PEREZ COSTAS FERNANDO;SILVEIRACORREA RAIMUNDO. Presidente: GARCIA COSTAS JOSE. Con.Delegado: GARCIA COSTAS JOSE. Vicepresid.: PEREZ COSTASFERNANDO. Secretario: SILVEIRA CORREA RAIMUNDO. Nombramientos. Consejero: GARCIA COSTAS JOSE. Presidente:GARCIA COSTAS JOSE. Consejero: PEREZ COSTAS FERNANDO. Vicepresid.: PEREZ COSTAS FERNANDO. Consejero:SILVEIRA CORREA RAIMUNDO. Secretario: SILVEIRA CORREA RAIMUNDO. Con.Delegado: GARCIA COSTAS JOSE. Datosregistrales. T 2117, L 2117, F 110, S 8, H PO 21259, I/A 5 ( 4.07.13).