Buscador CIF Logo

Actos BORME Proyectos Integrales Solares Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Proyectos Integrales Solares Sl

Actos BORME Proyectos Integrales Solares Sl - B31856438

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Navarra para Proyectos Integrales Solares Sl con CIF B31856438

馃敊 Perfil de Proyectos Integrales Solares Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Navarra

Actos BORME de Proyectos Integrales Solares Sl

19 de Octubre de 2016
Fe de erratas: En la inscripci贸n 13陋 el segundo apellido correcto de la apoderada do帽a Silvia Garbayo es U帽an, no el que se public贸por error. Datos registrales. T 1143 , F 43, S 8, H NA 22914, I/A 13 (14.09.11).

06 de Junio de 2016
Nombramientos. Auditor: BAKER TILLY FMAC SLP. Datos registrales. T 1581 , F 212, S 8, H NA 22914, I/A 28 (26.05.16).

20 de Noviembre de 2015
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ALVAREZ HERRAIZ ALFONSO. Consejero: CHAVEZ MARTINEZ ALEJANDRO JAVIER.Presidente: CHAVEZ MARTINEZ ALEJANDRO JAVIER. Consejero: CARRERO DIEZ GUSTAVO;REMACHA ZAPATEL FRANCISCOJAVIER;MIERES ROY0 JOSE ANTONIO. Co.De.Ma.So: CHAVEZ MARTINEZ ALEJANDRO JAVIER;CARRERO DIEZGUSTAVO;REMACHA ZAPATEL FRANCISCO JAVIER;MIERES ROYO JOSE ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico:PHOTOVOLTAIC GLOBAL DISTRIBUTION SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸na Administrador 煤nico. Designada persona f铆sica representante del Administrador 煤nico D. Mark Philip RANDALL. Datos registrales.T 1581 , F 212, S 8, H NA 22914, I/A 27 (10.11.15).

17 de Abril de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: REMACHA ZAPATEL MAITE. Apoderado: REMACHA ZAPATEL MAITE. Datos registrales. T 1581 ,F 212, S 8, H NA 22914, I/A 26 ( 1.04.15).

18 de Marzo de 2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1581 , F 212, S 8, H NA 22914, I/A 24 ( 6.03.15).

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: PHOTOVOLTAIC GLOBAL DISTRIBUTION SL. Datos registrales.T 1581 , F 212, S 8, H NA 22914, I/A 25 ( 6.03.15).

13 de Agosto de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARRENECHEA UCIN JOSE LUIS. Secretario: BARRENECHEA UCIN JOSE LUIS.Nombramientos. SecreNoConsj: ALVAREZ HERRAIZ ALFONSO. Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art. 18潞, enrelaci贸n al cargo de Secretario del Consejo de Administraci贸n.. Datos registrales. T 1581 , F 211, S 8, H NA 22914, I/A 23 (29.07.14).

24 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: RANDALL MARK-PHILIP. Datos registrales. T 1581 , F 210, S 8, H NA 22914, I/A 22 (13.12.13).

02 de Diciembre de 2013
Revocaciones. Apoderado: RAFFLESIEPER JENS. Datos registrales. T 1581 , F 210, S 8, H NA 22914, I/A 21 (18.11.13).

22 de Enero de 2013
Revocaciones. Apoderado: PEREZ VILLAR OSCAR;PEREZ VILLAR OSCAR. Nombramientos. Apoderado: RAFFLESIEPERJENS. Datos registrales. T 1581 , F 208, S 8, H NA 22914, I/A 20 (15.01.13).

04 de Junio de 2012
Otros conceptos: Constancia del cambio de denominaci贸n del socio 煤nico, "Otras producciones de energ铆a, S. L.", por la nuevadenominaci贸n "OPDE INVESTMENT ESPA脩A, S. L.". Datos registrales. T 1581 , F 208, S 8, H NA 22914, I/A 18 (23.05.12).

Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1581 , F 208, S 8, H NA 22914, I/A 19 (23.05.12).

21 de Diciembre de 2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LAPARTE PASCUAL ANGEL. Datos registrales. T 1581 , F 208, S 8, H NA 22914, I/A 17 ( 5.12.11).

20 de Diciembre de 2011
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1581 , F 206, S 8, H NA 22914, I/A14 ( 5.12.11).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 86.994,00 Euros. Resultante Suscrito: 90.000,00 Euros. Datos registrales. T 1581 , F 206, S 8, HNA 22914, I/A 15 ( 5.12.11).

Nombramientos. Apoderado: REMACHA ZAPATEL MAITE;REINOSO CASADO JESUS MARIA;PEREZ VILLAR OSCAR;PEREZVILLAR OSCAR. Datos registrales. T 1581 , F 207, S 8, H NA 22914, I/A 16 ( 5.12.11).

26 de Septiembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CHAVEZ MARTINEZ ALEJANDRO JAVIER. Revocaciones. Apoderado: CARRERO DIEZGUSTAVO;REMACHA ZAPATEL FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: CHAVEZ MARTINEZ ALEJANDRO JAVIER.Presidente: CHAVEZ MARTINEZ ALEJANDRO JAVIER. Consejero: BARRENECHEA UCIN JOSE LUIS. Secretario: BARRENECHEAUCIN JOSE LUIS. Consejero: CARRERO DIEZ GUSTAVO;REMACHA ZAPATEL FRANCISCO JAVIER;MIERES ROY0 JOSEANTONIO. Co.De.Ma.So: CHAVEZ MARTINEZ ALEJANDRO JAVIER;CARRERO DIEZ GUSTAVO;REMACHA ZAPATELFRANCISCO JAVIER;MIERES ROYO JOSE ANTONIO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 1143 , F 40, S 8, H NA 22914, I/A 12 (14.09.11).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: REMACHA ZAPATEL MAITE;LAPARTE PASCUAL ANGEL;REINOSO CASADO JESUSMARIA;REMACHA ZAPATEL FRANCISCO JAVIER;SERRANO JIMENEZ JUAN ANGEL;GARBAYO LI脩AN SILVIA. Datosregistrales. T 1143 , F 43, S 8, H NA 22914, I/A 13 (14.09.11).

13 de Octubre de 2010
Revocaciones. Apoderado: ENRIQUE BLANCO MARIA CONCEPCION. Datos registrales. T 1143 , F 40, S 8, H NA022914,

28 de Septiembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: CARRERO DIEZ GUSTAVO;REMACHA ZAPATEL FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 1143 ,F 37, S 8, H NA022914, I/A00010 (17.09.10).

Ceses/Dimisiones. Admin.Unico: RIOS GIL ADALBERTO. Nombramientos. Admin.Unico: CHAVEZ MARTINEZ ALEJANDROJAVIER. Datos registrales. T 1143 , F 37, S 8, H NA022914, I/A00009 (17.09.10).

20 de Septiembre de 2010
Cambio de domicilio social. POLIG SANTOS JUSTO Y PASTOR , n潞 S/N (FUSTI脩ANA). Datos registrales. T 1143 , F 37, S 8, H

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n