Actos BORME de Proyefa Internacional Sl
11 de Agosto de 2023Otros conceptos: Se revocan los poderes otorgados a D陋 EUGENIA MARTINEZ DE OSABA EIGUEZBAL, D陋CARMEN ROZPIDEORBEGOZO, D. LUIS ENRIQUE FRAGA LEON, D. JOSE ANTONIO VARGAS PRIETO, D. JAVIER FRAGA LEON, D. ANTONIOCASTRECHINI, D. MANUEL FRAGA MORENO, en relaci贸n con las cuentas bancarias abiertas en Banco Santander. Datosregistrales. T 27606 , F 21, S 8, H M 479108, I/A 29 ( 4.08.23).
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: NOAIN LARRINAGA CARMEN;COLAS YBA脩EZ INES. Revocaciones. Apoderado: FRAGALEON LUIS ENRIQUE;VARGAS PRIETO JOSE ANTONIO;FRAGA LEON JAVIER;CASTRECHINI ANTONIO;FRAGA MORENOMANUEL. Nombramientos. VsecrNoConsj: COLAS YBA脩EZ INES;MORENO DE LA SANTA ZABIA PALOMA. Datos registrales. T27606 , F 21, S 8, H M 479108, I/A 30 ( 4.08.23).
19 de Abril de 2022Reelecciones. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 27606 , F 20, S 8, H M 479108, I/A 27 ( 8.04.22).
30 de Septiembre de 2021Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: GARCIA SILVESTRE IGNACIO. Nombramientos. VsecrNoConsj: NOAIN LARRINAGACARMEN. Datos registrales. T 27606 , F 20, S 8, H M 479108, I/A 26 (23.09.21).
02 de Agosto de 2019Reelecciones. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 27606 , F 20, S 8, H M 479108, I/A 25 (26.07.19).
25 de Abril de 2018Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-. Cambio de domicilio social. C/SERRANO 41 - 4陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 27606 , F 19, S 8, H M 479108, I/A 24 (17.04.18).
27 de Abril de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 54.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.209.430,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:287.779,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.497.209,00 Euros. Datos registrales. T 27606 , F 17, S 8, H M 479108, I/A 22 (19.04.17).
31 de Enero de 2017Otros conceptos: Se declara que el auditor nombrado ha sido sustituido por "AUREN AUDITORES SP, SLP" como consecuencia dela escritura de fusi贸n y segregaci贸n que caus贸 la inscripci贸n 1陋 de la hoja 624.626. Datos registrales. T 27606 , F 15, S 8, H M479108, I/A 18M (16.01.17).
19 de Abril de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: FRAGA LEON LUIS ENRIQUE;VARGAS PRIETO JOSE ANTONIO. Cons.Del.Sol: CASTRECHINIANTONIO;FRAGA LEON LUIS ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: VARGAS USECHE JOSE ANTONIO;PRIETO HERRERARICARDO JOSE. Datos registrales. T 27606 , F 17, S 8, H M 479108, I/A 21 (12.04.16).
22 de Febrero de 2016Modificaciones estatutarias. Aprobado nuevo texto de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 27606 , F 15, S 8, H M 479108,I/A 20 (15.02.16).
17 de Noviembre de 2015Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: PROYEFA HOLDINGS NV. Datos registrales. T 27606 , F 15, S 8, H M 479108, I/A19 ( 6.11.15).
28 de Octubre de 2015Reelecciones. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES MAD SLP. Datos registrales. T 27606 , F 15, S 8, H M 479108, I/A 18 (20.10.15).
23 de Febrero de 2015Nombramientos. VsecrNoConsj: GARCIA SILVESTRE IGNACIO. Datos registrales. T 27606 , F 15, S 8, H M 479108, I/A 17(13.02.15).
28 de Enero de 2015Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: MELENDEZ ACEDO ELISA. Datos registrales. T 27606 , F 14, S 8, H M 479108, I/A 16 (21.01.15).
25 de Marzo de 2014P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 27606 , F 14, S 8, H M 479108, I/A 15 (14.03.14).
05 de Octubre de 2012Reelecciones. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES MADRID SL. Datos registrales. T 27606 , F 14, S 8, H M 479108, I/A 14(25.09.12).
03 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Representan: MARTINEZ DE OSABA ELGUEZABAL EUGENIA. Nombramientos. Representan: CASTA脩ONMARTINEZ ESPERANZA. Datos registrales. T 27606 , F 14, S 8, H M 479108, I/A 13 (24.07.12).
29 de Diciembre de 2010Ceses/Dimisiones. Presidente: CASTRECHINI ANTONIO. Nombramientos. Consejero: OLMOS GIBAJA JAIME. Presidente:OLMOS GIBAJA JAIME. Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ART. 11潞.. Datos registrales. T 27606 , F 13, S 8, H M479108, I/A 12 (17.12.10).
24 de Noviembre de 2010Nombramientos. Cons.Del.Sol: CASTRECHINI ANTONIO;FRAGA LEON LUIS ENRIQUE. Datos registrales. T 27606 , F 12, S 8, HM 479108, I/A 11 (11.11.10).
13 de Septiembre de 2010Ampliacion del objeto social. La compraventa, comercializacion y distribucion de insumos y productos agricolas, fertilizantes, asicomo cualesquiera otras materias primas o productos terminados relacionados directa o indirecamente con el sector agricola. Datosregistrales. T 27606 , F 12, S 8, H M 479108, I/A 10 ( 1.09.10).
30 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: SANCHEZ LOPEZ CHICHERI ALVARO. Nombramientos. Vicesecret.: MELENDEZ ACEDO ELISA.Datos registrales. T 27606 , F 12, S 8, H M 479108, I/A 9 (20.07.10).
08 de Abril de 2010Nombramientos. Aud.C.Con.: AUREN CENTRO AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 26585 , F 53, S 8, H M479108, I/A 8 (24.03.10).
11 de Febrero de 2010Nombramientos. Apoderado: FRAGA LEON LUIS ENRIQUE;VARGAS PRIETO JOSE ANTONIO;FRAGA LEONJAVIER;CASTRECHINI ANTONIO;FRAGA MORENO MANUEL. Datos registrales. T 26585 , F 53, S 8, H M 479108, I/A 7 (28.01.10).
25 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN. Apoderado: MARTINEZ DE OSABA ELGUEZABAL EUGENIA.Apo.Man.Soli: MARTINEZ DE OSABA ELGUEZABAL EUGENIA. Apo.Manc.: FRAGA LEON LUIS ENRIQUE;VARGAS PRIETO JOSEANTONIO;FRAGA LEON JAVIER;CASTRECHINI ANTONIO;FRAGA MORENO MANUEL. Datos registrales. T 26585 , F 52, S 8, HM 479108, I/A 5 (13.11.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN;MARTINEZ DE OSABA ELGUEZABAL EUGENIA. Datos registrales.T 26585 , F 52, S 8, H M 479108, I/A 6 (13.11.09).
17 de Septiembre de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: INTERTRUST (SPAIN) SA. Representan: MARTINEZ DE OSABA ELGUEZABAL EUGENIA.Nombramientos. Consejero: FRAGA LEON LUIS ENRIQUE;VARGAS PRIETO JOSE ANTONIO;FRAGA LEONJAVIER;CASTRECHINI ANTONIO;FRAGA MORENO MANUEL;INTERTRUST (SPAIN) SA. Presidente: CASTRECHINI ANTONIO.Vicepresid.: INTERTRUST (SPAIN) SA. SecreNoConsj: D'ONZA ROSSANNA. Vicesecret.: SANCHEZ LOPEZ CHICHERI ALVARO.Representan: MARTINEZ DE OSABA ELGUEZABAL EUGENIA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 26585 , F 50, S 8, H M 479108, I/A 4(31.08.09).
28 de Agosto de 2009Otros conceptos: EL ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD DE ESTE HOJA: -FORTISINTERTRUST (SPAIN) SA-, HACAMBIADO SU DENOMINACION SOCIAL,SIENDO LA ACTUAL, -INTERTRUST (SPAIN) SA-. Datos registrales. T 26585 , F 46, S 8,H M 479108, I/A 1-M (19.08.09).
13 de Julio de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 16.604,00 Euros. Resultante Suscrito: 19.904,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:10.134.926,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.154.830,00 Euros. Datos registrales. T 26585 , F 48, S 8, H M 479108, I/A 3 ( 1.07.09).
22 de Mayo de 2009Nombramientos. Apoderado: CASTRECHINI TROTTA ANTONIO;FRAGA LUIS ENRIQUE;VARGAS JOSE ANTONIO;FRAGA LEONJAVIER;FRAGA MORENO MANUEL;POSADA SESSAREGO ALVARO;REYES MARIA EUGENIA;CELIS MARIA DE LOSANGELES;LEAL MARIA ISABEL;PAUL MARIA LUISA. Datos registrales. T 26585 , F 47, S 8, H M 479108, I/A 2 (11.05.09).
20 de Abril de 2009Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 27.03.09. Objeto social: LA ADQUISICION, TENENCIA, GESTION Y ADMINISTRACIONDE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPA脩OL...Domicilio: C/ HERMOSILLA 11 4潞 A (MADRID). Capital: 3.300,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: