Actos BORME de Psn Asesoramiento Y Gestion Del Riesgo Sa
13 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: CARRERO SANCHEZ MIGUEL. Datos registrales. T 40337 , F 123, S 8, H M 609853, I/A 26 ( 6.03.23).
Nombramientos. Apoderado: CARRERO SANCHEZ MIGUEL. Datos registrales. T 40337 , F 123, S 8, H M 609853, I/A 27 (6.03.23).
05 de Enero de 2022Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 21 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 40337 , F 122, S 8, H M609853, I/A 24 (29.12.21).
27 de Octubre de 2021Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 40337 , F 122, S 8, H M 609853, I/A 23 (20.10.21).
17 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA JIMENEZ CRISTINA;DIAZ-MECO CONDE MARIA LUISA. Datos registrales. T 40337 , F 121, S8, H M 609853, I/A 21 (10.06.21).
Nombramientos. Apoderado: ANCOCHEA BERMUDEZ JULIO;DIAZ-MECO CONDE MARIA LUISA. Datos registrales. T 40337 , F121, S 8, H M 609853, I/A 22 (10.06.21).
02 de Junio de 2021Nombramientos. Con.Delegado: CARRERO LOPEZ MIGUEL JOSE. Datos registrales. T 40337 , F 120, S 8, H M 609853, I/A 20(26.05.21).
17 de Febrero de 2021Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 17陋 la reelecci贸n como consejero delegado de CARRERO LOPEZ MIGUELJOSE, siendo lo correcto su cese en dicho cargo. Datos registrales. T 33889 , F 200, S 8, H M 609853, I/A 17 (20.10.20).
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: CARRERO LOPEZ MIGUEL JOSE. Datos registrales. T 33889 , F 200, S 8, H M 609853, I/A 17(20.10.20).
16 de Febrero de 2021Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 17陋 la reelecci贸n como consejero delegado de CARRERO LOPEZ MIGUELJOSE, siendo lo correcto su cese en dicho cargo. Datos registrales. T 33889 , F 200, S 8, H M 609853, I/A 17 (20.10.20).
19 de Noviembre de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 40337 , F 120, S 8, H M 609853,I/A 18 (12.11.20).
27 de Octubre de 2020Nombramientos. Consejero: ANCOCHEA BERMUDEZ JULIO. Reelecciones. Consejero: CARRERO LOPEZ MIGUELJOSE;RODRIGUEZ MENENDEZ MARIA CARMEN;IMAZ BUENECHEA ESTEBAN;TRIOLA FORT MIGUEL. Presidente: CARREROLOPEZ MIGUEL JOSE. Secretario: IMAZ BUENECHEA ESTEBAN. Vicepresid.: RODRIGUEZ MENENDEZ MARIA CARMEN.Con.Delegado: CARRERO LOPEZ MIGUEL JOSE. Datos registrales. T 33889 , F 200, S 8, H M 609853, I/A 17 (20.10.20).
28 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA JIMENEZ CRISTINA;DIAZ-MECO CONDE MARIA LUISA. Datos registrales. T 33889 , F 200,S 8, H M 609853, I/A 16 (21.02.20).
27 de Febrero de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA JIMENEZ CRISTINA;RIOJA GONZALO JESUS MARIA. Datos registrales. T 33889 , F 199, S 8,H M 609853, I/A 15 (20.02.20).
24 de Junio de 2019Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 33889 , F 199, S 8, H M 609853,I/A 14 (17.06.19).
11 de Enero de 2019Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 33889 , F 199, S 8, H M 609853,I/A 13 ( 3.01.19).
30 de Julio de 2018Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ CANOSA JAVIER. Datos registrales. T 33889 , F 199, S 8, H M 609853, I/A 12(23.07.18).
04 de Agosto de 2017Cambio de domicilio social. C/ GENOVA 26 (MADRID). Datos registrales. T 33889 , F 199, S 8, H M 609853, I/A 11 (27.07.17).
10 de Mayo de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: CORTIZO RUBIO JOSE. Datos registrales. T 33889 , F 198, S 8, H M 609853, I/A 9 (28.04.17).
Revocaciones. Apo.Sol.: CORTIZO RUBIO JOSE. Datos registrales. T 33889 , F 198, S 8, H M 609853, I/A 10 (28.04.17).
21 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ CANOSA JAVIER;MARINA ALONSO ESTHER. Datos registrales. T 33889 , F 198, S 8,H M 609853, I/A 8 (14.02.17).
06 de Febrero de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: CANDELAS FERNANDEZ JUAN. Datos registrales. T 33889 , F 198, S 8, H M 609853, I/A 7 (27.01.17).
26 de Enero de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA JIMENEZ CRISTINA;RIOJA GONZALO JESUS MARIA;CORTIZO RUBIO JOSE. Datosregistrales. T 33889 , F 197, S 8, H M 609853, I/A 6 (19.01.17).
13 de Enero de 2017Nombramientos. Con.Delegado: CARRERO LOPEZ MIGUEL JOSE. Datos registrales. T 33889 , F 197, S 8, H M 609853, I/A 5 (4.01.17).
19 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apoderado: CARRERO LOPEZ MIGUEL JOSE. Datos registrales. T 33889 , F 195, S 8, H M 609853, I/A 2(11.11.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: CANDELAS FERNANDEZ JUAN;CORTIZO RUBIO JOSE. Datos registrales. T 33889 , F 196, S 8, H M609853, I/A 3 (11.11.15).
21 de Octubre de 2015Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 30.09.15. Objeto social: La realizaci贸n de actividades de mediaci贸n de seguros comoagencia de seguros exclusiva, as铆 como la comisi贸n, la representaci贸n mercantil y la intermediaci贸n comercial tanto de personas f铆sicascomo jur铆dicas, en los t茅rminos y condiciones que se establezcan en la legislaci贸n espec铆fica y, en parti. Domicilio: C/ VILLANUEVA 11(MADRID). Capital suscrito: 300.000,00 Euros. Desembolsado: 300.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico:PREVISION SANITARIA NACIONAL PSN MUTUA DE SEGUROS. Nombramientos. Consejero: CARRERO LOPEZ MIGUELJOSE;RODRIGUEZ MENENDEZ MARIA CARMEN;IMAZ BUENECHEA ESTEBAN;TRIOLA FORT MIGUEL. Presidente: CARREROLOPEZ MIGUEL JOSE. Secretario: IMAZ BUENECHEA ESTEBAN. Vicepresid.: RODRIGUEZ MENENDEZ MARIA CARMEN. Datosregistrales. T 33889 , F 191, S 8, H M 609853, I/A 1 (13.10.15).