Buscador CIF Logo

Actos BORME Puerto De Celeiro Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Puerto De Celeiro Sa

Actos BORME Puerto De Celeiro Sa - A27175553

Tenemos registrados 34 Actos BORME del Registro Mercantil de Lugo para Puerto De Celeiro Sa con CIF A27175553

馃敊 Perfil de Puerto De Celeiro Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Lugo

Actos BORME de Puerto De Celeiro Sa

25 de Septiembre de 2023
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.003.610,00 Euros. Resultante Suscrito: 260.590,00 Euros. Datos registrales. T 527 , F33, S 8, H LU 3253, I/A 61 (15.09.23).

29 de Agosto de 2023
Reelecciones. Auditor: AUDITGAL SA. Aud.C.Con.: AUDITGAL SA. Datos registrales. T 527 , F 32, S 8, H LU 3253, I/A 60(17.08.23).

08 de Agosto de 2022
Reelecciones. Auditor: AUDITGAL SA. Aud.C.Con.: AUDITGAL SA. Datos registrales. T 527 , F 32, S 8, H LU 3253, I/A 59(28.07.22).

16 de Septiembre de 2021
Reelecciones. Auditor: AUDITGAL SA. Aud.C.Con.: AUDITGAL SA. Datos registrales. T 527 , F 32, S 8, H LU 3253, I/A 58 (8.09.21).

02 de Septiembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: NOVO RODRIGUEZ JOSE. Presidente: NOVO RODRIGUEZ JOSE. Consejero: REY SEIJASDOMINGO. Vicepresid.: REY SEIJAS DOMINGO. Consejero: SANTOS PEREZ JOSE ANTONIO. Secretario: SANTOS PEREZ JOSEANTONIO. Consejero: CANOURA LABAYEN SAMUEL;SANCHEZ GARCIA JESUS;FERNANDEZ MIGUEZ JOSE DOMINGO;LOPEZCASAS JUAN RICARDO;SANTOS PAZ JOSE RAMON;REGAL TRASANCOS MARTIN;GARCIA LOPEZ LUIS;RODRIGUEZPARAPAR JOSE HILARIO;PINO MONTERO JOSE BAUTISTA;LORENZO PORTO RAMON. Nombramientos. Consejero: NOVORODRIGUEZ JOSE. Presidente: NOVO RODRIGUEZ JOSE. Consejero: SANTOS PEREZ JOSE ANTONIO. Secretario: SANTOSPEREZ JOSE ANTONIO. Consejero: REY SEIJAS DOMINGO. Vicepresid.: REY SEIJAS DOMINGO. Consejero: CANOURACALZADO JUAN;SANCHEZ GARCIA JESUS;FERNANDEZ MIGUEZ JOSE DOMINGO;LOPEZ CASAS JUAN RICARDO;SANTOSPAZ JOSE RAMON;REGAL TRASANCOS MARTIN;GARCIA LOPEZ LUIS;RODRIGUEZ PARAPAR JOSE HILARIO;PINO CAO JUANBAUTISTA;LORENZO PORTO RAMON. Datos registrales. T 527 , F 31, S 8, H LU 3253, I/A 56 (23.08.21).

Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.264.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.264.200,00 Euros. Datos registrales. T 527 , F32, S 8, H LU 3253, I/A 57 (23.08.21).

03 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Aud.C.Con.: AUDITGAL SA. Reelecciones. Auditor: AUDITGAL SA. Datos registrales. T 527 , F 31, S 8, H LU3253, I/A 55 (25.11.20).

21 de Noviembre de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.325.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.528.400,00 Euros. Datos registrales. T 527 , F30, S 8, H LU 3253, I/A 54 (12.11.19).

13 de Agosto de 2019
Reelecciones. Auditor: AUDITGAL SA. Datos registrales. T 479 , F 74, S 8, H LU 3253, I/A 53 ( 2.08.19).

06 de Agosto de 2019
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 581.400,00 Euros. Datos registrales. T 479 , F 74, S 8, H LU 3253, I/A 52(23.07.19).

30 de Agosto de 2018
Reelecciones. Auditor: AUDITGAL SA. Datos registrales. T 479 , F 73, S 8, H LU 3253, I/A 51 (16.08.18).

16 de Agosto de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: FUMEIRO DE CELEIRO SL;PESQUERA BENQUERENCIA SL. Presidente: PESQUERABENQUERENCIA SL. Consejero: ANTONIO SANTOS ALONSO SL. Secretario: ANTONIO SANTOS ALONSO SL. Consejero:ALEGRIN SL. Vicepresid.: ALEGRIN SL. Consejero: PESQUERA LUCENSE SL;FUMEIRO DE CELEIRO SL;PESQUERA SOCIOSL;PESQUERA KOIRO SL;PESQUERA JORALCA SL;REGAL PESCA LITORAL SL;HERMANOS GARCIA YA脩EZ SA1;PESQUERARODRIGUEZ PARAPAR SL;PESQUERA DE CILLERO SA;LORENZO PORTO RAMON. Nombramientos. Consejero: NOVORODRIGUEZ JOSE. Presidente: NOVO RODRIGUEZ JOSE. Consejero: REY SEIJAS DOMINGO. Vicepresid.: REY SEIJASDOMINGO. Consejero: SANTOS PEREZ JOSE ANTONIO. Secretario: SANTOS PEREZ JOSE ANTONIO. Consejero: CANOURALABAYEN SAMUEL;SANCHEZ GARCIA JESUS;FERNANDEZ MIGUEZ JOSE DOMINGO;LOPEZ CASAS JUAN RICARDO;SANTOSPAZ JOSE RAMON;REGAL TRASANCOS MARTIN;GARCIA LOPEZ LUIS;RODRIGUEZ PARAPAR JOSE HILARIO;PINO MONTEROJOSE BAUTISTA;LORENZO PORTO RAMON. Datos registrales. T 479 , F 72, S 8, H LU 3253, I/A 48 ( 3.08.18).

Modificaciones estatutarias. PRINCIPIOS Y REGLAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO EN LO RELATIVO A LAS ACTIVIDADESCOMO ORGANIZACION DE PRODUCTORES PESQUEROS. Principios de funcionamiento interno. El funcionamiento interno en lasactividades de la sociedad como Organizaci贸n de Productores Pesqueros se basar谩 en los principios de la. Datos registrales. T 479 ,F 72, S 8, H LU 3253, I/A 49 ( 3.08.18).

Modificaciones estatutarias. 6. Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 479 , F 73, S 8, H LU 3253, I/A 50 ( 3.08.18).

07 de Agosto de 2018
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 1.453.500,00 Euros. Datos registrales. T 479 , F 71, S 8, H LU 3253, I/A 47(26.07.18).

26 de Diciembre de 2017
Reelecciones. Auditor: AUDITGAL SA. Datos registrales. T 479 , F 71, S 8, H LU 3253, I/A 46 (12.12.17).

23 de Septiembre de 2016
Reelecciones. Auditor: AUDITGAL SA. Datos registrales. T 479 , F 71, S 8, H LU 3253, I/A 45 (14.09.16).

05 de Septiembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: NOVO RODRIGUEZ JOSE. Presidente: NOVO RODRIGUEZ JOSE. Consejero: REY SEIJASDOMINGO. Vicepresid.: REY SEIJAS DOMINGO. Consejero: SANTOS PEREZ JOSE ANTONIO. Secretario: SANTOS PEREZ JOSEANTONIO. Consejero: SANTOS PAZ JOSE RAMON;RAMON PEREZ RODRIGUEZ;JOSE HILARIO RODRIGUEZ PARAPAR;LUISGARCIA LOPEZ;PINO LADRA JUAN BAUTISTA;PINO MONTERO JOSE BAUTISTA;LOPEZ CASAS JUAN RICARDO;RODRIGUEZLAGE FERMIN;LORENZO PORTO RAMON. Nombramientos. Consejero: PESQUERA BENQUERENCIA SL. Presidente:PESQUERA BENQUERENCIA SL. Consejero: ANTONIO SANTOS ALONSO SL. Secretario: ANTONIO SANTOS ALONSO SL.Consejero: ALEGRIN SL. Vicepresid.: ALEGRIN SL. Consejero: PESQUERA LUCENSE SA;FUMEIRO DE CELEIRO SL;PESQUERASOCIO SL;PESQUERA KOIRO SL;PESQUERA JORALCA SL;REGAL PESCA LITORAL SL;HERMANOS GARCIA YA脩EZSA1;PESQUERA RODRIGUEZ PARAPAR SL;PESQUERA DE CILLERO SA;LORENZO PORTO RAMON. Datos registrales. T 479 ,F 70, S 8, H LU 3253, I/A 44 (26.08.16).

22 de Septiembre de 2015
Modificaciones estatutarias. 13. Funcionamiento Junta Gral.-. Ampliacion del objeto social. b. Fomentar el ejercicio deactividades pesqueras viables y sostenibles, cumpliendo plenamente la pol铆tica de conservaci贸n establecida, en particular, en elReglamento -UE- n煤mero 1380/2013 y en la legislaci贸n medioambiental, respetando al mismo tiempo la pol铆tica social y, cuando elEstado miembro. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: http://www.puertodeceleiro.es. Datosregistrales. T 479 , F 70, S 8, H LU 3253, I/A 43 (14.09.15).

07 de Septiembre de 2015
Reelecciones. Auditor: AUDITGAL SA. Datos registrales. T 417 , F 109, S 8, H LU 3253, I/A 42 (28.08.15).

18 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: FUMEIRO DE CELEIRO SL.Datos registrales. T 417 , F 109, S 8, H LU 3253, I/A 41 ( 9.06.15).

23 de Enero de 2015
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 5.994.000,00 Euros. Desembolsado: 5.994.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.854.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 10.854.000,00 Euros. Datos registrales. T 417 , F 109, S 8, H LU 3253, I/A 40 (16.01.15).

01 de Octubre de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.630.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.860.000,00 Euros. Datos registrales. T 417 , F108, S 8, H LU 3253, I/A 39 (22.09.14).

15 de Septiembre de 2014
Reelecciones. Auditor: AUDITGAL SA. Datos registrales. T 417 , F 108, S 8, H LU 3253, I/A 38 ( 5.09.14).

20 de Noviembre de 2013
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 88.948,00 Euros. Datos registrales. T 417 , F 108, S 8, H LU 3253, I/A 37(11.11.13).

23 de Septiembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: JESUS RODRIGUEZ LAGE;LOPEZ CANDIA FLORENTINO;JESUS MANUEL FERNANDEZ MIGUEZ.Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ LAGE FERMIN;LORENZO PORTO RAMON;SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL.Reelecciones. Consejero: NOVO RODRIGUEZ JOSE. Presidente: NOVO RODRIGUEZ JOSE. Consejero: DOMINGO REY SEIJAS.Vicepresid.: DOMINGO REY SEIJAS. Consejero: SANTOS PEREZ JOSE ANTONIO. Secretario: SANTOS PEREZ JOSE ANTONIO.Consejero: SANTOS PAZ JOSE RAMON;RAMON PEREZ RODRIGUEZ;JOSE HILARIO RODRIGUEZ PARAPAR;LUIS GARCIALOPEZ;PINO LADRA JUAN BAUTISTA;PINO MONTERO JOSE BAUTISTA;LOPEZ CASAS JUAN RICARDO. Datos registrales. T417 , F 107, S 8, H LU 3253, I/A 35 (12.09.13).

Reelecciones. Aud.Supl.: AUDITGAL SA. Datos registrales. T 417 , F 108, S 8, H LU 3253, I/A 36 (12.09.13).

02 de Abril de 2013
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 676.125,00 Euros. Datos registrales. T 417 , F 107, S 8, H LU 3253, I/A 34(22.03.13).

04 de Enero de 2012
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: CAPELLA PEREZ JUAN. Nombramientos. Auditor: AUDITGAL SA. Datosregistrales. T 417 , F 107, S 8, H LU 3253, I/A 33 (26.12.11).

02 de Marzo de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2,96 Euros. Resultante Suscrito: 4.481.056,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:2.009.746,96 Euros. Desembolsado: 770.484,96 Euros. Resultante Suscrito: 6.490.802,96 Euros. Resultante Desembolsado:5.251.540,96 Euros. Datos registrales. T 417 , F 106, S 8, H LU 3253, I/A 32 (14.02.11).

28 de Febrero de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2,96 Euros. Resultante Suscrito: 4.481.056,00 Euros. Datos registrales. T 417 , F 106, S8, H LU 3253, I/A 32 (14.02.11).

20 de Septiembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: NOVO RODRIGUEZ JOSE. Presidente: NOVO RODRIGUEZ JOSE. Consejero: DOMINGO REYSEIJAS. Vicepresid.: DOMINGO REY SEIJAS. Consejero: SANTOS PEREZ JOSE ANTONIO. Secretario: SANTOS PEREZ JOSEANTONIO. Consejero: REGAL PINO JUAN ANTONIO;SANTOS PAZ JOSE RAMON;RAMON PEREZ RODRIGUEZ;JESUSRODRIGUEZ LAGE;JOSE HILARIO RODRIGUEZ PARAPAR;LUIS GARCIA LOPEZ;PINO LADRA JUAN BAUTISTA;PINO MONTEROJOSE BAUTISTA;FLORENTINO LOPEZ CANDIA;VICENTE FUSTES SANCHEZ. Nombramientos. Consejero: NOVO RODRIGUEZJOSE. Presidente: NOVO RODRIGUEZ JOSE. Consejero: DOMINGO REY SEIJAS. Vicepresid.: DOMINGO REY SEIJAS. Consejero:SANTOS PEREZ JOSE ANTONIO. Secretario: SANTOS PEREZ JOSE ANTONIO. Consejero: SANTOS PAZ JOSE RAMON;RAMONPEREZ RODRIGUEZ;JESUS RODRIGUEZ LAGE;JOSE HILARIO RODRIGUEZ PARAPAR;LUIS GARCIA LOPEZ;PINO LADRAJUAN BAUTISTA;PINO MONTERO JOSE BAUTISTA;LOPEZ CANDIA FLORENTINO;LOPEZ CASAS JUAN RICARDO;JESUSMANUEL FERNANDEZ MIGUEZ. Datos registrales. T 417 , F 106, S 8, H LU 3253, I/A 31 ( 3.09.10).

18 de Marzo de 2010
Reelecciones. Auditor: CAPELLA PEREZ JUAN. Datos registrales. T 297 , F 5, S 8, H LU 3253, I/A 30 ( 4.03.10).

10 de Julio de 2009
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 1.848.600,08 Euros. Datos registrales. T 297 , F 5, S 8, H LU 3253, I/A 29(24.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n