Actos BORME de Pysec Seguridad Sa
27 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANCHEZ DONCEL FERNANDO. Nombramientos. Adm. Unico: RICAURTE CRUZ ELIANAMILENA. Datos registrales. T 13698 , F 220, S 8, H M 223279, I/A 18 (20.07.15).
24 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ DONCEL FERNANDO;RULE PROYECTOS SL;OCERETNI CORPORACION INDUSTRIALSA. Presidente: SANCHEZ DONCEL FERNANDO. Con.Delegado: SANCHEZ DONCEL FERNANDO. SecreNoConsj: MORENOACEDO LUIS MIGUEL. Representan: SANCHEZ DONCEL FERNANDO;MARTINEZ PERAN DIEGO. Revocaciones. Apoderado:SANCHEZ MARTINEZ PATRICIA;SANCHEZ MARTINEZ IVAN. Nombramientos. Adm. Unico: SANCHEZ DONCEL FERNANDO.Modificaciones estatutarias. 1. Modificaci贸n de la redacci贸n de los art铆culos de los estatutos sociales n煤meros 6, 7, 14, 15, 16, 17,18 y 25. . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 13698 , F 218, S 8, H M 223279, I/A 16 (17.07.15).
Cambio de domicilio social. C/ VIA DE LOS POBLADOS 17 (MADRID). Datos registrales. T 13698 , F 220, S 8, H M 223279, I/A17 (17.07.15).
08 de Noviembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ DONCEL FERNANDO;RAMON NIEVA SERGIO;CHEMLAL MOAOUIYA;ALONSOMOLINA RAUL. Presidente: SANCHEZ DONCEL FERNANDO. Con.Delegado: SANCHEZ DONCEL FERNANDO. Revocaciones.Apo.Sol.: SANCHEZ DONCEL FERNANDO. Apo.Man.Soli: RAMON NIEVA SERGIO;CHEMLAL MOAOUIYA;ALONSO MOLINARAUL;MORENO ACEDO LUIS MIGUEL. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ DONCEL FERNANDO;RULE PROYECTOSSL;OCERETNI CORPORACION INDUSTRIAL SA. Presidente: SANCHEZ DONCEL FERNANDO. Con.Delegado: SANCHEZ DONCELFERNANDO. SecreNoConsj: MORENO ACEDO LUIS MIGUEL. Representan: SANCHEZ DONCEL FERNANDO;MARTINEZ PERANDIEGO. Modificaciones estatutarias. 18. Administraci贸n y Representacion.-. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩ginaweb corporativa: www.pysec.com. Datos registrales. T 13698 , F 215, S 8, H M 223279, I/A 14 (30.10.13).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ MARTINEZ PATRICIA;SANCHEZ MARTINEZ IVAN;MORENO ACEDO LUISMIGUEL;SANCHEZ DONCEL ANTONIO. Datos registrales. T 13698 , F 216, S 8, H M 223279, I/A 15 (30.10.13).
15 de Febrero de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: GIL MARTIN JESUS;MOLINA MARTINEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 13698 , F 215, S 8, H M223279, I/A 13 ( 7.02.13).
02 de Noviembre de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: RAMON NIEVA SERGIO. Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ DONCEL FERNANDO;RAMONNIEVA SERGIO;CHEMLAL MOAOUIYA;ALONSO MOLINA RAUL. Nombramientos. SecreNoConsj: MORENO ACEDO LUISMIGUEL. Apo.Sol.: SANCHEZ DONCEL FERNANDO. Apo.Man.Soli: RAMON NIEVA SERGIO;CHEMLAL MOAOUIYA;ALONSOMOLINA RAUL;MORENO ACEDO LUIS MIGUEL.Apo.Sol.: GIL MARTIN JESUS;MOLINA MARTINEZ JOSE ANTONIO. Datosregistrales. T 13698 , F 190, S 8, H M 223279, I/A 12 (19.10.11).
07 de Marzo de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 29.160,88 Euros. Resultante Suscrito: 172.906,44 Euros. Modificaciones estatutarias.SE DA NUEVA REDACCION AL ARTICULO 25潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 13698 , F 189, S 8, H M223279, I/A 11 (24.02.11).
16 de Julio de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 52.506,44 Euros. Desembolsado: 52.506,44 Euros. Resultante Suscrito: 202.067,32 Euros.Resultante Desembolsado: 202.067,32 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datosregistrales. T 13698 , F 189, S 8, H M 223279, I/A 10 ( 1.07.10).
13 de Mayo de 2010Cambio de domicilio social. AVDA DE LA VIA LACTEA 1 - EDIFICIO AUGUSTA, POLIGO (SAN FERNANDO DE HENARES).Datos registrales. T 13698 , F 189, S 8, H M 223279, I/A 9 ( 3.05.10).
10 de Febrero de 2010Ampliacion del objeto social. LA PROTECCION DE PERSONAS DETERMINADAS, PREVIA LA AUTORIZACIONCORRESPONDIENTE, EL DEPOSITO, CUSTODIA, RECUENTO Y CLASIFICACION DE MONEDAS Y BILLETES, TITULOS,VALORES Y DEMAS OBJETOS QUE, POR SU VALOR ECONOMICO Y EXPECTATIVAS QUE GENEREN O POR SUPELIGROSIDAD, PUEDAN REQUERIR PROTECCION ESPECIAL,. Datos registrales. T 13698 , F 188, S 8, H M 223279, I/A 8(29.01.10).