Buscador CIF Logo

Actos BORME Pyton Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Pyton Sl

Actos BORME Pyton Sl - B08543076

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Pyton Sl con CIF B08543076

馃敊 Perfil de Pyton Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Pyton Sl

29 de Septiembre de 2023
Nombramientos. AUDIT.INDIV.: GM AUDITORS SL. Datos registrales. T 39700 , F 59, S 8, H B 49012, I/A 44 (21.09.23).

05 de Junio de 2023
Nombramientos. APOD.MANCOMU: GARCIA QUI脩ONES JUAN CARLOS;PRADES GONZALEZ MERCEDES. Datos registrales.T 39700 , F 58, S 8, H B 49012, I/A 43 (26.05.23).

11 de Mayo de 2022
Revocaciones. APODERAD.SOL: SONT HEILBRUNER ROBERTO. Datos registrales. T 39700 , F 58, S 8, H B 49012, I/A 42 (4.05.22).

07 de Abril de 2022
Revocaciones. APODERADO: GUTIERREZ SANCHEZ GLORIA;CIVERA GIMENO ROGER. APOD.MANCOMU: GUTIERREZSANCHEZ GLORIA;CIVERA GIMENO ROGER. Datos registrales. T 39700 , F 58, S 8, H B 49012, I/A 41 (30.03.22).

08 de Enero de 2021
Nombramientos. AUDIT.INDIV.: GM AUDITORS SL. Datos registrales. T 39700 , F 58, S 8, H B 49012, I/A 40 (28.12.20).

02 de Diciembre de 2020
Revocaciones. ADM.UNICO: ROB GESTION SL. REPR.143 RRM: SONT HEILBRUNER ROBERTO. Nombramientos.ADM.UNICO: SONT COLOMER JOSE. Datos registrales. T 39700 , F 56, S 8, H B 49012, I/A 38 (24.11.20).

Revocaciones. APODERADO: COLOMER KAMMULLER CRISTINA. Nombramientos. APODERAD.SOL: SONT HEILBRUNERROBERTO. Datos registrales. T 39700 , F 56, S 8, H B 49012, I/A 39 (24.11.20).

04 de Abril de 2017
Nombramientos. AUDIT.INDIV.: GM AUDITORS SL. Datos registrales. T 39700 , F 56, S 8, H B 49012, I/A 37 (28.03.17).

15 de Abril de 2016
Nombramientos. APOD.MANCOMU: PRADES GONZALEZ MERCEDES;GARCIA QUI脩ONES JUAN CARLOS;GUTIERREZSANCHEZ GLORIA;CIVERA GIMENO ROGER. Datos registrales. T 39700 , F 56, S 8, H B 49012, I/A 36 ( 7.04.16).

20 de Febrero de 2015
Revocaciones. APODERADO: GARCIA SANCHEZ JULIAN;GARCIA SANCHEZ JULIAN. Datos registrales. T 39700 , F 55, S 8, HB 49012, I/A 35 (12.02.15).

28 de Enero de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.636.004,00 Euros. Datos registrales. T 39700 , F 55, S8, H B 49012, I/A 34 (21.01.15).

22 de Enero de 2015
Revocaciones. ADMINISTR.: SONT HEILBRUNER ROBERTO. Nombramientos. ADM.UNICO: ROB GESTION SL. REPR.143RRM: SONT HEILBRUNER ROBERTO. Datos registrales. T 39700 , F 54, S 8, H B 49012, I/A 33 (12.01.15).

22 de Abril de 2014
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GM AUDITORS SL. AUDT.CTS.CON: GM AUDITORS SL. Datos registrales. T 39700 , F 54, S 8,H B 49012, I/A 32 (10.04.14).

30 de Junio de 2011
Nombramientos. APODERADO: CIVERA GIMENO ROGER. Datos registrales. T 39700 , F 53, S 8, H B 49012, I/A 31 (20.06.11).

11 de Octubre de 2010
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GM AUDITORS SL. Datos registrales. T 39700 , F 53, S 8, H B 49012, I/A 30 (29.09.10).

15 de Abril de 2010
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GM AUDITORS SL. Datos registrales. T 39700 , F 53, S 8, H B 49012, I/A 29 ( 1.04.10).

23 de Octubre de 2009
Otros conceptos: DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SOCIO UNICO:"ROB GESTION, S.L.". Datos registrales. T39700 , F 52, S 8, H B 49012, I/A 28 ( 9.10.09).

18 de Marzo de 2009
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GM AUDITORS SL. Datos registrales. T 39700 , F 52, S 8, H B 49012, I/A 27 ( 5.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n