Buscador CIF Logo

Actos BORME Qipro Soluciones Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Qipro Soluciones Sl

Actos BORME Qipro Soluciones Sl - B93435865

Tenemos registrados 43 Actos BORME del Registro Mercantil de Malaga para Qipro Soluciones Sl con CIF B93435865

馃敊 Perfil de Qipro Soluciones Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Malaga

Actos BORME de Qipro Soluciones Sl

21 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: MAYOR VALDERICEDA IRENE;FRIAS CORDOBA ENRIQUE. Datos registrales. T 6125, L 5032, F 23,S 8, H MA130928, I/A 42 (15.12.23).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ CARCEDO VIRGINIA. Datos registrales. T 6125, L 5032, F 23, S 8, H MA130928, I/A 43(15.12.23).

31 de Octubre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUZMAN ARRUE INES. Nombramientos. Consejero: IDIRIN GONZALEZ NEREA. Datosregistrales. T 6125, L 5032, F 23, S 8, H MA130928, I/A 41 (24.10.23).

21 de Julio de 2023
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 6125, L 5032, F 22, S 8, H MA130928, I/A 38 (13.07.23).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ CRUZ AMPARO. Datos registrales. T 6125, L 5032, F 22, S 8, H MA130928, I/A 39(13.07.23).

Nombramientos. Apoderado: CONILL FERRANDO NATALIA. Datos registrales. T 6125, L 5032, F 22, S 8, H MA130928, I/A 40(13.07.23).

13 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ CASAL ESTHER. Datos registrales. T 6125, L 5032, F 21, S 8, H MA130928, I/A 36 (2.03.23).

Revocaciones. Apo.Sol.: PE脩A GARCIA DOLORES;PRIETO ARIAS PILAR;SANDOVAL BARTULOS CONSTANTINO OSCAR.Apoderado: GARCIA SALCEDO MARIA INES. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PE脩A GARCIA DOLORES;PRIETO ARIASPILAR;SANDOVAL BARTULOS CONSTANTINO OSCAR. Apo.Sol.: GARCIA SALCEDO MARIA INES. Datos registrales. T 6125, L5032, F 21, S 8, H MA130928, I/A 37 ( 2.03.23).

12 de Diciembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: GARRIDO-ARROQUIA NOVES JOAQUINA. Datos registrales. T 6125, L 5032, F 20, S 8, H MA130928,I/A 34 (29.11.22).

Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ GARCIA DIEGO. Datos registrales. T 6125, L 5032, F 21, S 8, H MA130928, I/A 35(29.11.22).

03 de Noviembre de 2022
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 6125, L 5032, F 19, S 8, H MA130928, I/A 31 (19.10.22).

Nombramientos. Apoderado: CORDERO PEREZ DAVID. Datos registrales. T 6125, L 5032, F 20, S 8, H MA130928, I/A 33(19.10.22).

26 de Julio de 2022
Modificaciones estatutarias. 22潞. Cierre del Ejercicio.-. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/8. Datos registrales. T 6125, L 5032, F 19,S 8, H MA130928, I/A 30 (14.07.22).

22 de Febrero de 2022
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA. Ceses/Dimisiones. Consejero:MONTA脩EZ NU脩EZ MYRIAM;ANDRES PEREZ DAVID;HERAS PASCUAL MARIO;NAVARRO MARTIN ANGEL MARIA;BENAVIDESYANGUAS PABLO. SecreNoConsj: LOPEZ RAMON FRANCISCO MANUEL. Presidente: BENAVIDES YANGUAS PABLO.Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA LOPEZ NIEVES. Consejero: LOPEZ ABELLAN DIEGO. Presidente: LOPEZ ABELLANDIEGO. Consejero: CORDERO PEREZ DAVID;GUZMAN ARRUE INES. Datos registrales. T 5631, L 4538, F 86, S 8, H MA130928,I/A 19 ( 8.02.22).

Revocaciones. Apoderado: NAVARRO MARTIN ANGEL MARIA. Apo.Sol.: ALVAREZ OROZCO MARIA DEL CARMEN. Apoderado:HIDALGO MILLA RAUL. Datos registrales. T 5631, L 4538, F 86, S 8, H MA130928, I/A 20 ( 8.02.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ ABELLAN DIEGO;CORDERO PEREZ DAVID;GUZMAN ARRUE INES. Datos registrales. T5631, L 4538, F 86, S 8, H MA130928, I/A 21 ( 8.02.22).

Nombramientos. Apoderado: ALBERTOS MINGUELA TERESA. Datos registrales. T 5631, L 4538, F 87, S 8, H MA130928, I/A 22 (8.02.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: PE脩A GARCIA DOLORES;PRIETO ARIAS PILAR;SANDOVAL BARTULOS CONSTANTINO OSCAR.Datos registrales. T 5631, L 4538, F 87, S 8, H MA130928, I/A 23 ( 8.02.22).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA SALCEDO MARIA INES. Datos registrales. T 6125, L 5032, F 17, S 8, H MA130928, I/A 24 (8.02.22).

Nombramientos. Apoderado: GARRIDO-ARROQUIA NOVES JOAQUINA. Datos registrales. T 6125, L 5032, F 17, S 8, HMA130928, I/A 25 ( 8.02.22).

Nombramientos. Apoderado: SOBRINOS IGLESIAS MARIA JOSE. Datos registrales. T 6125, L 5032, F 18, S 8, H MA130928, I/A26 ( 8.02.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: PINAR HORCAJADA BELEN;AROCHENA GARCIA-PAGE ANA;GINES VILLARINO AGUEDA. Datosregistrales. T 6125, L 5032, F 18, S 8, H MA130928, I/A 27 ( 8.02.22).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GIMENO SANTIAGO. Datos registrales. T 6125, L 5032, F 19, S 8, H MA130928, I/A 28 (8.02.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA LOPEZ NIEVES;GONZALEZ CARCEDO VIRGINIA;MOSCARDO DELGADO DE ROBLES LUISMIGUEL. Datos registrales. T 6125, L 5032, F 19, S 8, H MA130928, I/A 29 ( 8.02.22).

27 de Octubre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: VARGAS CARRION JOSE ANTONIO. Nombramientos. Consejero: MONTA脩EZ NU脩EZ MYRIAM.Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 5631, L 4538, F 86, S 8, H MA130928, I/A 18 (18.10.21).

30 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ MORENO AMALIA. Nombramientos. Consejero: ANDRES PEREZ DAVID. Datosregistrales. T 5631, L 4538, F 85, S 8, H MA130928, I/A 16 (22.06.21).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RODRIGUEZ FUENTES FEDERICO. Nombramientos. SecreNoConsj: LOPEZ RAMONFRANCISCO MANUEL. Datos registrales. T 5631, L 4538, F 85, S 8, H MA130928, I/A 17 (22.06.21).

29 de Enero de 2021
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 5631, L 4538, F 85, S 8, H MA130928, I/A 14 (19.01.21).

Modificaciones estatutarias. 16潞. Otros.-. Datos registrales. T 5631, L 4538, F 85, S 8, H MA130928, I/A 15 (19.01.21).

20 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: MU脩IZ FABAL GRACIELA. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ MORENO AMALIA;VARGASCARRION JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 5631, L 4538, F 84, S 8, H MA130928, I/A 13 (13.12.19).

16 de Abril de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MILLAN BENAYAS RUBEN. Apo.Sol.: MILLAN BENAYAS RUBEN. Nombramientos. Apoderado:SANCHEZ CASAL ESTHER. Datos registrales. T 5631, L 4538, F 82, S 8, H MA130928, I/A 12 ( 4.04.19).

20 de Diciembre de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5518, L 4425, F 175, S 8, H MA130928, I/A 8 ( 3.11.16).

Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5631, L 4538, F 82, S 8, H MA130928, I/A 10 (12.12.17).

Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 5631, L 4538, F 82, S 8, H MA130928, I/A 11 (12.12.17).

28 de Junio de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: MILLAN BENAYAS RUBEN;AHUMADA MUNTANE LUIS. Apoderado: HIDALGO MILLA RAUL. Datosregistrales. T 5518, L 4425, F 176, S 8, H MA130928, I/A 9 (15.06.17).

16 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5518, L 4425, F 175, S 8, H MA130928, I/A 7 ( 3.11.16).

Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ PINILLA ALFREDO JOSE. Presidente: RODRIGUEZ PINILLA ALFREDO JOSE.SecreNoConsj: PALACIO BERMUDEZ DE CASTRO ELIAS. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Consejero: BENAVIDESYANGUAS PABLO. Presidente: BENAVIDES YANGUAS PABLO. SecreNoConsj: RODRIGUEZ FUENTES FEDERICO. Datosregistrales. T 5518, L 4425, F 175, S 8, H MA130928, I/A 8 ( 3.11.16).

03 de Agosto de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MILLAN BENAYAS RUBEN. Apo.Sol.: PIGNATELLI ALIX ALICIA. Datos registrales. T 5518, L4425, F 173, S 8, H MA130928, I/A 5 (25.07.16).

P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 5518, L 4425, F 175, S 8, H MA130928, I/A 6 (25.07.16).

30 de Mayo de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRICABEITIA IGARTUA JOSE FELIX;BA脩ALES PASCUAL JOSE RAMON;BEADE LOPEZALFONSO Datos registrales. T 5454, L 4361, F 44, S 8, H MA130928, I/A 3 (20.05.16).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAVIO FANI OZIEL;AHUMADA MUNTANE LUIS. Datos registrales. T 5454, L 4361, F 45, S 8, HMA130928, I/A 4 (20.05.16).

03 de Marzo de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.400.000,00 Euros. Datos registrales. T 5454, L 4361, F42, S 8, H MA130928, I/A 2 (23.02.16).

26 de Noviembre de 2015
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 28.10.15. Objeto social: La prestaci贸n de servicios de consultor铆a de planificaci贸n,organizaci贸n de empresas y contabilidad, administrativos, organizativos, operacionales, inform谩ticos y de intermediaci贸n en la gesti贸nde cobro por servicios prestados por empresas y particulares. Domicilio: C/ SEVERO OCHOA 55 - PARQUE TECNOLOGICO DEANDALUC (MALAGA). Capital: 3.000.000,00 Euros. Nombramientos. SecreNoConsj: PALACIO BERMUDEZ DE CASTRO ELIAS.Consejero: RODRIGUEZ PINILLA ALFREDO JOSE. Presidente: RODRIGUEZ PINILLA ALFREDO JOSE. Consejero: NAVARROMARTIN ANGEL MARIA;MU脩IZ FABAL GRACIELA;HERAS PASCUAL MARIO. Apoderado: NAVARRO MARTIN ANGEL MARIA.Apo.Sol.: VAZQUEZ DURAN GABRIEL;PEREZ SALCEDO ANA;MOLINA ORTEGA DAVID;ORUSCO ALMAZANEDUARDO;TORRIJOS FUENSALIDA ANGEL;ALVAREZ OROZCO MARIA DEL CARMEN;HUERTAS CUESTA ROCIO. Datosregistrales. T 5454, L 4361, F 39, S 8, H MA130928, I/A 1 (18.11.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n