Actos BORME de Quabit Distrito Centro Sl
27 de Abril de 2022Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 41593 , F 191, S 8, H M 644583, I/A 18 (20.04.22).
22 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: PRIETO RUIZ JAVIER MANUEL;HERRANZ GARCIA MIGUEL ANGEL. Apoderado: PRIETO RUIZJAVIER MANUEL;HERRANZ GARCIA MIGUEL ANGEL;RUIZ GARCIA EDUARDO;SANCHEZ DE LAMADRID CAMPSGABRIEL;MELERO BOWEN MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 41593 , F 191, S 8, H M 644583, I/A 17 (15.12.21).
14 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: QUABIT INMOBILIARIA SA. Representan: ABANADES LOPEZ FELIX. Nombramientos. Adm.Unico: GARCIA-EGOCHEAGA VERGARA FRANCISCO DE BORJA. Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANANUMERO 20, 6陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 36600 , F 177, S 8, H M 644583, I/A 15 ( 7.06.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARGEMI GARCIA JORDI. Apo.Manc.: GARCIA-EGOCHEAGA VERGARA FRANCISCO DEBORJA;BASCARAN AMORRORTU ANA;ESPINOSA HURTADO EVANGELINA;POMBO ALDECOA IGNACIO;RICO PALACIOSNURIA;FORTUNY ELGUER SILVIA;MORENO BERRAL MARIA JOSE;EGUSQUIZA GONZALEZ-GIL JULIO;LAPIEDRA VIVANCOMARIO;SANCHEZ CASSINELLO GABRIEL;HERNANZ DE DUE脩AS FERNANDO;BASCARAN AMORRORTU ANA;ESPINOSAHURTADO EVANGELINA;POMBO ALDECOA IGNACIO;RICO PALACIOS NURIA;FORTUNY ELGUER SILVIA;MORENO BERRALMARIA JOSE. Datos registrales. T 36600 , F 178, S 8, H M 644583, I/A 16 ( 7.06.21).
03 de Noviembre de 2020Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ DE LA CUEVA RAFAEL. Datos registrales. T 36600 , F 177, S 8, H M 644583, I/A 14(26.10.20).
18 de Mayo de 2020Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ HERNANDEZ SILVIA-MARIA. Datos registrales. T 36600 , F 177, S 8, H M 644583, I/A 13( 8.05.20).
25 de Julio de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ HERNANDEZ SILVIA-MARIA. Datos registrales. T 36600 , F 175, S 8, H M 644583, I/A12 (18.07.19).
16 de Abril de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: DIAZ ALMENARA SONIA. Apoderado: DIAZ ALMENARA SONIA. Datos registrales. T 36600 , F 175,S 8, H M 644583, I/A 11 ( 9.04.19).
17 de Julio de 2018Modificaciones estatutarias. 9. Datos registrales. T 36600 , F 174, S 8, H M 644583, I/A 10 ( 9.07.18).
11 de Julio de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: PRIETO RUIZ JAVIER MANUEL;HERRANZ GARCIA MIGUEL ANGEL;DIAZ SANZ NURIA;PRIETO RUIZJAVIER MANUEL;HERRANZ GARCIA MIGUEL ANGEL;DIAZ SANZ NURIA. Datos registrales. T 36600 , F 173, S 8, H M 644583,I/A 9 ( 4.07.18).
14 de Diciembre de 2017Nombramientos. Apoderado: MELERO BOWEN MIGUEL ANGEL;DIAZ SANZ NURIA;AREVALO AGRELA MARIA ANGELES.Datos registrales. T 36600 , F 171, S 8, H M 644583, I/A 8 ( 4.12.17).
27 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: PRIETO RUIZ JAVIER MANUEL;CLAVEL VILLANUEVA MIGUEL ANGEL;HERRANZ GARCIA MIGUELANGEL;GONZALEZ DE LA CUEVA RAFAEL;DIAZ ALMENARA SONIA;RUIZ GARCIA EDUARDO;SANCHEZ DE LAMADRID CAMPSGABRIEL;HERRERIAS POZO FRANCISCO. Datos registrales. T 35875 , F 70, S 8, H M 644583, I/A 7 (17.11.17).
15 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: CANDELA SAHUQUILLO ANTONIO;SANTISO POZO MANUEL. Datos registrales. T 35875 , F 69, S8, H M 644583, I/A 6 ( 6.11.17).
10 de Octubre de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIAZ ALMENARA SONIA. Datos registrales. T 35875 , F 67, S 8, H M 644583, I/A 5 ( 3.10.17).
15 de Septiembre de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 800.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.030.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: ARTICULO 6.-. Datos registrales. T 35875 , F 67, S 8, H M 644583, I/A 4 ( 7.09.17).
25 de Mayo de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.800.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.830.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 6. Capital social.-. Datos registrales. T 35875 , F 66, S 8, H M 644583, I/A 3 (17.05.17).
05 de Mayo de 2017Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 6.04.17. Objeto social: 1. La promoci贸n, construcci贸n, rehabilitaci贸n, venta, conservaci贸n yexplotaci贸n, incluido el arrendamiento no financiero de todo tipo de fincas y edificaciones, tales como viviendas, urbanizaciones,establecimientos y complejos industriales, hoteleros, sanitarios, deportivos, docentes, culturales y. Domicilio: C/ CAPITAN HAYA 1 16潞(MADRID). Capital: 30.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GLOBAL QUABIT SL. Nombramientos. Adm.Unico: QUABIT INMOBILIARIA SA. Representan: ABANADES LOPEZ FELIX. Datos registrales. T 35875 , F 63, S 8, H M 644583, I/A1 (25.04.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PRIETO RUIZ JAVIER MANUEL;HERRANZ GARCIA MIGUEL ANGEL;CLAVEL VILLANUEVAMIGUEL ANGEL;CANDELA SAHUQUILLO ANTONIO;SANTISO POZO MANUEL;ALGARATE GONZALO JORGE. Datos registrales.T 35875 , F 64, S 8, H M 644583, I/A 2 (25.04.17).