Buscador CIF Logo

Actos BORME Quavitae Servicios Asistenciales Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Quavitae Servicios Asistenciales Sa

Actos BORME Quavitae Servicios Asistenciales Sa - A80106842

Tenemos registrados 267 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Quavitae Servicios Asistenciales Sa con CIF A80106842

馃敊 Perfil de Quavitae Servicios Asistenciales Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Quavitae Servicios Asistenciales Sa

22 de Noviembre de 2023
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 38388 , F 160, S 8, H M 33105, I/A 414 (15.11.23).

03 de Noviembre de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: OLIVER MOREY AINA MARIA. Nombramientos. Apoderado: ROTGER VIVES AINA. Datos registrales.T 38388 , F 158, S 8, H M 33105, I/A 409 (26.10.23).

Revocaciones. Apo.Sol.: BEIZAMA AZCUE TERESA. Nombramientos. Apoderado: ISASA RODRIGUEZ IDOIA. Datosregistrales. T 38388 , F 158, S 8, H M 33105, I/A 410 (26.10.23).

Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ LAVADO ESTRELLA ANGELES. Nombramientos. Apoderado: ESCARCENA GOMEZMARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 38388 , F 159, S 8, H M 33105, I/A 411 (26.10.23).

Nombramientos. Apoderado: ABALDE LOPEZ ANTIA. Datos registrales. T 38388 , F 159, S 8, H M 33105, I/A 412 (26.10.23).

Nombramientos. Apoderado: TESTA CANDALES MIGUEL. Datos registrales. T 38388 , F 160, S 8, H M 33105, I/A 413 (26.10.23).

18 de Agosto de 2023
Nombramientos. Apoderado: SOLLA TORRES JOSE MANUEL. Datos registrales. T 38388 , F 157, S 8, H M 33105, I/A 408(10.08.23).

10 de Agosto de 2023
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ALVAREZ ADELA GUIOMAR;DEL MONTE ESPINOSA MARIA. Datos registrales. T38388 , F 157, S 8, H M 33105, I/A 406 ( 3.08.23).

Revocaciones. Apo.Sol.: BERMUDEZ EIJO BIBIANA. Datos registrales. T 38388 , F 157, S 8, H M 33105, I/A 407 ( 3.08.23).

08 de Junio de 2023
Cambio de domicilio social. C/ ULISES 16-18 - 5陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 38388 , F 152, S 8, H M 33105, I/A 396( 1.06.23).

25 de Mayo de 2023
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ BUITRON BEGO脩A. Datos registrales. T 38388 , F 152, S 8, H M 33105, I/A 395(17.05.23).

24 de Mayo de 2023
Nombramientos. Apoderado: ALZAMORA CA脩ERO ELENA. Datos registrales. T 38388 , F 151, S 8, H M 33105, I/A 394(17.05.23).

23 de Mayo de 2023
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ CASTRO ANGELA. Datos registrales. T 38388 , F 151, S 8, H M 33105, I/A 393(16.05.23).

28 de Abril de 2023
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ LOPEZ FELIX. Datos registrales. T 38388 , F 150, S 8, H M 33105, I/A 390 (21.04.23).

Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ CALAVIA JAVIER;JIMENEZ CALAVIA JAVIER. Datos registrales. T 38388 , F 150, S 8, H M33105, I/A 391 (21.04.23).

Revocaciones. Apo.Sol.: ABASCAL CASTA脩ON ALVARO-MARIA. Datos registrales. T 38388 , F 151, S 8, H M 33105, I/A 392(21.04.23).

14 de Abril de 2023
Nombramientos. Apoderado: VILLANUEVA IZQUIERDO LORENA. Datos registrales. T 38388 , F 149, S 8, H M 33105, I/A 386 (9.04.23).

Nombramientos. Apoderado: SOLA CASTI脩EIRAS PAULA. Datos registrales. T 38388 , F 149, S 8, H M 33105, I/A 387 ( 9.04.23).

Nombramientos. Apoderado: SOBRINO RASERO JOSE. Datos registrales. T 38388 , F 149, S 8, H M 33105, I/A 388 ( 9.04.23).

Revocaciones. Apo.Sol.: ALVAREZ MIR MARTA. Nombramientos. Apoderado: ORTEGA SANCHEZ ANTONIO MIGUEL. Datosregistrales. T 38388 , F 150, S 8, H M 33105, I/A 389 ( 9.04.23).

13 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 38388 , F 148, S 8, H M 33105, I/A 385 ( 6.03.23).

10 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: CANO CRUZ SUSANA. Datos registrales. T 38388 , F 148, S 8, H M 33105, I/A 384 ( 3.03.23).

10 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: ASENSIO OLASO IGNACIO. Datos registrales. T 38388 , F 147, S 8, H M 33105, I/A 380 ( 3.02.23).

Nombramientos. Apoderado: ESTAPE FRAU FELISA. Datos registrales. T 38388 , F 147, S 8, H M 33105, I/A 381 ( 3.02.23).

Nombramientos. Apoderado: COMPTE BOIX ALMUDENA. Datos registrales. T 38388 , F 147, S 8, H M 33105, I/A 382 ( 3.02.23).

Nombramientos. Apoderado: MATAS MELIS CRISTINA. Datos registrales. T 38388 , F 148, S 8, H M 33105, I/A 383 ( 3.02.23).

05 de Enero de 2023
Nombramientos. Apoderado: GISBERT EIJO MARIA MOI脩A. Datos registrales. T 38388 , F 146, S 8, H M 33105, I/A 379(29.12.22).

12 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: MONTERO QUINTELA SANDRA;LOPEZ MENDEZ JULITA;TAUSTE BAUTISTA HUGO;LAGUNAVALENZUELA MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 38388 , F 146, S 8, H M 33105, I/A 378 ( 1.12.22).

09 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: ROSALES VELARDE INMACULADA. Datos registrales. T 38388 , F 145, S 8, H M 33105, I/A 377(30.11.22).

05 de Diciembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: PUMARES GOMEZ MARIA BELEN. Nombramientos. Apo.Sol.: BERMUDEZ EIJO BIBIANA. Datosregistrales. T 38388 , F 143, S 8, H M 33105, I/A 372 (28.11.22).

Revocaciones. Apo.Sol.: CANTERO LOPEZ MARIA TERESA. Nombramientos. Apo.Sol.: SERRANO SERRANO SANDRA. Datosregistrales. T 38388 , F 144, S 8, H M 33105, I/A 373 (28.11.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: OLIVER MOREY AINA MARIA. Datos registrales. T 38388 , F 144, S 8, H M 33105, I/A 374 (28.11.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: PACHECO GONZALEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 38388 , F 144, S 8, H M 33105, I/A 375(28.11.22).

Revocaciones. Apoderado: MELO IZQUIERDO ROSA MARIA. Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA BUSTAMANTE MARIAANGELES. Datos registrales. T 38388 , F 145, S 8, H M 33105, I/A 376 (28.11.22).

28 de Noviembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Apo.Sol.: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Nombramientos.Apoderado: RUBIO PERIA脩EZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 38388 , F 143, S 8, H M 33105, I/A 371 (21.11.22).

26 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apoderado: CUETO FAUS JOSE LUIS;CUETO FAUS JOSE LUIS;CUETO FAUS JOSE LUIS. Nombramientos.Apoderado: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Datos registrales. T 38388 , F 142, S 8, H M 33105, I/A 370 (19.10.22).

30 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 38388 , F 139, S 8, H M 33105, I/A 367(23.08.22).

Nombramientos. Apoderado: TABOADA VAZQUEZ ANTONIO. Datos registrales. T 38388 , F 141, S 8, H M 33105, I/A 368(23.08.22).

Nombramientos. Apoderado: MOZAS POVEDA JOAQUINA. Datos registrales. T 38388 , F 141, S 8, H M 33105, I/A 369(23.08.22).

26 de Julio de 2022
Revocaciones. Apoderado: BARREIRA VIVIAN VICTORIA. Datos registrales. T 38388 , F 138, S 8, H M 33105, I/A 364 (18.07.22).

Revocaciones. Apoderado: ISASI AYUSO ANA ISABEL. Nombramientos. Apoderado: RETANA GONZALEZ NOELIA. Datosregistrales. T 38388 , F 139, S 8, H M 33105, I/A 365 (18.07.22).

Revocaciones. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 38388 , F 139, S 8, H M33105, I/A 366 (18.07.22).

12 de Julio de 2022
Nombramientos. Apoderado: LAGO COLLAR RAQUEL. Datos registrales. T 38388 , F 138, S 8, H M 33105, I/A 362 ( 5.07.22).

Nombramientos. Apoderado: MESA RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD. Datos registrales. T 38388 , F 138, S 8, H M 33105, I/A 363 (5.07.22).

01 de Julio de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: SALABERRIA INDACOECHEA ENDARA. Datos registrales. T 38388 , F 137, S 8, H M 33105, I/A 361(24.06.22).

21 de Junio de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ YA脩EZ OLGA. Datos registrales. T 38388 , F 136, S 8, H M 33105, I/A 359 (14.06.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: DELGADO MONTELIU LORENA. Datos registrales. T 38388 , F 137, S 8, H M 33105, I/A 360(14.06.22).

17 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 38388 , F 135, S 8, H M 33105, I/A 358 ( 9.05.22).

27 de Abril de 2022
Nombramientos. Apoderado: RIOS FAGUNDO RODRIGO. Datos registrales. T 38388 , F 134, S 8, H M 33105, I/A 356 (20.04.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: FISCALETTI MARQUES MARINA. Datos registrales. T 38388 , F 135, S 8, H M 33105, I/A 357(20.04.22).

22 de Febrero de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA-ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: GERIAVI SA.Representan: PENA RODRIGUEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 38388 , F 134, S 8, H M 33105, I/A 355 (15.02.22).

21 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apoderado: PEREIRA CARRIL FABIAN. Datos registrales. T 38388 , F 133, S 8, H M 33105, I/A 354 (14.02.22).

11 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ DE LA TAJADA MARINA. Datos registrales. T 38388 , F 133, S 8, H M 33105, I/A 352 (4.02.22).

Revocaciones. Apoderado: GARCIA BARREIRO GLORIA MARIA. Datos registrales. T 38388 , F 133, S 8, H M 33105, I/A 353 (4.02.22).

29 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ DE ARELLANO GUERRA ISABEL DEL ROCIO. Datos registrales. T 38388 , F 133, S 8, HM 33105, I/A 351 (22.12.21).

28 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 38388 , F 131, S 8, H M 33105, I/A 348 (21.12.21).

Nombramientos. Apoderado: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 38388 , F 132, S 8, H M 33105, I/A 349 (21.12.21).

Nombramientos. Apoderado: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 38388 , F 132, S 8, H M 33105, I/A 350(21.12.21).

20 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: EIXERES RAMBLA RAQUEL. Datos registrales. T 38388 , F 131, S 8, H M 33105, I/A 347 (10.12.21).

16 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: REQUENA GARMENDIA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 38388 , F 131, S 8, H M 33105, I/A346 ( 9.12.21).

02 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 38388 , F 128, S 8, H M 33105, I/A 345 (25.11.21).

30 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 38388 , F 128, S 8, H M 33105, I/A 344 (23.11.21).

02 de Agosto de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: MORENO BORT CARMEN. Datos registrales. T 38388 , F 127, S 8, H M 33105, I/A 343 (26.07.21).

16 de Julio de 2021
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ DE LA TAJADA MARINA. Datos registrales. T 38388 , F 126, S 8, H M 33105, I/A 340 (9.07.21).

Nombramientos. Apoderado: SALES BALLE AURORA. Datos registrales. T 38388 , F 126, S 8, H M 33105, I/A 341 ( 9.07.21).

Nombramientos. Apoderado: TENA SOTO ROSANA. Datos registrales. T 38388 , F 127, S 8, H M 33105, I/A 342 ( 9.07.21).

23 de Junio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: MONTEJANO BERMUDEZ MARIA. Datos registrales. T 38388 , F 126, S 8, H M 33105, I/A 339(16.06.21).

17 de Junio de 2021
Revocaciones. Apoderado: DURAN BENGOECHEA INGRID. Datos registrales. T 38388 , F 125, S 8, H M 33105, I/A 338(10.06.21).

25 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ MARTINEZ MARTA. Datos registrales. T 38388 , F 125, S 8, H M 33105, I/A 336 (18.05.21).

Revocaciones. Apoderado: HIPOLITO GOMEZ MARIA ROSA. Datos registrales. T 38388 , F 125, S 8, H M 33105, I/A 337(18.05.21).

20 de Abril de 2021
Nombramientos. Apoderado: ORTU脩O TERRIZA LOURDES. Datos registrales. T 38388 , F 124, S 8, H M 33105, I/A 334(13.04.21).

Nombramientos. Apoderado: MELO IZQUIERDO ROSA MARIA. Datos registrales. T 38388 , F 124, S 8, H M 33105, I/A 335(13.04.21).

05 de Abril de 2021
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GERIAVI SA. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas:QUAVITAE RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL SL. SARQUAVITAE SERVICIOS A LA DEPENDENCIA SL. Escisi贸n parcial.Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL SA. Datos registrales. T 38388 , F 118, S 8, H M33105, I/A 333 (25.03.21).

10 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: TUDELA SOLANO VICTOR. Datos registrales. T 38388 , F 118, S 8, H M 33105, I/A 332 ( 3.03.21).

01 de Marzo de 2021
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: AZUL CENTROS RESIDENCIALES SA. Datos registrales. T 38388 , F 116, S 8, HM 33105, I/A 329 (22.02.21).

Revocaciones. Apo.Sol.: POZANCO NIETO MIRIAM. Datos registrales. T 38388 , F 117, S 8, H M 33105, I/A 330 (22.02.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: CANO CRUZ SUSANA. Datos registrales. T 38388 , F 117, S 8, H M 33105, I/A 331 (22.02.21).

24 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apoderado: NU脩EZ GRANADOS BLANCA. Datos registrales. T 38388 , F 116, S 8, H M 33105, I/A 328(17.02.21).

08 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apoderado: SERRATO MARTINEZ JAVIER. Datos registrales. T 38388 , F 115, S 8, H M 33105, I/A 326 (1.02.21).

Nombramientos. Apoderado: LEIS CARRIL ROSA MARIA. Datos registrales. T 38388 , F 116, S 8, H M 33105, I/A 327 ( 1.02.21).

22 de Enero de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: CARPETANO ARIZA JESSICA. Datos registrales. T 38388 , F 114, S 8, H M 33105, I/A 324 (15.01.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: CARRION GOMEZ OFELIA. Datos registrales. T 38388 , F 115, S 8, H M 33105, I/A 325 (15.01.21).

21 de Enero de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: PIJUAN GALITO JUDIT. Datos registrales. T 38388 , F 114, S 8, H M 33105, I/A 323 (14.01.21).

11 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: SANZ AMAYA SARA. Datos registrales. T 38388 , F 113, S 8, H M 33105, I/A 321 ( 2.12.20).

Revocaciones. Apoderado: AMER FORTEZA LOURDES. Datos registrales. T 38388 , F 114, S 8, H M 33105, I/A 322 ( 2.12.20).

16 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apoderado: HONORATO GUZMAN JORGE;SANJUAN CORTES JOSE MARIA;GALAN COLLANTESAUXILIADORA. Datos registrales. T 38388 , F 113, S 8, H M 33105, I/A 320 ( 8.10.20).

30 de Septiembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: DOMINGO TORRA LAURA;DOMINGO TORRA LAURA. Datos registrales. T 38388 , F 113, S 8, H M33105, I/A 319 (23.09.20).

05 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 38388 , F 112, S 8, H M 33105,I/A 318 (29.07.20).

04 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 38388 , F 112, S 8, H M 33105, I/A 317 (28.07.20).

22 de Julio de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 38388 , F 112, S 8, H M 33105, I/A 316 (15.07.20).

15 de Junio de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: BUSTINZA CORDERO NATALIA. Datos registrales. T 38388 , F 111, S 8, H M 33105, I/A 315 (8.06.20).

12 de Junio de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: SIGHIN LARISA. Datos registrales. T 38388 , F 111, S 8, H M 33105, I/A 314 ( 7.06.20).

04 de Mayo de 2020
Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 38388 , F 111, S 8, H M 33105, I/A 313 (24.04.20).

27 de Abril de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA-OSORIO PRADO MARIA PAZ. Datos registrales. T 38388 , F 110, S 8, H M 33105, I/A 312(20.04.20).

16 de Abril de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: QUAVITAE RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL SL. Representan: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFAISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA-ISABEL. Datos registrales. T 38388 , F 110, S 8, H M33105, I/A 311 ( 7.04.20).

13 de Noviembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: PRIEGO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 38388 , F 110, S 8, H M 33105, I/A 310 ( 6.11.19).

12 de Julio de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LORENZO DIEGO. Datos registrales. T 38388 , F 109, S 8, H M 33105, I/A 308 ( 5.07.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: PERALTA ABAD MARIA ESPERANZA. Datos registrales. T 38388 , F 109, S 8, H M 33105, I/A 309 (5.07.19).

01 de Julio de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: ERA脩A VILLA YOLANDA. Datos registrales. T 38388 , F 109, S 8, H M 33105, I/A 307 (24.06.19).

18 de Junio de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: VILLAR CEBRAL ANA. Datos registrales. T 38388 , F 108, S 8, H M 33105, I/A 305 (11.06.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: POZANCO NIETO MIRIAM. Datos registrales. T 38388 , F 108, S 8, H M 33105, I/A 306 (11.06.19).

17 de Junio de 2019
Revocaciones. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 38388 , F 108, S 8, H M 33105, I/A 304 (10.06.19).

22 de Mayo de 2019
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 256陋 EL PODER OTORGADO A SOLER VICENS ANTONIO,SIENDO LO CORRECTO SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 31903 , F 212, S 8, H M 33105, I/A 256 (26.09.17).

30 de Abril de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: TABOADA FERNANDEZ MARIA. Datos registrales. T 38388 , F 107, S 8, H M 33105, I/A 303(23.04.19).

09 de Abril de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ MIR MARTA. Datos registrales. T 38388 , F 106, S 8, H M 33105, I/A 301 ( 2.04.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: MAYORAL CARRIZOSA MARIA ISABEL. Datos registrales. T 38388 , F 107, S 8, H M 33105, I/A 302 (2.04.19).

13 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apoderado: GARCIA-SANTIUSTE AZCUNAGA ALBERTO. Datos registrales. T 38388 , F 106, S 8, H M 33105,I/A 299 ( 6.03.19).

Revocaciones. Apoderado: SAN ROMAN ROMERO LARA. Apo.Sol.: SAN ROMAN ROMERO LARA. Datos registrales. T 38388 , F106, S 8, H M 33105, I/A 300 ( 6.03.19).

01 de Marzo de 2019
Revocaciones. Apoderado: PENAS GARCIA MARIA-JESUS. Datos registrales. T 38388 , F 106, S 8, H M 33105, I/A 298(22.02.19).

07 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: BEIZAMA AZCUE TERESA. Datos registrales. T 38388 , F 105, S 8, H M 33105, I/A 297 (31.01.19).

04 de Febrero de 2019
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 38388 , F 105, S 8, H M 33105, I/A 296 (28.01.19).

24 de Enero de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: PASTOR RIVERA CRISTINA. Datos registrales. T 38388 , F 105, S 8, H M 33105, I/A 295 (17.01.19).

21 de Enero de 2019
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: QUAVITAE BIZI KALITATE SL. SACOVA CENTROS RESIDENCIALES SL. Datosregistrales. T 38388 , F 102, S 8, H M 33105, I/A 294 (14.01.19).

08 de Enero de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO MOLINA MARIA JOSE. Datos registrales. T 38388 , F 102, S 8, H M 33105, I/A 293(28.12.18).

18 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: REVILLA LIZARZA I脩AKI;CERDA VILCHEZ ANA MARIA;GOMARIZ VERDU AMELIA;MANSILLA CANOISABEL MARIA;CANTERO LOPEZ MARIA TERESA;FAZ PEREZ LAURA;MOZAS POVEDA JOAQUINA;MINGORANCE PEREZMARIA ESTHER;LOPEZ GARRIDO MARIA EUGENIA;PERTUSA OLIVARES LAURA;TENA MARTINEZ VICENT XAVIER;TORRESPEREZ LEIRE;SAN ROMAN ROMERO LARA. Datos registrales. T 38388 , F 101, S 8, H M 33105, I/A 292 (11.12.18).

17 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ MC COLLUM RAQUEL. Datos registrales. T 38388 , F 101, S 8, H M 33105, I/A 291(10.12.18).

28 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ VALLES MARTA. Datos registrales. T 31903 , F 225, S 8, H M 33105, I/A 290 (21.11.18).

15 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apoderado: GARCIA ALVAREZ SERGIO. Datos registrales. T 31903 , F 225, S 8, H M 33105, I/A 289 ( 4.10.18).

05 de Octubre de 2018
Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ FERNANDEZ ELENA. Datos registrales. T 31903 , F 225, S 8, H M 33105, I/A 288(28.09.18).

25 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: GALLARDO HERNANDEZ SILVIA. Datos registrales. T 31903 , F 224, S 8, H M 33105, I/A 287(14.09.18).

13 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ALONSO LUIS MANUEL. Datos registrales. T 31903 , F 224, S 8, H M 33105, I/A 286 (5.09.18).

31 de Julio de 2018
Nombramientos. Apoderado: CASTILLO ROMERO HILARIO. Datos registrales. T 31903 , F 223, S 8, H M 33105, I/A 285(24.07.18).

23 de Julio de 2018
Nombramientos. Apoderado: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 31903 , F 223, S 8, H M 33105, I/A 284 (13.07.18).

02 de Julio de 2018
Nombramientos. Apoderado: GALIANO FERNANDEZ ROCIO. Datos registrales. T 31903 , F 222, S 8, H M 33105, I/A 283(22.06.18).

30 de Abril de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 31903 , F 220, S 8, H M 33105, I/A 279 (23.04.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: VAN-DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 31903 , F 221, S 8, H M 33105, I/A 280 (23.04.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 31903 , F 222, S 8, H M 33105, I/A 281 (23.04.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU. Datos registrales. T 31903 , F 222, S 8, H M 33105, I/A 282(23.04.18).

19 de Abril de 2018
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n de los art铆culos 8, 8bis, y 10 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 31903 , F220, S 8, H M 33105, I/A 278 (12.04.18).

06 de Abril de 2018
Revocaciones. Apoderado: CALVARRO ORDAS SILVIA. Datos registrales. T 31903 , F 220, S 8, H M 33105, I/A 277 (28.03.18).

02 de Abril de 2018
Nombramientos. Apoderado: PLAZA LUNA SUSANA. Datos registrales. T 31903 , F 219, S 8, H M 33105, I/A 276 (22.03.18).

06 de Marzo de 2018
Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 31903 , F 219, S 8, H M 33105, I/A275 (26.02.18).

14 de Febrero de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: PASCUAL ORTEGA ANA. Apoderado: FERNANDEZ GOMEZ BEGO脩A;CANDEAL CRUZ MARIA. Datosregistrales. T 31903 , F 216, S 8, H M 33105, I/A 268 ( 6.02.18).

Nombramientos. Apoderado: BA脩OS HERRAIZ ANA. Datos registrales. T 31903 , F 216, S 8, H M 33105, I/A 269 ( 6.02.18).

Nombramientos. Apoderado: CHAVEZ GIL ELENA. Datos registrales. T 31903 , F 217, S 8, H M 33105, I/A 270 ( 6.02.18).

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ALONSO MONICA. Datos registrales. T 31903 , F 217, S 8, H M 33105, I/A 271 ( 6.02.18).

Nombramientos. Apoderado: GORDILLO RODRIGUEZ MARIA. Datos registrales. T 31903 , F 217, S 8, H M 33105, I/A 272 (6.02.18).

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ CARRILLO MONICA. Datos registrales. T 31903 , F 218, S 8, H M 33105, I/A 273 (6.02.18).

Nombramientos. Apoderado: VARA CENTENO BEGO脩A. Datos registrales. T 31903 , F 218, S 8, H M 33105, I/A 274 ( 6.02.18).

07 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ ISABEL. Datos registrales. T 31903 , F 215, S 8, H M 33105, I/A 266(30.01.18).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 31903 , F 216, S 8, H M 33105, I/A 267 (30.01.18).

06 de Febrero de 2018
Revocaciones. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 31903 , F 215, S 8, H M 33105, I/A 265(30.01.18).

01 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: BUSTOS MU脩OZ AMELIA. Datos registrales. T 31903 , F 214, S 8, H M 33105, I/A 263 (23.01.18).

Nombramientos. Apoderado: PRIEGO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 31903 , F 215, S 8, H M 33105, I/A 264 (24.01.18).

26 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ MARTINEZ ISABEL. Datos registrales. T 31903 , F 214, S 8, H M 33105, I/A 262(15.12.17).

18 de Diciembre de 2017
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. AVDA GENERAL PERON 36 4潞A (MADRID). Datos registrales. T 31903 , F 214, S 8, H M 33105, I/A 261 ( 7.12.17).

13 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ ORDOVAS JAVIER. Datos registrales. T 31903 , F 214, S 8, H M 33105, I/A 260 ( 4.12.17).

12 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: ISASI PEREZ I脩AKI. Datos registrales. T 31903 , F 214, S 8, H M 33105, I/A 259 (30.11.17).

05 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: ROMERO ALCALDE MIGUEL. Datos registrales. T 31903 , F 213, S 8, H M 33105, I/A 258 (28.11.17).

21 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: VELASCO JIMENEZ MARIA-ANTONIA;CALVO DIEGUEZ MONICA;ALONSO ZURUTUZA OLGA;SOLERVICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Apoderado: SOLERVICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI. Datosregistrales. T 31903 , F 213, S 8, H M 33105, I/A 257 (10.11.17).

03 de Octubre de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: ABASCAL CASTA脩ON ALVARO-MARIA. Datos registrales. T 31903 , F 206, S 8, H M 33105, I/A 250(26.09.17).

Nombramientos. Apoderado: PENAS GARCIA MARIA-JESUS. Datos registrales. T 31903 , F 210, S 8, H M 33105, I/A 251(26.09.17).

Nombramientos. Apoderado: TABOADA VAZQUEZ ANTONIO. Datos registrales. T 31903 , F 210, S 8, H M 33105, I/A 252(26.09.17).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO. Datos registrales. T 31903 , F 211, S 8, H M 33105, I/A 253(26.09.17).

Nombramientos. Apoderado: VILLAVERDE MARTINEZ ANA. Datos registrales. T 31903 , F 211, S 8, H M 33105, I/A 254(26.09.17).

Nombramientos. Apoderado: CALVARRO ORDAS SILVIA. Datos registrales. T 31903 , F 212, S 8, H M 33105, I/A 255 (26.09.17).

Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONIO. Datos registrales. T 31903 , F 212, S 8, H M 33105, I/A 256 (26.09.17).

29 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 31903 , F 206, S 8, H M 33105, I/A 249(21.09.17).

26 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 31903 , F 202, S 8, H M 33105, I/A 247 (19.09.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: DURAN MARI脩O MARIA;DEL CAMPO REDONDO LUCIA;MELON CASTRO MARIA JOSE. Datosregistrales. T 31903 , F 205, S 8, H M 33105, I/A 248 (19.09.17).

25 de Abril de 2017
Nombramientos. Apoderado: CASTELLANOS POZA GALA. Datos registrales. T 31903 , F 201, S 8, H M 33105, I/A 246 (17.04.17).

11 de Abril de 2017
Otros conceptos: EMISION DEL TITULO MULTIPLE N潞 1 COMPRENSIVO DE 237.602 ACCIONES NOMINATIVAS NUMEROS 1 A237.602 AMBOS INCLUSIVE DE 136,54 EUROS DE VALOR NOMINAL CADA UNO TOTALMENTE SUSCRITO Y DESEMBOLSADO.Datos registrales. T 28518 , F 123, S 8, H M 33105, I/A142/M ( 4.04.17).

03 de Abril de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: CARRERAS JIMENEZ JULIAN. Nombramientos. Representan: FERNANDEZ MIGUELEZJOSEFA ISABEL. Datos registrales. T 31903 , F 201, S 8, H M 33105, I/A 245 (24.03.17).

11 de Enero de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ PEREZ MARA. Datos registrales. T 31903 , F 201, S 8, H M 33105, I/A 244 ( 2.01.17).

07 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: CANDEAL CRUZ MARIA. Datos registrales. T 31903 , F 201, S 8, H M 33105, I/A 243 (28.11.16).

11 de Noviembre de 2016
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 31903 , F 200, S 8, H M 33105, I/A 242 ( 2.11.16).

13 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 31903 , F 199, S 8, H M 33105, I/A 240 ( 5.09.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 31903 , F 200, S 8, H M 33105, I/A 241 ( 5.09.16).

04 de Agosto de 2016
Nombramientos. Apoderado: GALLARDO CASAS MARIA VICTORIA. Datos registrales. T 31903 , F 199, S 8, H M 33105, I/A 239(27.07.16).

14 de Julio de 2016
Reelecciones. Adm. Unico: QUAVITAE RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL SL. Datos registrales. T 31903 , F 198, S 8, H M 33105, I/A235 ( 6.07.16).

Revocaciones. Apo.Sol.: SEBASTIA VIGATA SUSANA. Datos registrales. T 31903 , F 198, S 8, H M 33105, I/A 236 ( 6.07.16).

Revocaciones. Apoderado: RAMIREZ BARRERO CARLOS. Datos registrales. T 31903 , F 198, S 8, H M 33105, I/A 237 ( 6.07.16).

Revocaciones. Apoderado: SICILIA GARCIA IRENE. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ CASTRO ANGELA. Datosregistrales. T 31903 , F 198, S 8, H M 33105, I/A 238 ( 6.07.16).

06 de Mayo de 2016
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 31903 , F 197, S 8, H M 33105, I/A 233 (27.04.16).

Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ CALAVIA JAVIER. Datos registrales. T 31903 , F 197, S 8, H M 33105, I/A 234 (27.04.16).

14 de Enero de 2016
Revocaciones. Apoderado: EXPOSITO CUESTA SARA. Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ BARRERO CARLOS. Datosregistrales. T 31903 , F 196, S 8, H M 33105, I/A 231 ( 5.01.16).

Nombramientos. Apoderado: DE LA VEGA FERNANDEZ MIRIAM. Datos registrales. T 31903 , F 197, S 8, H M 33105, I/A 232 (5.01.16).

27 de Octubre de 2015
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 31903 , F 195, S 8, H M 33105, I/A 230 (16.10.15).

08 de Septiembre de 2015
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 31903 , F 195, S 8, H M 33105, I/A 229 (31.08.15).

23 de Julio de 2015
Nombramientos. Apoderado: PRIETO SALVATIERRA ELENA MARIA. Datos registrales. T 31903 , F 194, S 8, H M 33105, I/A 228(15.07.15).

03 de Junio de 2015
Nombramientos. Apoderado: PEREZ ZAMARRA RUTH. Datos registrales. T 31903 , F 194, S 8, H M 33105, I/A 227 (27.05.15).

19 de Mayo de 2015
Nombramientos. Apoderado: BARREIRA VIVIAN VICTORIA. Datos registrales. T 31903 , F 194, S 8, H M 33105, I/A 226 (8.05.15).

20 de Abril de 2015
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 31903 , F 193, S 8, H M 33105, I/A 225 ( 9.04.15).

09 de Abril de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: HINOJOSA GARCIA ALMUDENA. Datos registrales. T 31903 , F 192, S 8, H M 33105, I/A 222(30.03.15).

Nombramientos. Apoderado: NOSTI GONZALEZ BARBARA. Datos registrales. T 31903 , F 193, S 8, H M 33105, I/A 224(30.03.15).

Nombramientos. Apoderado: SICILIA GARCIA IRENE. Datos registrales. T 31903 , F 192, S 8, H M 33105, I/A 223 (30.03.15).

17 de Marzo de 2015
Nombramientos. Apoderado: HINOJOSA GARCIA ALMUDENA. Datos registrales. T 31903 , F 191, S 8, H M 33105, I/A 220 (9.03.15).

Nombramientos. Apoderado: ALONSO MU脩OZ LAURA. Datos registrales. T 31903 , F 191, S 8, H M 33105, I/A 221 ( 9.03.15).

10 de Marzo de 2015
Ceses/Dimisiones. Representan: GUARNER MU脩OZ JORGE. Nombramientos. Representan: CARRERAS JIMENEZ JULIAN.Datos registrales. T 31903 , F 189, S 8, H M 33105, I/A 218 ( 2.03.15).

Revocaciones. Apoderado: RAVENTOS NEGRA HIGINIO;GUARNER MU脩OZ JORGE. Nombramientos. Apoderado: SOLERVICENS ANTONI. Datos registrales. T 31903 , F 189, S 8, H M 33105, I/A 219 ( 2.03.15).

02 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 31903 , F 188, S 8, H M 33105, I/A 217 (25.11.14).

20 de Noviembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: ROJAS RODRIGUEZ VICTORIA. Datos registrales. T 31903 , F 188, S 8, H M 33105, I/A 216(12.11.14).

14 de Octubre de 2014
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 31903 , F 188, S 8, H M 33105, I/A 215 ( 3.10.14).

09 de Octubre de 2014
Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Datos registrales. T 31903 , F 187, S 8, H M 33105, I/A 214 ( 1.10.14).

01 de Octubre de 2014
Nombramientos. Apoderado: HIPOLITO GOMEZ MARIA ROSA. Datos registrales. T 31903 , F 187, S 8, H M 33105, I/A 213(24.09.14).

03 de Septiembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: CABELLO VILLEGAS SONIA. Datos registrales. T 31903 , F 186, S 8, H M 33105, I/A 212 (22.08.14).

07 de Agosto de 2014
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ MARTIN JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 31903 , F 186, S 8, H M 33105, I/A 211(25.07.14).

04 de Junio de 2014
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 206 EL NOMBRAMIENTO COMO APODERADO DE DONGREGORIO MOLINA PANIAGUA. Datos registrales. T 29470 , F 109, S 8, H M 33105, I/A 206 (24.02.14).

Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 205 EL NOMBRAMIENTO COMO APODERADO DE DO脩ABASILISA BARRIGA LOPEZ. Datos registrales. T 29470 , F 108, S 8, H M 33105, I/A 205 (24.02.14).

Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 204 EL NOMBRAMIENTO COMO APODERADO DE DO脩A ANAMERINO SANCHEZ. Datos registrales. T 29470 , F 108, S 8, H M 33105, I/A 204 (24.02.14).

Otros conceptos: Por la presente se rectifica el error material padecido en las inscripciones 204, 205 y 206 en cuanto a la concesi贸ndel poder para representar a esta sociedad que se practico indebidamente, dado que tal poder estaba conferido para representar aotra. Datos registrales. T 31903 , F 186, S 8, H M 33105, I/A 210 (23.05.14).

16 de Mayo de 2014
Nombramientos. Apoderado: EXPOSITO CUESTA SARA. Datos registrales. T 31903 , F 185, S 8, H M 33105, I/A 209 ( 7.05.14).

11 de Abril de 2014
Nombramientos. Apoderado: ROMERO ALCALDE MIGUEL. Datos registrales. T 29470 , F 109, S 8, H M 33105, I/A 207 ( 4.04.14).

Nombramientos. Apoderado: URROZ BORDONABA MARIA. Datos registrales. T 31903 , F 185, S 8, H M 33105, I/A 208 (4.04.14).

05 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: MERINO SANCHEZ ANA. Nombramientos. Apoderado: MERINO SANCHEZ ANA. Datos registrales. T29470 , F 108, S 8, H M 33105, I/A 204 (24.02.14).

Revocaciones. Apoderado: BARRIGA LOPEZ BASILISA. Nombramientos. Apoderado: BARRIGA LOPEZ BASILISA. Datosregistrales. T 29470 , F 108, S 8, H M 33105, I/A 205 (24.02.14).

Revocaciones. Apoderado: MOLINA PANIAGUA GREGORIO. Nombramientos. Apoderado: MOLINA PANIAGUA GREGORIO.Datos registrales. T 29470 , F 109, S 8, H M 33105, I/A 206 (24.02.14).

11 de Febrero de 2014
Nombramientos. Apoderado: SOCIAS FUSTER ANDREU. Datos registrales. T 29470 , F 108, S 8, H M 33105, I/A 203 ( 4.02.14).

06 de Febrero de 2014
Nombramientos. Apoderado: DOMINGO TORRA LAURA. Datos registrales. T 29470 , F 107, S 8, H M 33105, I/A 202 (29.01.14).

30 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: DURAN BENGOECHEA INGRID. Datos registrales. T 29470 , F 107, S 8, H M 33105, I/A 201(19.12.13).

23 de Julio de 2013
Nombramientos. Apoderado: ISASI AYUSO ANA ISABEL. Datos registrales. T 29470 , F 106, S 8, H M 33105, I/A 200 (12.07.13).

21 de Mayo de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 29470 , F 106, S 8, H M 33105, I/A 199 (10.05.13).

03 de Mayo de 2013
Nombramientos. Apoderado: PADILLA DOMINGUEZ CIRENE. Datos registrales. T 29470 , F 104, S 8, H M 33105, I/A 194(24.04.13).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA GONZALEZ MONICA. Datos registrales. T 29470 , F 104, S 8, H M 33105, I/A 195(24.04.13).

Nombramientos. Apoderado: CANTERO RUEDA SUSANA. Datos registrales. T 29470 , F 105, S 8, H M 33105, I/A 196 (24.04.13).

Revocaciones. Apo.Sol.: HINOJOSA GARCIA ALMUDENA. Datos registrales. T 29470 , F 105, S 8, H M 33105, I/A 197 (24.04.13).

Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ BALSALOBRE SILVIA ESTEFANIA. Datos registrales. T 29470 , F 106, S 8, H M 33105, I/A198 (24.04.13).

09 de Abril de 2013
Nombramientos. Apoderado: BARROS GUTIERREZ BELEN;MOYA MOLINA MARIA CARMEN;GOMEZ MARTIN JUANANTONIO;BAEZA ALEMAN MARIA CARMEN;CASTILLO ROMERO HILARIO;RIVAS CABEZA CARMEN;DIAZ CASTRONURIA;VIVES JUSGEN SANDRA;MOYA ALCALDE IRENE;CORCUERA CHAVARRI MONICA. Datos registrales. T 29470 , F 103, S8, H M 33105, I/A 192 ( 1.04.13).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA BARREIRO GLORIA MARIA. Datos registrales. T 29470 , F 104, S 8, H M 33105, I/A 193 (1.04.13).

08 de Marzo de 2013
Modificaciones estatutarias. 8bis. Usufructo, prenda y embargo de acciones.. Datos registrales. T 29470 , F 103, S 8, H M 33105,I/A 191 (27.02.13).

05 de Diciembre de 2012
Revocaciones. Apo.Sol.: MONTESINOS LOPEZ TANIA. Datos registrales. T 29470 , F 103, S 8, H M 33105, I/A 190 (23.11.12).

02 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: ALMALE MARIFONS MARTA. Datos registrales. T 29470 , F 102, S 8, H M 33105, I/A 187 (22.10.12).

Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ GIMENEZ LORENZO. Datos registrales. T 29470 , F 102, S 8, H M 33105, I/A 188 (22.10.12).

Nombramientos. Apo.Sol.: QUESADA ESTEBAN NATALIA. Datos registrales. T 29470 , F 102, S 8, H M 33105, I/A 189 (22.10.12).

26 de Junio de 2012
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ BALSALOBRE SILVIA ESTEFANIA. Datos registrales. T 29470 , F 101, S 8, H M 33105,I/A 186 (14.06.12).

23 de Mayo de 2012
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ MARTINEZ ISABEL. Datos registrales. T 29470 , F 100, S 8, H M 33105, I/A 182 (7.05.12).

Nombramientos. Apoderado: PITEL MENDEZ MARIA-EUGENIA. Datos registrales. T 29470 , F 100, S 8, H M 33105, I/A 183 (7.05.12).

Nombramientos. Apoderado: VELASCO JIMENEZ MARIA-ANTONIA. Datos registrales. T 29470 , F 101, S 8, H M 33105, I/A 184 (7.05.12).

Revocaciones. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA;ESPIN FORJAN ANA. Nombramientos. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA.Datos registrales. T 29470 , F 101, S 8, H M 33105, I/A 185 ( 7.05.12).

16 de Mayo de 2012
Revocaciones. Apo.Sol.: PIQUERAS RAMIREZ SORAYA. Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ MARTIN ALVARO. Datosregistrales. T 29470 , F 99, S 8, H M 33105, I/A 181 (30.04.12).

09 de Abril de 2012
Revocaciones. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN;LOPESINO SOUSA AGUSTIN;LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Apo.Manc.:LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Apo.Man.Soli: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO.Apoderado: BELTRAN MENDEZ JESUS. Datos registrales. T 29470 , F 99, S 8, H M 33105, I/A 179 (26.03.12).

Revocaciones. Apo.Sol.: FORTEA AGUIRRE BEATRIZ. Datos registrales. T 29470 , F 99, S 8, H M 33105, I/A 180 (26.03.12).

04 de Abril de 2012
Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Datos registrales. T 29470 , F 98, S 8, H M 33105, I/A 176 (26.03.12).

Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 29470 , F 98, S 8, H M 33105, I/A 177 (26.03.12).

Revocaciones. Apo.Sol.: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO;GAYOSO PARDO JOSE LUIS. Datos registrales. T 29470 , F99, S 8, H M 33105, I/A 178 (26.03.12).

20 de Febrero de 2012
Ceses/Dimisiones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: KPMGAUDITORES SL. Datos registrales. T 29470 , F 96, S 8, H M 33105, I/A 170 ( 7.02.12).

Revocaciones. Apoderado: ROCHA JAEN MARTA. Datos registrales. T 29470 , F 96, S 8, H M 33105, I/A 171 ( 9.02.12).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GOMEZ BEGO脩A. Datos registrales. T 29470 , F 96, S 8, H M 33105, I/A 172 (9.02.12).

Nombramientos. Apoderado: SAEZ IZQUIERDO ISABEL. Datos registrales. T 29470 , F 96, S 8, H M 33105, I/A 173 ( 9.02.12).

Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ FERNANDEZ ELENA. Datos registrales. T 29470 , F 97, S 8, H M 33105, I/A 174 (9.02.12).

Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ VIDAL CESAREO. Datos registrales. T 29470 , F 97, S 8, H M 33105, I/A 175 ( 9.02.12).

08 de Febrero de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: DOMINGUEZ LLORENTE MARIA LUZ;MURO GONZALEZ MARIA LUISA;ROJAS RODRIGUEZVICTORIA;CATROLA VERGARA RAQUEL;GARCIA MIGUEL NURIA;JIMENEZ GUTIERREZ MARIA JOSE;PIQUERAS RAMIREZ

Nombramientos. Apo.Sol.: RECUENCO COTILLAS PILAR;ASENSIO OLASO IGNACIO;SEBASTIA VIGATA SUSANA;SANJUANCORTES JOSE MARIA;HONORATO GUZMAN JORGE;GALAN COLLANTES AUXILIADORA;REYES PONCE MONICA. Datosregistrales. T 29470 , F 95, S 8, H M 33105, I/A 168 (27.01.12).

Nombramientos. Apo.Sol.: MU脩OZ RUIZ ROSA MARIA. Datos registrales. T 29470 , F 95, S 8, H M 33105, I/A 169 (27.01.12).

02 de Febrero de 2012
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 52 5 (MADRID). Datos registrales. T 29470 , F 94, S 8, H M 33105, I/A166 (20.01.12).

24 de Enero de 2012
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ LAVADO ESTRELLA ANGELES. Datos registrales. T 29470 , F 94, S 8, H M 33105, I/A165 (12.01.12).

15 de Diciembre de 2011
Revocaciones. Apoderado: TRIGO DE AIZPURU MIGUEL ANGEL;CORDOBA DIAZ ANGEL;GAYOSO PARDO JOSE LUIS;HIERRODEL CORRAL IGNACIO;SANCHEZ LUQUERO PILAR;BAEZ MARTIN MANUEL;LOPEZ VIDAL CESAREO;ROSALES GARCIAMARIA JOSE;RAMIREZ CUSTODIO PILAR;ANIDO RUBIO JAVIER;RODRIGUEZ SALAMANCA EVA;PORRO GUTIERREZINMACULADA;CATROLA VERGARA RAQUEL;GIL ROMERO LUIS ANTONIO;GARCIA RUIZ FERNANDO;BAURA ORTEGA JOSECARLOS;CAMPOS DOMPEDRO JOSE RAMON;VALLE PEIRO JOSE ALBERTO;GARCIA RUIZ FERNANDO RAMON;DE PEDROALFARO ALFONSO;GIL ROMERO LUIS ANTONIO;DOMINGUEZ LLORENTE MARIA LUZ;CAMPOS DOMPEDRO JOSERAMON;DIEZ MEDINA MARTA;MENESES PONCIO JOSE JUAN;GARCIA RUIZ FERNANDO;GIL ROMERO LUISANTONIO;MENESES PONCIO JOSE JUAN;GARCIA RUIZ FERNANDO;SANCHEZ LUQUERO PILAR;DE PEDRO ALFAROALFONSO;GIL ROMERO LUIS ANTONIO;CAMPOS DOMPEDRO JOSE RAMON;MOLERO ROMERO ROBERTO;RECUENCOCOTILLAS PILAR;MENESES PONCIO JOSE JUAN;SERRANO MARTIN FERNANDO;DOMINGUEZ LLORENTE MARIA LUZ;REYESPONCE MONICA;VILAR VAZQUEZ ANAHI;SAEZ IZQUIERDO ISABEL;SANTAMARIA MENENDEZ ELENA;MORALES ALCONCHELCONCEPCION;ARANDA ARANDA JESUS;PERI脩AN GOMEZ FERNANDO;BRUNICARDI SANZ EMMA;GALAN COLLANTESAUXILIADORA;GIMENO FERNANDEZ ANA;GAYOSO PARDO JOSE LUIS;CANTERO RUEDA SUSANA;DOMINGUEZ LLORENTEMARIA LUZ;MENENDEZ GONZALEZ MARIA ISABEL;CATROLA VERGARA RAQUEL;RAMIREZ CUSTODIO PILAR;GARCIAGONZALEZ MARIA JOSE;SANCHEZ REY JUAN CARLOS. Apo.Manc.: CAMPOS DOMPEDRO JOSE RAMON;GARCIA RUIZFERNANDO RAMON;MOLERO ROMERO ROBERTO;SANCHEZ LUQUERO PILAR;FERRAJOLI SABATER AMADEO. Apoderado:

Nombramientos. Apoderado: ROCHA JAEN MARTA. Datos registrales. T 28518 , F 139, S 8, H M 33105, I/A 162 ( 2.12.11).

Nombramientos. Apoderado: BARRIGA LOPEZ BASILISA. Datos registrales. T 28518 , F 140, S 8, H M 33105, I/A 163 ( 2.12.11).

Nombramientos. Apoderado: ISASI PEREZ I脩AKI. Datos registrales. T 28518 , F 140, S 8, H M 33105, I/A 164 ( 2.12.11).

23 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO;GAYOSO PARDO JOSE LUIS. Datos registrales. T 28518 , F137, S 8, H M 33105, I/A 160 (11.11.11).

22 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Datos registrales. T 28518 , F 136, S 8, H M 33105, I/A 159 (10.11.11).

05 de Octubre de 2011
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ CALAVIA JAVIER. Datos registrales. T 28518 , F 135, S 8, H M 33105, I/A 157 (23.09.11).

Nombramientos. Apoderado: RAVENTOS NEGRA HIGINIO;GUARNER MU脩OZ JORGE;SOLER VICENS ANTONI;LOPESINOSOUSA AGUSTIN;JIMENEZ CALAVIA JAVIER;CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 28518 , F 135, S 8, H M 33105, I/A158 (23.09.11).

04 de Octubre de 2011
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ LOPEZ FELIX. Datos registrales. T 28518 , F 133, S 8, H M 33105, I/A 155 (22.09.11).

Nombramientos. Apoderado: RUBIO VALOR PABLO. Datos registrales. T 28518 , F 134, S 8, H M 33105, I/A 156 (22.09.11).

28 de Septiembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 28518 , F 130, S 8, HM 33105, I/A 149 (15.09.11).

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ORDOVAS JAVIER. Datos registrales. T 28518 , F 131, S 8, H M 33105, I/A 150(15.09.11).

Nombramientos. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 28518 , F 132, S 8, H M 33105, I/A 151(15.09.11).

Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 28518 , F 132, S 8, H M 33105, I/A 152(15.09.11).

Nombramientos. Apoderado: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER. Datos registrales. T 28518 , F 133, S 8, H M 33105, I/A 153(15.09.11).

Otros conceptos: CON FECHA 20 DE JULIO DE 2011 SE PRODUCE EL CAMBIO DE SOCIOUNICO DE LA SOCIEDAD DE ESTAHOJA, DEJANDO DE SER LA SOCIEDAD "MAQUAVIT INMUEBLES SL" EL SOCIO UNICO Y SIENDO LA SOCIEDAD "QUAVITAERESIDENCIAL Y ASISTENCIAL SL" EL NUEVO SOCIO UNICO. Datos registrales. T 28518 , F 133, S 8, H M 33105, I/A 154(15.09.11).

26 de Septiembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: BRAVO ARAGON PEDRO. Datos registrales. T 28518 , F 127, S 8, H M 33105, I/A 144 (14.09.11).

Revocaciones. Apoderado: CANES MARTI CARLES;RUBIO YELAMOS ISAAC. Nombramientos. Apoderado: MOLINA PANIAGUAGREGORIO;DOMINGO TORRA LAURA;SAN ROMAN ROMERO LARA. Datos registrales. T 28518 , F 128, S 8, H M 33105, I/A 145(15.09.11).

Nombramientos. Apoderado: ALONSO ZURUTUZA OLGA. Datos registrales. T 28518 , F 128, S 8, H M 33105, I/A 146 (15.09.11).

Nombramientos. Apoderado: PUMARES GOMEZ MARIA BELEN. Datos registrales. T 28518 , F 129, S 8, H M 33105, I/A 147(15.09.11).

Nombramientos. Apoderado: AMER FORTEZA LOURDES. Datos registrales. T 28518 , F 130, S 8, H M 33105, I/A 148 (15.09.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n