Actos BORME de Questio Despai Sl
04 de Marzo de 2021Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 6 APARTADO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES RELATIVO A LARETRIBUCION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 45994 , F 25, S 8, H B 376547, I/A 18 (24.02.21).
12 de Febrero de 2021Nombramientos. APODERAD.SOL: GIMENEZ LAX ISABEL. Datos registrales. T 45994 , F 23, S 8, H B 376547, I/A 17 ( 4.02.21).
20 de Febrero de 2020Nombramientos. APODERAD.SOL: MUXACH GONZALEZ CRISTINA. Datos registrales. T 45994 , F 23, S 8, H B 376547, I/A 16(12.02.20).
27 de Enero de 2020Cambio de domicilio social. AV DE BARCELONA 211 NAVE 6 PG.INDUSTRIAL EL PLA (MOLINS DE REI). Datos registrales. T45994 , F 23, S 8, H B 376547, I/A 15 (20.01.20).
23 de Mayo de 2019Revocaciones. APODERAD.SOL: PAGAN JUAREZ RAQUEL. Datos registrales. T 45994 , F 22, S 8, H B 376547, I/A 13(15.05.19).
Nombramientos. APODERAD.SOL: PAGAN JUAREZ RAQUEL. Datos registrales. T 45994 , F 22, S 8, H B 376547, I/A 14(15.05.19).
26 de Febrero de 2019Revocaciones. ADM.UNICO: ISERN MORA JORGE. Nombramientos. ADM.UNICO: RUIZ ESTOPI脩AN DOMINGO. Datosregistrales. T 45994 , F 22, S 8, H B 376547, I/A 12 (19.02.19).
09 de Febrero de 2018Revocaciones. APODERADO: JUAREZ CA脩AS JOSEFA. Datos registrales. T 45994 , F 22, S 8, H B 376547, I/A 11 ( 1.02.18).
31 de Enero de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.020,00 Euros. Resultante Suscrito: 980,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:2.020,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000,00 Euros. Datos registrales. T 45994 , F 21, S 8, H B 376547, I/A 10 (23.01.18).
22 de Junio de 2017Revocaciones. ADM.UNICO: PAGAN JUAREZ RAQUEL. Nombramientos. ADM.UNICO: ISERN MORA JORGE. Datosregistrales. T 40829 , F 224, S 8, H B 376547, I/A 8 (14.06.17).
Nombramientos. APODERAD.SOL: PAGAN JUAREZ RAQUEL. Datos registrales. T 40829 , F 224, S 8, H B 376547, I/A 9(14.06.17).
30 de Noviembre de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.503,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.503,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:1.497,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 4.-RENUMERACION DE LASPARTICIPACIONES SOCIALES. Datos registrales. T 40829 , F 223, S 8, H B 376547, I/A 7 (22.11.16).
17 de Noviembre de 2016Revocaciones. ADM.UNICO: TORRES VARO MARCOS ANTONIO. Nombramientos. ADM.UNICO: PAGAN JUAREZ RAQUEL.Datos registrales. T 40829 , F 223, S 8, H B 376547, I/A 6 ( 9.11.16).
23 de Septiembre de 2013Cambio de domicilio social. CL FERRAN I CLUA NUM.23 LOCAL BAJOS (VILADECANS). Datos registrales. T 40829 , F 223, S 8,H B 376547, I/A 5 (16.09.13).
27 de Junio de 2012Nombramientos. APODERADO: JUAREZ CA脩AS JOSEFA. Datos registrales. T 40829 , F 221, S 8, H B 376547, I/A 4 (15.06.12).
15 de Junio de 2012Revocaciones. ADM.UNICO: JUAREZ CA脩AS JOSEFA. Nombramientos. ADM.UNICO: TORRES VARO MARCOS ANTONIO.Cambio de domicilio social. CL LLUIS COMPANYS,26-30 (VILADECANS). Datos registrales. T 40829 , F 220, S 8, H B 376547,I/A 3 ( 6.06.12).
04 de Noviembre de 2010Otros conceptos: PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD. Datos registrales. T 40829 , F 220, S 8, H B 376547, I/A 2 (21.10.10).