Buscador CIF Logo

Actos BORME Quimica Del Cinca Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Quimica Del Cinca Sl

Actos BORME Quimica Del Cinca Sl - B08628455

Tenemos registrados 43 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Quimica Del Cinca Sl con CIF B08628455

馃敊 Perfil de Quimica Del Cinca Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Quimica Del Cinca Sl

11 de Diciembre de 2023
Reelecciones. Auditor: PROAUDIT SL. Datos registrales. T 652 , F 113, S 8, H HU 13288, I/A 19 (30.11.23).

21 de Noviembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: GRANE AULADELL VALENTI;GRANE AULADELL JAVIER;COLL KLEIN DANIEL;BALLY PETER.Nombramientos. Consejero: BISBE I LLUCH AURELI. Datos registrales. T 652 , F 113, S 8, H HU 13288, I/A 18 (14.11.23).

21 de Junio de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: TOGRAFA SL. Datos registrales. T 652 , F 113, S 8, H HU 13288, I/A 16 (14.06.23).

20 de Febrero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: GRACIA CORNIEL VICENTE. Nombramientos. Consejero: TOGRAFA SL. Datos registrales. T652 , F 112, S 8, H HU 13288, I/A 15 (13.02.23).

20 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: PROAUDIT SL. Datos registrales. T 652 , F 112, S 8, H HU 13288, I/A 14 ( 5.12.22).

31 de Agosto de 2021
Reelecciones. Auditor: PROAUDIT SL. Datos registrales. T 652 , F 112, S 8, H HU 13288, I/A 13 (24.08.21).

29 de Julio de 2021
Reelecciones. Consejero: COLL KLEIN FRANCISCO;BALLY PETER;GRANE AULADELL VALENTI;GRANE AULADELLJAVIER;SERUSAN GESTION SL;COLL USANDIZAGA ICIAR. Vicepresid.: COLL USANDIZAGA ICIAR. Vicesecret.: SERUSANGESTION SL. Otros conceptos: MODIFICACION de los Art铆culos 7潞 y 9潞 de los Estatutos Sociales, relativos a la Junta General y alConsejo de Administraci贸n, respectivamente. Datos registrales. T 652 , F 111, S 8, H HU 13288, I/A 12 (22.07.21).

24 de Febrero de 2021
Fe de erratas: En el envio 100 del a帽o 2019, se publico la Reelecci贸n de Auditor de Cuentas con la inscripci贸n 11陋 de fecha11/11/2019, cuando le correspond铆a la inscripci贸n 9陋. Datos registrales. T 652 , F 109, S 8, H HU 13288, I/A 9 (11.11.19).

17 de Febrero de 2021
Reelecciones. Auditor: PROAUDIT SL. Datos registrales. T 652 , F 111, S 8, H HU 13288, I/A 11 (11.02.21).

27 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Presidente: COLL KLEIN FRANCISCO. Vicepresid.: SERRA FARRE JESUS. Vicesecret.: COLL USANDIZAGAICIAR. Nombramientos. Presidente: SERRA FARRE JESUS. Vicepresid.: COLL USANDIZAGA ICIAR. Vicesecret.: SERUSANGESTION SL. Datos registrales. T 652 , F 109, S 8, H HU 13288, I/A 10 (20.01.20).

18 de Noviembre de 2019
Reelecciones. Auditor: PROAUDIT SL. Datos registrales. T 652 , F 109, S 8, H HU 13288, I/A 11 (11.11.19).

15 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: USANDIZAGA SAINZ JUAN. Nombramientos. Consejero: USANDIZAGA SAINZ ICIAR;COLLKLEIN DANIEL. Reelecciones. Consejero: FIOL OLIVAN FERNANDO;GRACIA CORNIEL VICENTE. Otros conceptos:Modificaci贸n de los art铆culos 8潞 y 9潞 de los estatutos sociales, relativos al Organo de Administraci贸n. Datos registrales. T 652 , F 109,S 8, H HU 13288, I/A 7 ( 7.10.19).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: COSTA FONTICH ROSA-MARIA. Nombramientos. Apo.Sol.: CASAS ANGUERA MARIA NIEVES.Apo.Manc.: CASAS ANGUERA MARIA NIEVES;CASAS ANGUERA MARIA NIEVES. Datos registrales. T 652 , F 109, S 8, H HU13288, I/A 8 ( 7.10.19).

14 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: COLL KLEIN FRANCISCO;FIOL OLIVAN FERNANDO. Apo.Man.Soli: CASTELLVI GIRBAUCRISTINA;DELGADO TORRES JOSE CARLOS. Apo.Sol.: VILAMASANA BALLBE MERCE. Apo.Manc.: COSTA FONTICH ROSA-MARIA. Nombramientos. Vicesecret.: COLL USANDIZAGA ICIAR. Datos registrales. T 652 , F 106, S 8, H HU 13288, I/A 5 (7.02.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: COLL KLEIN FRANCISCO;FIOL OLIVAN FERNANDO;USANDIZAGA SAINZ ICIAR;COLLUSANDIZAGA FRANCISCO;COLL USANDIZAGA ICIAR;CASTELLVI GIRBAU CRISTINA;DELGADO TORRES JOSECARLOS;COSTA FONTICH ROSA-MARIA;VILAMASANA BALLBE MERCE;INGLAN BIELSA FERNANDO. Datos registrales. T 652 ,F 107, S 8, H HU 13288, I/A 6 ( 7.02.19).

31 de Enero de 2019
Revocaciones. Apoderado: GRACIA CORNIEL VICENTE;GRACIA CORNIEL VICENTE;PUJOL BOROTAU JUAN. Apo.Manc.:TORRENS ROVIRA RAMON;COSTA FONTICH ROSA-MARIA. Apoderado: USANDIZAGA SAINZ EUGENIO. Nombramientos.Consejero: SERRA FARRE JESUS. Vicepresid.: SERRA FARRE JESUS. Otros conceptos: MODIFICADOS los Art铆culos 8潞 y 9潞 delos Estatutos Sociales relativos al 贸rgano de Administraci贸n, tras ampliar en 1 el n煤mero de miembros del Consejo de Administraci贸n.Datos registrales. T 652 , F 106, S 8, H HU 13288, I/A 4 (24.01.19).

20 de Noviembre de 2018
Reelecciones. Auditor: PROAUDIT SL. Datos registrales. T 652 , F 106, S 8, H HU 13288, I/A 3 (13.11.18).

16 de Febrero de 2018
Cambio de domicilio social. C/ CAMINO DEL ACIPRES S/N - POLIGON INDUSTRIAL PAU (MONZON). Datos registrales. T 652 ,F 31, S 8, H HU 13288, I/A 2 ( 8.02.18).

04 de Enero de 2017
Modificaci贸n de poderes. APODERAD.SOL: FIOL OLIVAN FERNANDO. Datos registrales. T 44561 , F 180, S 8, H B 95423, I/A 97(27.12.16).

07 de Abril de 2016
Revocaciones. AUDIT.CUENT.: RSM GASSO AUDITORES SLP. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PROAUDIT SLP. Datosregistrales. T 44561 , F 180, S 8, H B 95423, I/A 96 (30.03.16).

17 de Marzo de 2016
Nombramientos. CONSEJERO: COLL USANDIZAGA ICIAR. Datos registrales. T 44561 , F 180, S 8, H B 95423, I/A 95 ( 9.03.16).

13 de Enero de 2016
Otros conceptos: SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: IBERCLOR SL. Datos registrales. T 44561 , F 180, S 8, H B 95423,I/A 94 ( 4.01.16).

31 de Diciembre de 2015
Revocaciones. CONSEJERO: COLL USANDIZAGA FRANCISCO. Nombramientos. CONSEJERO: SERUSAN GESTION SL.REPR.143 RRM: COLL USANDIZAGA FRANCISCO. Datos registrales. T 44561 , F 179, S 8, H B 95423, I/A 93 (22.12.15).

11 de Diciembre de 2015
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: COAGULANTES DEL CINCA SL. Datos registrales. T 44421 , F 199, S 8, H B95423, I/A 92 ( 1.12.15).

22 de Octubre de 2015
Nombramientos. CONSEJERO: COLL KLEIN FRANCISCO;PETER BALLY;GRANE AULADELL VALENTI;GRANE AULADELLJAVIER. Datos registrales. T 44421 , F 198, S 8, H B 95423, I/A 91 (14.10.15).

24 de Diciembre de 2014
Nombramientos. CONSEJERO: GRACIA CORNIEL VICENTE;USANDIZAGA SAINZ JUAN;COLL USANDIZAGA FRANCISCO;FIOLOLIVAN FERNANDO. Datos registrales. T 44421 , F 198, S 8, H B 95423, I/A 90 (16.12.14).

19 de Noviembre de 2014
Modificaciones estatutarias. ART.8.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales.T 44421 , F 198, S 8, H B 95423, I/A 89 (11.11.14).

05 de Noviembre de 2014
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: RSM GASSO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 44421 , F 197, S 8, H B 95423, I/A 88(29.10.14).

14 de Agosto de 2014
Revocaciones. APODERADO: ABAD MARTINEZ ANTONIO JOSE;DELGADO TORRES JOSE CARLOS;COLL KELIN FRANCISCO.Datos registrales. T 42836 , F 80, S 8, H B 95423, I/A 83 ( 6.08.14).

Nombramientos. APODERAD.SOL: COLL KLEIN FRANCISCO;FIOL OLIVAN FERNANDO. Datos registrales. T 44421 , F 191, S 8,H B 95423, I/A 84 ( 6.08.14).

Nombramientos. APOD.SOL/MAN: CASTELLVI GIRBAU CRISTINA;DELGADO TORRES JOSE CARLOS. Datos registrales. T44421 , F 192, S 8, H B 95423, I/A 85 ( 6.08.14).

Nombramientos. APODERAD.SOL: VILAMASANA BALLBE MERCE. Datos registrales. T 44421 , F 194, S 8, H B 95423, I/A 86 (6.08.14).

Nombramientos. APOD.MANCOMU: COSTA FONTICH ROSA MARIA. Datos registrales. T 44421 , F 196, S 8, H B 95423, I/A 87 (6.08.14).

06 de Noviembre de 2013
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GASSO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 42836 , F 80, S 8, H B 95423, I/A 82 (29.10.13).

15 de Febrero de 2013
Modificaciones estatutarias. ART.7,APARTADO C):SISTEMA DE ADOPCION DE ACUERDOS EN EL SENO DE LA JUNTA.

21 de Septiembre de 2012
Nombramientos. APODERADO: COLL KELIN FRANCISCO. Datos registrales. T 42836 , F 79, S 8, H B 95423, I/A 80 ( 7.09.12).

06 de Septiembre de 2012
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GASSO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 42836 , F 77, S 8, H B 95423, I/A 77 (24.08.12).

Nombramientos. CONSEJERO: COLL KLEIN FRANCISCO;PETER BALLY;GRANE AULADELL VALENTI;GRANE AULADELLJAVIER. Datos registrales. T 42836 , F 78, S 8, H B 95423, I/A 78 (24.08.12).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.507.508,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.050.740,00 Euros. Datos registrales. T 42836 , F 78, S8, H B 95423, I/A 79 (24.08.12).

11 de Mayo de 2012
P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.qcinca.es. Datos registrales. T 25918 , F 172, S 8, H B95423, I/A 25 N (28.07.11).

02 de Febrero de 2012
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GASSO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 42836 , F 77, S 8, H B 95423, I/A 76 (24.01.12).

04 de Noviembre de 2011
Nombramientos. APODERADO: COLL KLEIN FRANCISCO. Datos registrales. T 42836 , F 76, S 8, H B 95423, I/A 75 (24.10.11).

26 de Octubre de 2011
Ampliaci贸n de capital. Capital: 7.190.832,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.543.232,00 Euros. Datos registrales. T 42836 , F 75, S8, H B 95423, I/A 74 (18.10.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n