Buscador CIF Logo

Actos BORME Quimica Industrial Mediterranea Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Quimica Industrial Mediterranea Sl

Actos BORME Quimica Industrial Mediterranea Sl - B29225687

Tenemos registrados 32 Actos BORME del Registro Mercantil de Malaga para Quimica Industrial Mediterranea Sl con CIF B29225687

🔙 Perfil de Quimica Industrial Mediterranea Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Malaga

Actos BORME de Quimica Industrial Mediterranea Sl

21 de Diciembre de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5738, L 4645, F 149, S 8, H MA 17498, I/A 55 (15.12.23).

18 de Octubre de 2023
Nombramientos. Apoderado: MARTIN SALSILLI NICOLAS IGNACIO. Datos registrales. T 5738, L 4645, F 149, S 8, H MA 17498,I/A 53 ( 3.10.23).

13 de Octubre de 2023
Revocaciones. Apoderado: MORALES MANSITO ALEJANDRO. Datos registrales. T 5738, L 4645, F 149, S 8, H MA 17498, I/A 54( 3.10.23).

11 de Octubre de 2022
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5738, L 4645, F 149, S 8, H MA 17498, I/A 52 (29.09.22).

01 de Junio de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: OTSUKA LOVE JANET. Nombramientos. Consejero: SONG IRENE EUNMI. Datos registrales. T5738, L 4645, F 148, S 8, H MA 17498, I/A 50 (23.05.22).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ECHANIZ SERRANO JOSE JOAQUIN. Datos registrales. T 5738, L 4645, F 149, S 8, H MA 17498,I/A 51 (23.05.22).

25 de Octubre de 2021
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5738, L 4645, F 148, S 8, H MA 17498, I/A 49 (15.10.21).

05 de Abril de 2021
Revocaciones. Apoderado: TORRES PICON M. ANGELES;VILLALTA CAMACHO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos.Apo.Man.Soli: ECHANIZ SERRANO JOSE JOAQUIN. Datos registrales. T 5738, L 4645, F 148, S 8, H MA 17498, I/A 48 (24.03.21).

21 de Diciembre de 2020
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5738, L 4645, F 148, S 8, H MA 17498, I/A 47 (11.12.20).

27 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MERX MARC. Datos registrales. T 5738, L 4645, F 147, S 8, H MA 17498, I/A 46 (13.11.20).

28 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: SAAVEDRA SALAS ALBERTO. Nombramientos. Consejero: PASEK JOANA BARBARA. Datosregistrales. T 5738, L 4645, F 147, S 8, H MA 17498, I/A 44 (15.10.20).

Revocaciones. Apoderado: SAAVEDRA SALAS ALBERTO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUIZ BUSONS VICTORMANUEL;ERAUSO SANZ NAIARA. Datos registrales. T 5738, L 4645, F 147, S 8, H MA 17498, I/A 45 (15.10.20).

11 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: VALLS SERRAT JUAN. Presidente: VALLS SERRAT JUAN. Nombramientos. Consejero:ZIMMERMAN MICHAEL R. Presidente: ZIMMERMAN MICHAEL R. Datos registrales. T 5738, L 4645, F 147, S 8, H MA 17498, I/A43 ( 3.02.20).

07 de Noviembre de 2019
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5738, L 4645, F 146, S 8, H MA 17498, I/A 42 (24.10.19).

28 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: SPIEGEL MARY ANN. Nombramientos. Consejero: OTSUKA LOVE JANET. Reelecciones.Presidente: VALLS SERRAT JUAN. Consejero: SAAVEDRA SALAS ALBERTO. Presidente: VALLS SERRAT JUAN. Datosregistrales. T 5738, L 4645, F 146, S 8, H MA 17498, I/A 41 (15.10.19).

08 de Agosto de 2019
Revocaciones. Apoderado: GLOOR JEAN PHILLIPPE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MERX MARC. Datos registrales. T 5738,L 4645, F 146, S 8, H MA 17498, I/A 40 (30.07.19).

05 de Octubre de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5738, L 4645, F 146, S 8, H MA 17498, I/A 39 (26.09.18).

12 de Junio de 2018
Nombramientos. VsecrNoConsj: SORIA DIAZ JENNIFER. Datos registrales. T 4794, L 3702, F 19, S 8, H MA 17498, I/A 37(31.05.18).

Revocaciones. Apoderado: REQUENA SANCHEZ-GARRIDO GABRIEL;DOMINGUEZ ACIEGO ROSA;TORRES PICON M.ANGELES. Apo.Man.Soli: VILLALTA CAMACHO FRANCISCO JAVIER;MORALES MANSITO ALEJANDRO. Apoderado: GONZALEZACERO SANDRA;SAAVEDRA SALAS ALBERTO. Nombramientos. Apoderado: SAAVEDRA SALAS ALBERTO;REQUENASANCHEZ-GARRIDO GABRIEL;DOMINGUEZ ACIEGO ROSA;GONZALEZ ACERO SANDRA;TORRES PICON M.ANGELES;VILLALTA CAMACHO FRANCISCO JAVIER;MORALES MANSITO ALEJANDRO;GONCALVES MARTINSMONIQUE;AMARA JONATHAN ADRIEN;GLOOR JEAN PHILLIPPE. Datos registrales. T 4794, L 3702, F 19, S 8, H MA 17498, I/A38 (31.05.18).

30 de Octubre de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4794, L 3702, F 19, S 8, H MA 17498, I/A 36 (20.10.17).

30 de Agosto de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4794, L 3702, F 19, S 8, H MA 17498, I/A 35 (22.08.16).

04 de Noviembre de 2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4794, L 3702, F 19, S 8, H MA 17498, I/A 34 (26.10.15).

08 de Octubre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ DE MUNAIN ROMAN AGUSTIN. Presidente: RUIZ DE MUNAIN ROMAN AGUSTIN. Consejero:REQUENA SANCHEZ-GARRIDO GABRIEL. Nombramientos. Consejero: VALLS SERRAT JUAN;SPIEGEL MARY ANN. Presidente:VALLS SERRAT JUAN. Datos registrales. T 4794, L 3702, F 18, S 8, H MA 17498, I/A 32 (30.09.14).

Revocaciones. Apoderado: RUIZ DE MUNAIN ROMAN AGUSTIN. Nombramientos. Apoderado: SAAVEDRA SALAS ALBERTO.Datos registrales. T 4794, L 3702, F 18, S 8, H MA 17498, I/A 33 (30.09.14).

08 de Agosto de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4794, L 3702, F 18, S 8, H MA 17498, I/A 31 (30.07.14).

14 de Enero de 2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CUADROS BEHN JUAN MIGUEL. Datos registrales. T 4794, L 3702, F 18, S 8, H MA 17498, I/A 30 (3.01.14).

25 de Septiembre de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4794, L 3702, F 18, S 8, H MA 17498, I/A 29 (16.09.13).

07 de Agosto de 2013
Reelecciones. Consejero: RUIZ DE MUNAIN ROMAN AGUSTIN. Presidente: RUIZ DE MUNAIN ROMAN AGUSTIN. Consejero:SAAVEDRA SALAS ALBERTO;REQUENA SANCHEZ-GARRIDO GABRIEL. Datos registrales. T 4794, L 3702, F 17, S 8, H MA17498, I/A 28 (26.07.13).

29 de Agosto de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4794, L 3702, F 17, S 8, H MA 17498, I/A 27 (14.08.12).

02 de Abril de 2012
Revocaciones. Apoderado: PEREZ CACERES MAXIMINO. Datos registrales. T 4794, L 3702, F 17, S 8, H MA 17498, I/A 25(15.03.12).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ ACERO SANDRA. Datos registrales. T 4794, L 3702, F 17, S 8, H MA 17498, I/A 26(15.03.12).

19 de Octubre de 2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4794, L 3702, F 16, S 8, H MA 17498, I/A 24 ( 5.10.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información