Buscador CIF Logo

Actos BORME Quival Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Quival Sa

Actos BORME Quival Sa - A36014330

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Pontevedra para Quival Sa con CIF A36014330

🔙 Perfil de Quival Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Pontevedra

Actos BORME de Quival Sa

07 de Septiembre de 2022
Reelecciones. Auditor: RANDULFE Y CASARIEGO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 989, L 989, F 200, S 8, H PO 1990, I/A35 (30.08.22).

10 de Septiembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: VALIÑO MARQUEZ IGNACIO. Con.Delegado: QUINTAS GONZALEZ MARIA LUISA.Nombramientos. Consejero: QUINTAS GONZALEZ FERNANDO. Con.Delegado: QUINTAS GONZALEZ MARIA LUISA.Reelecciones. Consejero: QUINTAS GONZALEZ MARIA LUISA. Presidente: QUINTAS GONZALEZ MARIA LUISA. Consejero:QUINTAS GONZALEZ JOSE LUIS. Secretario: QUINTAS GONZALEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 989, L 989, F 200, S 8, H PO1990, I/A 34 (30.08.19).

15 de Abril de 2019
Nombramientos. Auditor: RANDULFE Y CASARIEGO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 989, L 989, F 199, S 8, H PO 1990,I/A 33 ( 8.04.19).

10 de Octubre de 2017
Nombramientos. Apoderado: QUINTAS GONZALEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 989, L 989, F 199, S 8, H PO 1990, I/A 32(28.09.17).

06 de Octubre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: QUINTAS GONZALEZ MIGUEL. Secretario: QUINTAS GONZALEZ MIGUEL. Nombramientos.Secretario: QUINTAS GONZALEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 989, L 989, F 198, S 8, H PO 1990, I/A 31 (28.09.17).

15 de Abril de 2016
Ceses/Dimisiones. Auditor: VAZQUEZ FERRO JOSE ANTONIO. Aud.Supl.: GOMEZ CAPEANS JUAN JESUS. Datos registrales. T989, L 989, F 197, S 8, H PO 1990, I/A 29 ( 4.04.16).

Nombramientos. Auditor: RANDULFE Y CASARIEGO AUDITORES SC. Otros conceptos: Modificación del Artículo 11º de losEstatutos Sociales relativo al sistema de comunicación de la convocatoria de la junta general de accionistas y modificación del Artículo15º relativo al sistema de retribución del órgano de administración. Datos registrales. T 989, L 989, F 198, S 8, H PO 1990, I/A 30 (4.04.16).

09 de Abril de 2015
Reelecciones. Auditor: VAZQUEZ FERRO JOSE ANTONIO. Aud.Supl.: GOMEZ CAPEANS JUAN JESUS. Datos registrales. T 989,L 989, F 197, S 8, H PO 1990, I/A 28 (30.03.15).

07 de Enero de 2015
Reelecciones. Consejero: VALIÑO MARQUEZ IGNACIO;QUINTAS GONZALEZ MARIA LUISA;QUINTAS GONZALEZ JOSELUIS;QUINTAS GONZALEZ MIGUEL. Presidente: QUINTAS GONZALEZ MARIA LUISA. Secretario: QUINTAS GONZALEZ MIGUEL.Datos registrales. T 989, L 989, F 197, S 8, H PO 1990, I/A 26 (26.12.14).

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Con.Delegado: QUINTAS GONZALEZ MARIA LUISA. Nombramientos.Con.Delegado: QUINTAS GONZALEZ MARIA LUISA. Datos registrales. T 989, L 989, F 197, S 8, H PO 1990, I/A 27 (26.12.14).

02 de Abril de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: QUINTAS BOUZO JOSE. Secretario: QUINTAS GONZALEZ MARIA LUISA. Presidente: QUINTASBOUZO JOSE. Con.Delegado: QUINTAS BOUZO JOSE. Nombramientos. Presidente: QUINTAS GONZALEZ MARIA LUISA.Secretario: QUINTAS GONZALEZ MIGUEL. Con.Delegado: QUINTAS GONZALEZ MARIA LUISA. Datos registrales. T 989, L 989, F190, S 8, H PO 1990, I/A 25 (25.03.14).

09 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUANA ARNAL MARIA JOSE. Datos registrales. T 989, L 989, F 188, S 8, H PO 1990, I/A 20 (2.09.11).

11 de Enero de 2012
Reelecciones. Auditor: VAZQUEZ FERRO JOSE ANTONIO. Aud.Supl.: GOMEZ CAPEANS JUAN JESUS. Datos registrales. T 989,L 989, F 190, S 8, H PO 1990, I/A 23 (29.12.11).

Reelecciones. Auditor: VAZQUEZ FERRO JOSE ANTONIO. Aud.Supl.: GOMEZ CAPEANS JUAN JESUS. Datos registrales. T 989,L 989, F 190, S 8, H PO 1990, I/A 24 (29.12.11).

13 de Octubre de 2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PRATS PALOMO DAVID;PONT AMENOS JOSEP;PUIG COLL JOAN;RIBE ARBOS JOAN;BALASCHJOVAL ANTONIO;QUINTAS BOUZO JOSE;TECLES MONTIEL JULIO ANTONIO;PREGO BASTOS JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 989, L 989, F 189, S 8, H PO 1990, I/A 21 (29.09.11).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: QUINTAS GONZALEZ MARIA LUISA;QUINTAS GONZALEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 989,L 989, F 189, S 8, H PO 1990, I/A 22 (29.09.11).

15 de Septiembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Presidente: TECLES MONTIEL JULIO ANTONIO. Consejero: TECLES MONTIEL JULIO ANTONIO;COS GOMEZVICENTE;RUANA ARNAL MARIA JOSE. Secretario: RUANA ARNAL MARIA JOSE. Nombramientos. Consejero: QUINTASGONZALEZ MARIA LUISA;QUINTAS GONZALEZ JOSE LUIS;QUINTAS GONZALEZ MIGUEL.Presidente: QUINTAS BOUZO JOSE.Secretario: QUINTAS GONZALEZ MARIA LUISA. Con.Delegado: QUINTAS BOUZO JOSE. Modificaciones estatutarias. Artículode los estatutos: ARTICULO 20.- El ejercicio social comenzará el primero de Enero de cada año y terminará eltreinta y uno dediciembre del mismo año. Por excepción el ejercicio iniciado el uno de junio de 2011 finalizará el 31 de diciembre de 2.011.. Datosregistrales. T 989, L 989, F 188, S 8, H PO 1990, I/A 20 ( 2.09.11).

28 de Julio de 2010
Nombramientos. Auditor: VAZQUEZ FERRO JOSE ANTONIO;VAZQUEZ FERRO JOSE ANTONIO. Aud.Supl.: GOMEZ CAPEANSJUAN JESUS;GOMEZ CAPEANS JUAN JESUS. Auditor: VAZQUEZ FERRO JOSE ANTONIO. Aud.Supl.: GOMEZ CAPEANS JUANJESUS. Auditor: VAZQUEZ FERRO JOSE ANTONIO. Aud.Supl.: GOMEZ CAPEANS JUAN JESUS. Auditor: VAZQUEZ FERRO JOSEANTONIO. Aud.Supl.: GOMEZ CAPEANS JUAN JESUS. Auditor: VAZQUEZ FERRO JOSE ANTONIO. Aud.Supl.: GOMEZ CAPEANSJUAN JESUS. Auditor: VAZQUEZ FERRO JOSE ANTONIO. Aud.Supl.: GOMEZ CAPEANS JUAN JESUS. Auditor: VAZQUEZ FERROJOSE ANTONIO. Aud.Supl.: GOMEZ CAPEANS JUAN JESUS. Auditor: VAZQUEZ FERRO JOSE ANTONIO. Aud.Supl.: GOMEZCAPEANS JUAN JESUS. Datos registrales. T 989, L 989, F 188, S 8, H PO 1990, I/A 19 (14.07.10).

22 de Octubre de 2009
Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL "A FACHA" PARCELA 8 - REDONDE (CAMPO LAMEIRO). Cambio de objetosocial. La sociedad tendrá por objeto social el comercio al por mayor de frutos secos. Pudiendo asociarse con otras sociedades delmismo ramo, relacionadas con su objeto social. Datos registrales. T 989, L 989, F 187, S 8, H PO 1990, I/A 17 ( 8.10.09).

Reelecciones. Consejero: RUANA ARNAL MARIA JOSE;COS GOMEZ VICENTE;TECLES MONTIEL JULIO ANTONIO;QUINTASBOUZO JOSE;VALIÑO MARQUEZ IGNACIO. Presidente: TECLES MONTIEL JULIO ANTONIO. Secretario: RUANA ARNAL MARIAJOSE. Datos registrales. T 989, L 989, F 188, S 8, H PO 1990, I/A 18 ( 8.10.09).

21 de Enero de 2009
Revocaciones. Apo.Manc.: VALIÑO MARQUEZ IGNACIO;PREGO BASTOS JOSE MANUEL. Apo.Sol.: VALIÑO MARQUEZIGNACIO;PREGO BASTOS JOSE MANUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PRATS PALOMO DAVID;PONT AMENOSJOSEP;PUIG COLL JOAN;RIBE ARBOS JOAN;BALASCH JOVAL ANTONIO;QUINTAS BOUZO JOSE;TECLES MONTIEL JULIOANTONIO;PREGO BASTOS JOSE MANUEL. Datos registrales. T 989, L 989, F 186, S 8, H PO 1990, I/A 16 ( 8.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información