Buscador CIF Logo

Actos BORME R. G. T. Desarrollo Informatico Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera R. G. T. Desarrollo Informatico Sl

Actos BORME R. G. T. Desarrollo Informatico Sl - B93279529

Tenemos registrados 36 Actos BORME del Registro Mercantil de Malaga para R. G. T. Desarrollo Informatico Sl con CIF B93279529

🔙 Perfil de R. G. T. Desarrollo Informatico Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Malaga

Actos BORME de R. G. T. Desarrollo Informatico Sl

28 de Junio de 2022
Reelecciones. Auditor: ALCAZABA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 5796, L 4703, F 213, S 8, H MA119789, I/A 38(16.06.22).

23 de Junio de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: KILPATRICK JANE;MANCIAUSKAITE LAURA;VALENZUELA BELDA MARIA CRISTINA;GARCIAAGUA AGUERA LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 5796, L 4703, F 213, S 8, H MA119789, I/A 39 (16.06.22).

Revocaciones. Apoderado: FARNWORTH MARTYN LEE. Datos registrales. T 5796, L 4703, F 214, S 8, H MA119789, I/A 40(16.06.22).

27 de Mayo de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BIANCHI MARCO GUIDO. Nombramientos. Adm. Solid.: SCHROEDER KAI ALBRECHT;FORTESHIDALGO ALBERTO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios.Datos registrales. T 5796, L 4703, F 213, S 8, H MA119789, I/A 37 (19.05.22).

04 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apoderado: DA CAMARA ANTON NURIA. Datos registrales. T 5796, L 4703, F 212, S 8, H MA119789, I/A 36(24.07.20).

05 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: BLANC CAROLINE. Apo.Manc.: BLANC CAROLINE. Datos registrales. T 5796, L 4703, F 212, S 8, HMA119789, I/A 34 (27.11.19).

Nombramientos. Apoderado: FORTES HIDALGO ALBERTO. Datos registrales. T 5796, L 4703, F 212, S 8, H MA119789, I/A 35(27.11.19).

14 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apoderado: SCHRODER KAI ALBRECHT. Datos registrales. T 5796, L 4703, F 211, S 8, H MA119789, I/A 33 (3.10.19).

07 de Marzo de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: FARNWORTH MARTYN LEE. Datos registrales. T 5796, L 4703, F 211, S 8, H MA119789, I/A 31(25.02.19).

Nombramientos. Apo.Manc.: SABORIDO CEBALLOS LIDIA. Datos registrales. T 5796, L 4703, F 211, S 8, H MA119789, I/A 32(25.02.19).

16 de Enero de 2019
Nombramientos. Auditor: ALCAZABA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 5796, L 4703, F 211, S 8, H MA119789, I/A 30 (4.01.19).

03 de Octubre de 2018
Revocaciones. Apoderado: BERDUGO CABEZA SARA. Datos registrales. T 5181, L 4088, F 219, S 8, H MA119789, I/A 29(25.09.18).

09 de Abril de 2018
Nombramientos. Apoderado: DA CAMARA ANTON NURIA. Datos registrales. T 5181, L 4088, F 219, S 8, H MA119789, I/A 28(22.03.18).

21 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MACGREGOR ROBERT SCOTT. Nombramientos. Adm. Unico: BIANCHI MARCO GUIDO. Datosregistrales. T 5181, L 4088, F 219, S 8, H MA119789, I/A 27 ( 9.11.17).

28 de Junio de 2017
Nombramientos. Apo.Manc.: FARNWORTH MARTYN LEE;BLANC CAROLINE;SCHRODER KAI ALBRECHT;FORTES HIDALGOALBERTO Datos registrales. T 5181, L 4088, F 218, S 8, H MA119789, I/A 25 (15.06.17).

Revocaciones. Apo.Manc.: FARNWORTH MARTYN LEE;BLANC CAROLINE;SCHRODER KAI ALBRECHT. Datos registrales. T5181, L 4088, F 219, S 8, H MA119789, I/A 26 (15.06.17).

21 de Febrero de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: CIRIA RAMIREZ MARIA LUISA;BLANC CAROLINE. Datos registrales. T 5181, L 4088, F 218, S 8, HMA119789, I/A 23 (13.02.17).

Nombramientos. Apo.Manc.: FARNWORTH MARTYN LEE;BLANC CAROLINE;SCHRODER KAI ALBRECHT;GONZALEZ RUBIOMARIA RAQUEL. Datos registrales. T 5181, L 4088, F 218, S 8, H MA119789, I/A 24 (13.02.17).

12 de Diciembre de 2016
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Cierre del Ejercicio.-. Datos registrales. T 5181, L 4088, F 218, S 8, HMA119789, I/A 22 (29.11.16).

23 de Septiembre de 2016
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social y web corporativa.-. Cambio de domicilio social. C/SEVERO OCHOA 16-20 - EDF. NERJA, PARQUE TECNOLO (MALAGA). Datos registrales. T 5181, L 4088, F 217, S 8, HMA119789, I/A 18 (14.09.16).

Nombramientos. Apoderado: BERDUGO CABEZA SARA. Datos registrales. T 5181, L 4088, F 217, S 8, H MA119789, I/A 19(14.09.16).

Revocaciones. Apo.Manc.: CIRIA RAMIREZ MARIA LUISA;MCCANCE LEE MICHAEL;BLANC CAROLINE. Datos registrales. T5181, L 4088, F 217, S 8, H MA119789, I/A 20 (14.09.16).

Nombramientos. Apo.Manc.: CIRIA RAMIREZ MARIA LUISA;BLANC CAROLINE. Datos registrales. T 5181, L 4088, F 218, S 8, HMA119789, I/A 21 (14.09.16).

20 de Mayo de 2016
Nombramientos. Auditor: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP. Datos registrales. T 5181, L 4088, F 217, S 8, H MA119789,I/A 17 (11.05.16).

06 de Mayo de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: TIJERIN MARTIN SILVIA;CIRIA RAMIREZ MARIA LUISA;MCCANCE LEE MICHAEL. Datos registrales.T 5181, L 4088, F 216, S 8, H MA119789, I/A 13 (26.04.16).

Revocaciones. Apoderado: TIJERIN MARTIN SILVIA. Datos registrales. T 5181, L 4088, F 216, S 8, H MA119789, I/A 14(26.04.16).

Nombramientos. Apo.Manc.: CIRIA RAMIREZ MARIA LUISA;MCCANCE LEE MICHAEL;BLANC CAROLINE. Datos registrales. T5181, L 4088, F 216, S 8, H MA119789, I/A 15 (26.04.16).

Nombramientos. Apoderado: BLANC CAROLINE. Datos registrales. T 5181, L 4088, F 217, S 8, H MA119789, I/A 16 (26.04.16).

09 de Marzo de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GILLESPIE ROBERT JOSEPH. Nombramientos. Adm. Unico: MACGREGOR ROBERT SCOTT.Datos registrales. T 5181, L 4088, F 216, S 8, H MA119789, I/A 11 (26.02.16).

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: THE WORKSHOP TECHNOLOGIES LTD. Datos registrales. T5181, L 4088, F 216, S 8, H MA119789, I/A 12 ( 1.03.16).

30 de Abril de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: TIJERIN MARTIN SILVIA;CIRIA RAMIREZ MARIA LUISA;MCCANCE LEE MICHAEL. Datosregistrales. T 5181, L 4088, F 215, S 8, H MA119789, I/A 10 (21.04.15).

09 de Abril de 2015
Revocaciones. Apoderado: CIRIA RAMIREZ MARIA LUISA;MCCANCE LEE MICHAEL;TIJERIN MARTIN SILVIA. Datos registrales.T 5181, L 4088, F 215, S 8, H MA119789, I/A 9 (27.03.15).

13 de Octubre de 2014
Nombramientos. Apoderado: MCCANCE LEE MICHAEL. Datos registrales. T 5181, L 4088, F 215, S 8, H MA119789, I/A 7 (2.10.14).

Nombramientos. Apoderado: TIJERIN MARTIN SILVIA. Datos registrales. T 5181, L 4088, F 215, S 8, H MA119789, I/A 8 (2.10.14).

02 de Enero de 2014
Nombramientos. Apoderado: CIRIA RAMIREZ MARIA LUISA. Datos registrales. T 5181, L 4088, F 214, S 8, H MA119789, I/A 5(23.12.13).

Nombramientos. Apoderado: TIJERIN MARTIN SILVIA. Datos registrales. T 5181, L 4088, F 215, S 8, H MA119789, I/A 6(23.12.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información