Actos BORME de Radiometer Iberica Sl
18 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apoderado: LOPEZ PUMAREGA JOSE LUIS. Datos registrales. T 45798 , F 121, S 8, H M 54210, I/A 58 (5.12.23).
15 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apoderado: LOPEZ PUMAREGA JOSE LUIS. Datos registrales. T 45798 , F 121, S 8, H M 54210, I/A 58 (5.12.23).
16 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: UZELAC LJUBICA;SERRANO MORENO MERCEDES. Apo.Manc.: JENSEN SUSANNETHRANE;ANDERSEN KAREN BRIYHE SVAERKE;KOSTECKI MIA;MEYER ANNE-CECILE;SERRANO MORENO MERCEDES.Apoderado: SERRANO MORENO MERCEDES. Nombramientos. Apoderado: PEREZ GARCIA DANIEL;VALGIMIGLISTEFANO;PIESYK ADRIANNA;OSTROWSKA AGNIESZKA;KAZMIERCZAK NATALIA;GUNZER AGNIESZKA;KOZAKIEWICZ
13 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: MCFADEN FRANK. Datos registrales. T 27048 , F 140, S 8, H M 54210, I/A 56 ( 5.10.23).
02 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27048 , F 139, S 8, H M 54210, I/A 55 (25.10.22).
25 de Mayo de 2022Ceses/Dimisiones. Presidente: BRANDBORG HENRIK. Consejero: BRANDBORG HENRIK. Nombramientos. Consejero:HELSTRUP MARIANNE. Presidente: MADSEN CLAUS LOENBORG. Datos registrales. T 27048 , F 138, S 8, H M 54210, I/A 53(18.05.22).
Revocaciones. Apo.Sol.: MEYER ANNE-CECILE. Nombramientos. Apoderado: SANZ RODRIGUEZ MARIA DE LOSANGELES;SERRANO MORENO MERCEDES. Datos registrales. T 27048 , F 138, S 8, H M 54210, I/A 54 (18.05.22).
01 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: LISTWAN BOGUMILA;CIELNAK AGNIESZCA EWA;PERKIEWIEZ AGNIESZCA ANNA;PRZEMYSLAWKOZAK;MEYER ANNE-CECILE;SERRANO MORENO MERCEDES. Datos registrales. T 27048 , F 137, S 8, H M 54210, I/A 52(24.06.21).
30 de Septiembre de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: MOLENAAR ANDRE;LUNDEGAARD THOMAS;PORTILLO RIOS JUAN CARLOS;HOJBO OLSENSUSANNE;NICOLAJ LUND CHRISTIAN;THORSEN TRINE;KLARSKOV JOHN;SERRANO MORENO MERCEDES;KOSTECKI MIA.Apoderado: PORTILLO RIOS JUAN CARLOS;SERRANO MORENO MERCEDES. Apo.Manc.: PORTILLO RIOS JUAN CARLOS.Apo.Sol.: SERRANO MORENO MERCEDES. Apo.Manc.: SERRANO MORENO MERCEDES;LUND CHRISTIAN NICOLAJ;MOELLERTHOMAS LUNDEGAARD;SERRANO MORENO MERCEDES;ANDERSEN BIRTHE SVAERKE. Apoderado: NIELSEN ANNE SOFIENYMARK;OVERBECK CAMILA LUNDIN;GRONEMANN METTE. Apo.Sol.: DARNA GALOBART PABLO;DARNA GALOBART PABLO.Apo.Manc.: JENSEN SUSANNE THRANE;ANDERSEN KAREN BRIYHE SVAERKE;PETERSEN ALLAN JOACHIM;KOSTECHIMIA;MWAEUGANGA ABIGAIL WAKESHO;DALGAARD DANIEL GALLIANO;HOFFREN MAJBRIT TEHOMAA;UZELAC LJUBICA.Apo.Sol.: UZELAC LJUBICA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: UZELAC LJUBICA. Apo.Sol.: MEYER ANNE-CECILE. Apo.Man.Soli:SERRANO MORENO MERCEDES. Apo.Manc.: JENSEN SUSANNE THRANE;LUND CHRISTIAN NICOLAJ;MOELLER THOMASLUNDEGAARD;ANDERSEN KAREN BRIYHE SVAERKE;PETERSEN ALLAN JOACHIM;KOSTECKI MIA;SIEMIATKOWSKA ANNAMARIA;WIACEK MONIKA GRAZYNA;WISNIEWSKA IZABELA SYLWIA. Datos registrales. T 27048 , F 135, S 8, H M 54210, I/A 51(23.09.20).
25 de Septiembre de 2020Revocaciones. Apoderado: OTERO LOPEZ VANESSA. Datos registrales. T 27048 , F 135, S 8, H M 54210, I/A 50 (18.09.20).
20 de Julio de 2020Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27048 , F 134, S 8, H M 54210, I/A 49 (13.07.20).
31 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: JENSEN PETER-KURTEIN. Nombramientos. Consejero: SCHIMMELL NIELSEN HENRIK. Datosregistrales. T 27048 , F 134, S 8, H M 54210, I/A 48 (24.01.20).
11 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PORTILLO RIOS JUAN CARLOS. Revocaciones. Apo.Manc.: BREHMER DAVILA MARIATERESA. Apo.Sol.: BREHMER DAVILA MARIA TERESA. Apo.Manc.: BREHMER DAVILA MARIA TERESA. Nombramientos.SecreNoConsj: UZELAC LJUBICA. Apo.Manc.: UZELAC LJUBICA. Apo.Sol.: UZELAC LJUBICA. Apo.Manc.: SERRANO MORENOMERCEDES. Datos registrales. T 27048 , F 133, S 8, H M 54210, I/A 47 ( 4.11.19).
03 de Julio de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: KNUDSEN LARS SECHER. Presidente: KNUDSEN LARS SECHER. Nombramientos. Consejero:BRANDBORG HENRIK. Datos registrales. T 27048 , F 132, S 8, H M 54210, I/A 45 (25.06.18).
Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDEZ SERRANO CARLOS HONORIO. Apoderado: FERNANDEZ SERRANO CARLOSHONORIO. Nombramientos. Presidente: BRANDBORG HENRIK. Apo.Manc.: BREHMER DAVILA MARIA TERESA;PORTILLORIOS JUAN CARLOS. Apo.Sol.: BREHMER DAVILA MARIA TERESA;DARNA GALOBART PABLO;SERRANO MORENOMERCEDES;DARNA GALOBART PABLO. Apo.Manc.: BREHMER DAVILA MARIA TERESA;SERRANO MORENOMERCEDES;JENSEN SUSANNE THRANE;LUND CHRISTIAN NICOLAJ;MOELLER THOMAS LUNDEGAARD;ANDERSEN KARENBRIYHE SVAERKE;PETERSEN ALLAN JOACHIM;KOSTECHI MIA;MWAEUGANGA ABIGAIL WAKESHO;DALGAARD DANIELGALLIANO;HOFFREN MAJBRIT TEHOMAA. Datos registrales. T 27048 , F 132, S 8, H M 54210, I/A 46 (25.06.18).
19 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: OTERO LOPEZ VANESSA. Datos registrales. T 27048 , F 132, S 8, H M 54210, I/A 44 ( 9.03.18).
13 de Marzo de 2018Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27048 , F 131, S 8, H M 54210, I/A 43 ( 6.03.18).
18 de Abril de 2016Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27048 , F 131, S 8, H M 54210, I/A 42 ( 8.04.16).
11 de Febrero de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: BJERREGAARD DORTHE;KRISTENSEN BJARNE. Nombramientos. Apoderado: NIELSEN ANNESOFIE NYMARK;OVERBECK CAMILA LUNDIN;GRONEMANN METTE. Datos registrales. T 27048 , F 130, S 8, H M 54210, I/A 40(31.01.14).
Cambio de domicilio social. AVDA DE VALGRANDE 8 2 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 27048 , F 131, S 8, H M 54210, I/A41 ( 3.02.14).
16 de Enero de 2013Otros conceptos: CAMBIO DE DENOMINACION DEL SOCIO QUE OSTENTA EL 99 % DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDADDE ESTA HOJA KOLLMORGEN SAS POR LA ACTUAL QUE ES LIFE SCIENCES HOLDING FRANCE SAS. Datos registrales. T27048 , F 130, S 8, H M 54210, I/A 39 ( 9.01.13).
01 de Agosto de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: MORTENSEN MICHAEL. Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ SERRANO CARLOSHONORIO;MORTENSEN MICHAEL. Apoderado: MORTENSEN MICHAEL;FERNANDEZ SERRANO CARLOS HONORIO;PORTILLORIOS JUAN CARLOS;SERRANO MORENO MERCEDES;PORTILLO RIOS JUAN CARLOS;SERRANO MORENO MERCEDES.Apo.Manc.: MORTENSEN MICHAEL. Nombramientos. SecreNoConsj: PORTILLO RIOS JUAN CARLOS. Apoderado: PORTILLORIOS JUAN CARLOS;SERRANO MORENO MERCEDES;FERNANDEZ SERRANO CARLOS HONORIO. Datos registrales. T 27048, F 129, S 8, H M 54210, I/A 38 (20.07.11).
09 de Diciembre de 2010Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27048 , F 128, S 8, H M 54210, I/A 37 (25.11.10).
21 de Enero de 2010Revocaciones. Apoderado: BJERREGAARD DORTHE;MOLENAAR ANDRE;LUNDEGAARD THOMAS;MORTENSENMICHAEL;KRISTENSEN BJARNE;HOJBO OLSEN SUSANNE;NICOLAJ LUND CHRISTIAN;THORSEN TRINE;KLARSKOV JOHN.Apo.Manc.: SERRANO MORENO MERCEDES;LUNDEGAARD THOMAS;MORTENSEN MICHAEL;FERNANDEZ SERRANO CARLOSHONORIO;PORTILLO RIOS JUAN CARLOS;HOJBO OLSEN SUSANNE;KRISTENSEN BJARNE;NICOLAJ LUNDCHRISTIAN;THORSEN TRINE;KLARSKOV JOHN. Nombramientos. Apo.Manc.: BJERREGAARD DORTHE;MOLENAARANDRE;LUNDEGAARD THOMAS;MORTENSEN MICHAEL;FERNANDEZ SERRANO CARLOS HONORIO;PORTILLO RIOS JUANCARLOS;HOJBO OLSEN SUSANNE;KRISTENSEN BJARNE;NICOLAJ LUND CHRISTIAN;THORSEN TRINE;KLARSKOVJOHN;SERRANO MORENO MERCEDES;ANDERSEN BIRTHE SVAERKE;KOSTECKI MIA. Otros conceptos: Quedan revocadosdon Carlos Honorio Fernandez Serrano y donJuan Carlos Portillo Rios para la facultad de poder de disposicion de cuentas bancariasde todo tipo y abiertas en cualquier pais de la Union Europea, inscritos por la 31. Datos registrales. T 27048 , F 127, S 8, H M 54210,I/A 36 (11.01.10).
04 de Noviembre de 2009Reelecciones. Auditor: AUDIHISPANA GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 27048 , F 127, S 8, H M 54210, I/A 35(22.10.09).
22 de Octubre de 2009Revocaciones. Apoderado: BOMHOLTZ THORKILD. Nombramientos. Apo.Manc.: SERRANO MORENOMERCEDES;LUNDEGAARD THOMAS;MORTENSEN MICHAEL;FERNANDEZ SERRANO CARLOS HONORIO;PORTILLO RIOSJUAN CARLOS;HOJBO OLSEN SUSANNE;KRISTENSEN BJARNE;NICOLAJ LUND CHRISTIAN;THORSEN TRINE;KLARSKOVJOHN. Datos registrales. T 14714 , F 52, S 8, H M 54210, I/A 34 ( 9.10.09).