Actos BORME de Raser 21 Sociedad Limitada
01 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: MONTA脩ES CUESTA MARIA TERESA;VILLAR BELTRAN EDUARDO. Datos registrales. T 10740, L8020, F 64, S 8, H V 133279, I/A 27 (24.11.23).
18 de Abril de 2023Nombramientos. Apo.Manc.: RUIZ FERRANDO TAMARA. Datos registrales. T 10740, L 8020, F 64, S 8, H V 133279, I/A 26(11.04.23).
21 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: MARTINEZ REYNAL JESUS. Datos registrales. T 10740, L 8020, F 64, S 8, H V 133279, I/A 25(10.03.23).
22 de Junio de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANJUAN GARCIA MARIA JULIA. Apo.Manc.: MARTINEZ REYNAL JESUS;MONTA脩ES CUESTAMARIA TERESA;VILLAR BELTRAN EDUARDO. Datos registrales. T 10740, L 8020, F 63, S 8, H V 133279, I/A 24 (14.06.22).
20 de Junio de 2022Cambio de domicilio social. C/ LA GRANJA 7 (ALMUSSAFES). Datos registrales. T 10740, L 8020, F 63, S 8, H V 133279, I/A 22(13.06.22).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MONTA脩ES CUESTA MARIA TERESA. Apo.Manc.: SANJUAN GARCIA MARIA JULIA;SANJUANGARCIA JULIA. Apo.Sol.: SANJUAN GARCIA JULIA. Apo.Manc.: VILLAR BELTRAN EDUARDO;VILLAR BELTRANEDUARDO;MARTINEZ REYNAL JESUS;MARTINEZ REYNAL JESUS;MICO GOMEZ MARIA JOSE;OME脩ACA MARTINEZESPERANZA;ROSA ESTEVE NURIA;RUIZ DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 10740, L 8020, F 63, S 8, H V133279, I/A 23 (13.06.22).
11 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONTA脩ES CUESTA MARIA TERESA. Apo.Manc.: SANJUAN GARCIA MARIA JULIA;VILLARBELTRAN EDUARDO;MARTINEZ REYNAL JESUS. Datos registrales. T 10740, L 8020, F 62, S 8, H V 133279, I/A 21 ( 4.06.21).
04 de Junio de 2021Fe de erratas: Rectificada referencia 01923712021 BORME 78 en la que se omiti贸 hacer constar la designaci贸n de D. Salvador MarcoVicente, como persona f铆sica representante de "Corona Boreal Servicios de Mensajer铆a SL" designada administradora 煤nica de "Raser21, S.L.". Datos registrales. T 10740, L 8020, F 61, S 8, H V 133279, I/A 17 (20.04.21).
13 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: SANJUAN GARCIA JULIA. Apo.Manc.: SANJUAN GARCIA JULIA;VILLAR BELTRANEDUARDO;MARTINEZ REYNAL JESUS. Datos registrales. T 10740, L 8020, F 61, S 8, H V 133279, I/A 19 ( 6.05.21).
Cambio de domicilio social. C/ CANAL CRESPO 6 (ALMUSSAFES). Datos registrales. T 10740, L 8020, F 61, S 8, H V 133279,I/A 20 ( 6.05.21).
05 de Mayo de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CORONA BOREAL SERVICIOS DE MENSAJERIA SOCIEDAD LIM.Datos registrales. T 10740, L 8020, F 61, S 8, H V 133279, I/A 18 (27.04.21).
27 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: VALERO GIMENEZ VICTOR PASCUAL;VALERO GIMENEZ JAVIER. Nombramientos. Adm.Unico: MARCO VINCENT SALVADOR. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 10740, L 8020, F 61, S 8, H V 133279, I/A 17 (20.04.21).
06 de Octubre de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: MICO GOMEZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 10740, L 8020, F 61, S 8, H V 133279, I/A 16(29.09.20).
12 de Noviembre de 2019Revocaciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.Datos registrales. T 10740, L 8020, F 61, S 8, H V 133279, I/A 15 ( 5.11.19).
21 de Noviembre de 2017Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 9015, L 6300, F 212, S 8, H V 133279, I/A 14 (13.11.17).
27 de Mayo de 2015Revocaciones. Apoderado: VALERO GIMENEZ MARGARITA. Datos registrales. T 9015, L 6300, F 212, S 8, H V 133279, I/A 11(20.05.15).
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: FERROSTAAL AUTOMOTIVE SPAIN SL. Datos registrales. T9015, L 6300, F 212, S 8, H V 133279, I/A 12 (20.05.15).
Nombramientos. Apo.Manc.: OME脩ACA MARTINEZ ESPERANZA;ROSA ESTEVE NURIA;RUIZ DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL.Datos registrales. T 9015, L 6300, F 212, S 8, H V 133279, I/A 13 (20.05.15).
10 de Abril de 2015Cambio de domicilio social. C/ PONENT 8 - POLIGONO INDUSTRIAL REY JUAN CARLOS (ALMUSSAFES). Datos registrales. T9015, L 6300, F 211, S 8, H V 133279, I/A 9 ( 1.04.15).
Ceses/Dimisiones. Consejero: GIMENEZ PEYRO MARGARITA;VALERO GIMENEZ MARGARITA;VALERO GIMENEZJAVIER;VALERO GIMENEZ VICTOR PASCUAL. Presidente: VALERO GIMENEZ JAVIER. Secretario: VALERO GIMENEZMARGARITA. Cons.Del.Man: VALERO GIMENEZ JAVIER;VALERO GIMENEZ VICTOR PASCUAL;VALERO GIMENEZ MARGARITA.Nombramientos. Adm. Mancom.: VALERO GIMENEZ JAVIER;VALERO GIMENEZ VICTOR PASCUAL. Otros conceptos: Cambiodel Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 9015, L 6300, F211, S 8, H V 133279, I/A 10 ( 1.04.15).
22 de Julio de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANCHIS CARBONELL CARMEN. Revocaciones. Apoderado: SANJUAN GARCIA JULIA.Nombramientos. Consejero: GIMENEZ PEYRO MARGARITA;VALERO GIMENEZ MARGARITA;VALERO GIMENEZJAVIER;VALERO GIMENEZ VICTOR PASCUAL. Presidente: VALERO GIMENEZ JAVIER. Secretario: VALERO GIMENEZMARGARITA. Cons.Del.Man: VALERO GIMENEZ JAVIER;VALERO GIMENEZ VICTOR PASCUAL;VALERO GIMENEZ MARGARITA.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T9015, L 6300, F 210, S 8, H V 133279, I/A 6 (15.07.14).
Nombramientos. Apoderado: VALERO GIMENEZ MARGARITA. Datos registrales. T 9015, L 6300, F 211, S 8, H V 133279, I/A 7(15.07.14).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GRUPO VALAUTOMOCION SL. Datos registrales. T 9015, L 6300, F 211, S 8, H V133279, I/A 8 (15.07.14).