Actos BORME de Rauros Zmcom Sl
19 de Octubre de 2022Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MARTINEZ ESPINAR JAVIER-MARIA. Nombramientos. Con.Delegado: VARELA SOTOFERNANDO. Datos registrales. T 34392 , F 200, S 8, H M 296597, I/A 24 (11.10.22).
Modificaciones estatutarias. Modificación del artículo 9º de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 34392 , F 200, S 8, H M296597, I/A 25 (11.10.22).
14 de Junio de 2022Revocaciones. Apoderado: ANDINO PILCO CARLOS ALBERTO. Nombramientos. Apoderado: ANDINO PILCO CARLOSALBERTO. Datos registrales. T 34392 , F 199, S 8, H M 296597, I/A 23 ( 7.06.22).
30 de Mayo de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: GRANDE FLOREZ JULIO. Nombramientos. Consejero: RAMOS GARCIA JOSE ANTONIO. Datosregistrales. T 34392 , F 199, S 8, H M 296597, I/A 22 (23.05.22).
10 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: RAMOS GARCIA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 34392 , F 198, S 8, H M 296597, I/A 21 (3.05.22).
28 de Enero de 2022Nombramientos. Apoderado: PATERNA LOPEZ OSCAR. Datos registrales. T 34392 , F 197, S 8, H M 296597, I/A 20 (21.01.22).
23 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: ALBRECHT ARQUER GUILLERMO. Con.Delegado: ALBRECHT ARQUER GUILLERMO.Nombramientos. Con.Delegado: MARTINEZ ESPINAR JAVIER-MARIA. Datos registrales. T 34392 , F 197, S 8, H M 296597, I/A19 (16.06.21).
13 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: ZAMPILLO PASTEN FRANO STANLEY;MORA DEVOTO URSULA MARIA. Datos registrales. T 34392 ,F 197, S 8, H M 296597, I/A 18 ( 6.04.21).
14 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Presidente: GRANDE FLOREZ JULIO. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ ESPINAR JAVIER-MARIA.Presidente: MARTINEZ ESPINAR JAVIER-MARIA. Datos registrales. T 34392 , F 196, S 8, H M 296597, I/A 17 ( 7.02.20).
05 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: ANDINO PILCO CARLOS ALBERTO. Datos registrales. T 34392 , F 196, S 8, H M 296597, I/A 16(28.11.18).
23 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apoderado: MARTIN MARTIN OLGA. Nombramientos. Apoderado: MARTIN MARTIN OLGA. Datos registrales. T34392 , F 195, S 8, H M 296597, I/A 15 (15.11.16).
01 de Agosto de 2016Cambio de domicilio social. C/ CALERA 3 - OFICINAS 18 Y 19.- (TRES CANTOS). Datos registrales. T 34392 , F 195, S 8, H M296597, I/A 14 (21.07.16).
08 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: VALERA SOTO FERNANDO. Nombramientos. Apo.Sol.: VARELA SOTO FERNANDO;BUENO TOMASMARIA DOLORES;BUENO TOMAS MARTA. Datos registrales. T 17297 , F 189, S 8, H M 296597, I/A 13 (31.03.16).
22 de Febrero de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: BUENO TOMAS DOLORES;BUENO TOMAS LAURA;BUENO TOMAS MARTA;SEGURAFONTCUBERTA JAVIER;BUENO TOMAS DOLORES;BUENO TOMAS MARTA. Datos registrales. T 17297 , F 188, S 8, H M
26 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: VALERA SOTO MARIA DE LOS ANGELES. Nombramientos. Consejero: GRANDE FLOREZJULIO;ALBRECHT ARQUER GUILLERMO;BUENO TOMAS PABLO;VARELA SOTO FERNANDO;POZO CARO ESTHER. Presidente:
26 de Octubre de 2015Declaración de unipersonalidad. Socio único: TECNICA Y PROYECTOS SA. Datos registrales. T 17297 , F 187, S 8, H M296597, I/A 10 (15.10.15).
20 de Octubre de 2015Revocaciones. Apoderado: DIEZ MUÑOZ CARMEN. Datos registrales. T 17297 , F 187, S 8, H M 296597, I/A 9 ( 8.10.15).
08 de Octubre de 2015Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ LAVIN JOSE-RAMON. Nombramientos. Apoderado: MARTIN MARTIN OLGA. Datosregistrales. T 17297 , F 186, S 8, H M 296597, I/A 8 (30.09.15).
29 de Julio de 2013Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ LAVIN JOSE-RAMON. Datos registrales. T 17297 , F 186, S 8, H M 296597, I/A 7(19.07.13).
17 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: LLORT MACDONALD DANIEL. Datos registrales. T 17297 , F 185, S 8, H M 296597, I/A 6 ( 4.05.12).
19 de Julio de 2010Nombramientos. Apoderado: DIEZ MUÑOZ CARMEN. Datos registrales. T 17297 , F 185, S 8, H M 296597, I/A 5 ( 7.07.10).