Buscador CIF Logo

Actos BORME Ravial Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ravial Sa

Actos BORME Ravial Sa - A08072894

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Ravial Sa con CIF A08072894

馃敊 Perfil de Ravial Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Ravial Sa

28 de Agosto de 2023
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 24.040,00 Euros. Resultante Suscrito: 96.160,00 Euros. Datos registrales. T 46538 , F 91,S 8, H B 26719, I/A 48 (18.08.23).

12 de Agosto de 2021
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: PRADES MARTINEZ ARTURO;PLANAS MONTSERRAT XAVIER. Nombramientos.ADM.SOLIDAR.: PRADES MARTINEZ ARTURO;PLANAS MONTSERRAT XAVIER. Datos registrales. T 46538 , F 91, S 8, H B26719, I/A 46 ( 4.08.21).

Nombramientos. AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 46538 , F 91, S 8, H B 26719, I/A 47 ( 4.08.21).

30 de Agosto de 2018
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 39629 , F 70, S 8, H B 26719, I/A 45 (23.08.18).

30 de Abril de 2018
Modificaciones estatutarias. ADICION DEL ARTICULO 10 BIS A LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 39629 , F 70,S 8, H B 26719, I/A 44 (18.04.18).

20 de Diciembre de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 39629 , F 70, S 8, H B 26719, I/A 43 (13.12.16).

21 de Octubre de 2016
Revocaciones. CONSEJERO: PRADES MARTINEZ ARTURO. PRESIDENTE: PRADES MARTINEZ ARTURO. CONS. DELEG.:PRADES MARTINEZ ARTURO. CONSEJERO: PLANAS MONTSERRAT XAVIER. SECRETARIO: PLANAS MONTSERRAT XAVIER.CONSEJERO: GONGORA ARANDA BERNARDO;PRADES MARTINEZ MARIO. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: PRADESMARTINEZ ARTURO;PLANAS MONTSERRAT XAVIER. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 6,8 Y10 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO. SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DEADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 39629 , F 69, S 8, H B 26719, I/A 41 (13.10.16).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 13.- TRANSMISION DE LAS ACCIONES. Datos registrales. T 39629 , F 69, S 8, H B26719, I/A 42 (13.10.16).

09 de Octubre de 2014
Nombramientos. APODERAD.SOL: PLANAS MONTSERRAT XAVIER. Datos registrales. T 39629 , F 68, S 8, H B 26719, I/A 39 (1.10.14).

Revocaciones. APODERADO: GONGORA ARANDA BERNARDO;PLANAS MONTSERRAT XAVIER. Datos registrales. T 39629 , F68, S 8, H B 26719, I/A 40 ( 1.10.14).

20 de Agosto de 2014
Revocaciones. CONSEJERO: PRADES FERRER JOSE VICTOR. PRESIDENTE: PRADES FERRER JOSE VICTOR. CONSEJERO:PRADES MARTINEZ ARTURO. CONS. DELEG.: PRADES MARTINEZ ARTURO. CONSEJERO: PRADES CAUSERA JUANJOSE;PRADES MARTINEZ MARIO. SECRETARIO: PRADES MARTINEZ MARIO. Nombramientos. CONSEJERO: PRADESMARTINEZ ARTURO. PRESIDENTE: PRADES MARTINEZ ARTURO. CONS. DELEG.: PRADES MARTINEZ ARTURO.CONSEJERO: PLANAS MONTSERRAT XAVIER. SECRETARIO: PLANAS MONTSERRAT XAVIER. CONSEJERO: GONGORAARANDA BERNARDO;PRADES MARTINEZ MARIO. Datos registrales. T 39629 , F 67, S 8, H B 26719, I/A 38 ( 8.08.14).

28 de Octubre de 2013
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SL. Modificaciones estatutarias. ART.3:CREACION DE PAGINA WEBCORPORATIVA: www.ravial.com. ART.7:CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de lap谩gina web corporativa: www.ravial.com. Datos registrales. T 39629 , F 66, S 8, H B 26719, I/A 36 (21.10.13).

Modificaciones estatutarias. ART.8: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales.T 39629 , F 67, S 8, H B 26719, I/A 37 (21.10.13).

01 de Febrero de 2013
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: COT GIL JOSE RAMON. Datos registrales. T 39629 , F 66, S 8, H B 26719, I/A 35 (24.01.13).

22 de Noviembre de 2012
Revocaciones. CONSEJERO: AISA GUILLEM ESTHER. SECRETARIO: AISA GUILLEM ESTHER. Nombramientos.CONSEJERO: PRADES MARTINEZ MARIO. SECRETARIO: PRADES MARTINEZ MARIO. Datos registrales. T 39629 , F 66, S 8, HB 26719, I/A 34 ( 9.11.12).

26 de Septiembre de 2012
Revocaciones. APODERADO: AISA GUILLEM ESTHER. Datos registrales. T 39629 , F 65, S 8, H B 26719, I/A 32 (17.09.12).

Nombramientos. APODERADO: PLANAS MONTSERRAT XAVIER. Datos registrales. T 39629 , F 65, S 8, H B 26719, I/A 33(17.09.12).

15 de Diciembre de 2009
Revocaciones. CONSEJERO: PRADES FERRER JOSE VICTOR. PRESIDENTE: PRADES FERRER JOSE VICTOR. CONSEJERO:PRADES MARTINEZ ARTURO;PRADES CAUSERA JUAN JOSE;AISA GUILLEM ESTHER. SECRETARIO: AISA GUILLEM ESTHER.CONS. DELEG.: PRADES MARTINEZ ARTURO. Nombramientos. CONSEJERO: PRADES FERRER JOSE VICTOR.PRESIDENTE: PRADES FERRER JOSE VICTOR. CONSEJERO: PRADES MARTINEZ ARTURO. CONS. DELEG.: PRADESMARTINEZ ARTURO. CONSEJERO: PRADES CAUSERA JUAN JOSE;AISA GUILLEM ESTHER. SECRETARIO: AISA GUILLEMESTHER. Datos registrales. T 39629 , F 64, S 8, H B 26719, I/A 31 ( 2.12.09).

13 de Abril de 2009
Revocaciones. APODERADO: PRADES MARTINEZ MARIO;AISA GUILLEM ESTHER. Nombramientos. APODERADO:GONGORA ARANDA BERNARDO;AISA GUILLEM ESTHER. DTOR.GENERAL: GONGORA ARANDA BERNARDO. Datosregistrales. T 39629 , F 61, S 8, H B 26719, I/A 30 (30.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n