Actos BORME de Real Club Celta De Vigo Sad
29 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Presidente: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS.Con.Delegado: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Miem.Com.Ej.: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Pres.Com.Ej.:MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Revocaciones. Apo.Man.Soli: VARGAS COLLAZO JULIO JOSE. Nombramientos.Consejero: MOURI脩O TERRAZO MARIA DE LOS ANGELES. Presidente: MOURI脩O TERRAZO MARIA DE LOS ANGELES. Datosregistrales. T 4372, L 4372, F 144, S 8, H PO 7073, I/A 74 (20.11.23).
16 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: GAINZARAIN GONZALEZ JOSE LUIS;CAO PEREZ CARLOS JOSE. Datos registrales. T 4372, L 4372,F 143, S 8, H PO 7073, I/A 73 ( 6.11.23).
05 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apoderado: MOURI脩O TERRAZO MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 4372, L 4372, F 142, S 8, HPO 7073, I/A 72 (28.08.23).
20 de Febrero de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: MOURI脩O TERRAZO MARIA DE LOS ANGELES;CHAVES ESCALANTE ANTONIO;HERBONPRADA MARIA JOSE;MAGDALENA SEOANE MARIA-CARMEN;GARCIA BAYON CARLOS HUGO;SALVADOR HERRERACARLOS;VARGAS COLLAZO JULIO JOSE. Datos registrales. T 4372, L 4372, F 141, S 8, H PO 7073, I/A 69 (10.02.23).
07 de Febrero de 2023Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 4372, L4372, F 141, S 8, H PO 7073, I/A 68 (27.01.23).
25 de Enero de 2022Reelecciones. Consejero: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS;POSADA MARTINEZ PEDRO;BARROS HERMIDARICARDO;FERRO RIBADULLA PRIMITIVO;AVENDA脩O OTERO MARIA DEL CARMEN. Presidente: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Con.Delegado: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Vicepresid.: BARROS HERMIDA RICARDO;POSADA MARTINEZPEDRO. Consejero: RODILLA MARTINEZ JOSE-FERNANDO;TABOAS CABRAL MARIA-JOSE. Sec.Com.Ej.: BARROS HERMIDARICARDO. Miem.Com.Ej.: POSADA MARTINEZ PEDRO;MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Pres.Com.Ej.: MOURI脩O ATANESMANUEL-CARLOS. Miem.Com.Ej.: BARROS HERMIDA RICARDO. Otros conceptos: Creaci贸n de un nuevo art铆culo 17潞 BIS de losEstatutos Sociales. Aprobaci贸n de las normas de funcionamiento de la Comisi贸n Ejecutiva. Datos registrales. T 4372, L 4372, F 140,S 8, H PO 7073, I/A 67 (14.01.22).
05 de Agosto de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: CHAVES ESCALANTE ANTONIO;HERBON PRADA MARIA JOSE;MAGDALENA SEOANE MARIA-CARMEN;MI脩AMBRES FERNANDEZ FELIPE;GARCIA BAYON CARLOS HUGO;SALVADOR HERRERA CARLOS;VARGASCOLLAZO JULIO JOSE. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 194, S 8, H PO 7073, I/A 66 (26.07.21).
08 de Septiembre de 2020Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 250/2008. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 17/08/2020. Auto de conclusi贸n delconcurso. Cumplimiento de convenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE PONTEVEDRA. Juez: JOSELUIS GUTIERREZ MARTIN. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 250/2008. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 17/08/2020.Cese de las limitaciones de las facultades de administraci贸n. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DEPONTEVEDRA. Juez: JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 193, S 8, H PO 7073, I/A 65 (2.09.20).
20 de Febrero de 2020Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 250/2008. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 20/01/2020. Auto de declaraci贸n decumplimiento de convenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE PONTEVEDRA. Juez: JOSE LUISGUTIERREZ MARTIN. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 193, S 8, H PO 7073, I/A A (12.02.20).
16 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: RODILLA MARTINEZ JOSE-FERNANDO;TABOAS CABRAL MARIA-JOSE. Nombramientos.Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Consejero: RODILLA MARTINEZ JOSE-FERNANDO;TABOAS CABRAL MARIA-JOSE.Reelecciones. Consejero: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS;POSADA MARTINEZ PEDRO;BARROS HERMIDARICARDO;FERRO RIBADULLA PRIMITIVO;AVENDA脩O OTERO MARIA DEL CARMEN. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP.Datos registrales. T 1659, L 1659, F 192, S 8, H PO 7073, I/A 63 ( 9.01.20).
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Nombramientos. Con.Delegado: MOURI脩O ATANESMANUEL-CARLOS. Reelecciones. Presidente: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Sec.Com.Ej.: BARROS HERMIDARICARDO. Miem.Com.Ej.: POSADA MARTINEZ PEDRO. Vicepresid.: BARROS HERMIDA RICARDO. Miem.Com.Ej.: MOURI脩OATANES MANUEL-CARLOS. Vicepresid.: POSADA MARTINEZ PEDRO. Pres.Com.Ej.: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS.Consejero: BARROS HERMIDA RICARDO. Miem.Com.Ej.: BARROS HERMIDA RICARDO. Otros conceptos: SE APRUEBAN LASNORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION EJECUTIVA. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 193, S 8, H PO 7073, I/A 64( 9.01.20).
03 de Diciembre de 2018Nombramientos. Consejero: RODILLA MARTINEZ JOSE-FERNANDO;TABOAS CABRAL MARIA-JOSE. Otros conceptos:FIJACION EN SIETE EL NUMERO DE LOS CONSEJEROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 1659, L1659, F 192, S 8, H PO 7073, I/A 62 (26.11.18).
24 de Julio de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: ROSENDO MARTINEZ ANTONIO. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 192, S 8, H PO 7073, I/A 61(12.07.18).
27 de Marzo de 2018Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE 44 (VIGO). Datos registrales. T 1659, L 1659, F 192, S 8, H PO 7073, I/A 60 (21.03.18).
10 de Enero de 2018Reelecciones. Consejero: AVENDA脩O OTERO MARIA DEL CARMEN;BARROS HERMIDA RICARDO;MOURI脩O ATANESMANUEL-CARLOS;ROSENDO MARTINEZ ANTONIO;POSADA MARTINEZ PEDRO;FERRO RIBADULLA PRIMITIVO. Datosregistrales. T 1659, L 1659, F 190, S 8, H PO 7073, I/A 58 ( 2.01.18).
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Miem.Com.Ej.: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Con.Delegado: MOURI脩OATANES MANUEL-CARLOS. Sec.Com.Ej.: BARROS HERMIDA RICARDO. Pres.Com.Ej.: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS.Miem.Com.Ej.: BARROS HERMIDA RICARDO;POSADA MARTINEZ PEDRO. Nombramientos. Con.Delegado: MOURI脩O ATANESMANUEL-CARLOS. Miem.Com.Ej.: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS;POSADA MARTINEZ PEDRO;BARROS HERMIDARICARDO. Pres.Com.Ej.: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Sec.Com.Ej.: BARROS HERMIDA RICARDO. Reelecciones.Presidente: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Vicepresid.: BARROS HERMIDA RICARDO;POSADA MARTINEZ PEDRO.Otros conceptos: Establecimiento de las normas que regir谩n el funcionamiento de la Comisi贸n Ejecutiva. P谩gina web de lasociedad. Modificaci贸n de la p谩gina web corporativa.Nueva p谩gina web: www.rccelta.es. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 191,S 8, H PO 7073, I/A 59 ( 2.01.18).
22 de Febrero de 2017Fe de erratas: En la inscripci贸n 35陋 de la sociedad REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD se nombr贸 como secretario no consejero aJavier Mosquera de Valdivieso cuando el nombre correcto es JAVIER MOSQUERA DE VALDIVIELSO. Datos registrales. T 1659, L1659, F 217, S 8, H PO 7073, I/A 35 (10.12.08).
18 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 190, S 8, H PO 7073, I/A 56 ( 9.01.17).
29 de Noviembre de 2016Otros conceptos: El auditor de cuentas es ahora AUREN AUDITORES SP, S.L.P. y como consecuencia de FUSION de fecha 1 deseptiembre de 2.015 elevada a p煤blico en escritura autorizada el 28 de abril de 2.016 n煤mero 2772 de protocolo, por notario de MadridDon Antonio-Luis Reina Guti茅rrez. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 190, S 8, H PO 7073, I/A 55 (22.11.16).
04 de Octubre de 2016Otros conceptos: En Acta autorizada el 12/09/2016 por el Notario de Vigo Don Julio-Manuel D铆az Losada, se identifica la firma delPresidente del Consejo, Don Manuel-Carlos Mouri帽o Atanes, que consta reproducida mec谩nicamente en el prototipo de los t铆tulosm煤ltiples nominativos representativos de las acciones. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 189, S 8, H PO 7073, I/A 54 (26.09.16).
27 de Abril de 2016Otros conceptos: En Acta autorizada el 4 de marzo de 2016 por el Notario de Vigo Don Miguel Lucas S谩nchez, se identifica la firmadel Presidente del Consejo, Don Manuel Carlos Mouri帽o Atanes, que consta reproducida mec谩nicamente en el prototipo de los t铆tulosm煤ltiples nominativos representativos de las acciones. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 189, S 8, H PO 7073, I/A 53 (21.04.16).
28 de Marzo de 2016Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 250/2008. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 30/06/2011. Sentencia de calificaci贸n delconcurso. Culpable. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: ROBERTO DE LA CRUZ ALVAREZ. Inhabilitados: Fecha17/09/2015. Tiempo: A帽os 2, meses 00, dias 00, NIF 36037632J. RODRIGUEZ MILLARES ALFREDO. Causas/Observaciones: PorSentencia 80/2011, de 30 de junio de 2011, que adquiri贸 firmeza el d铆a 17-09-2013, se condena al afectado por la calificaci贸n, DonAlfredo Rodr铆guez Millares, con D.N.I. 36.037.632-J, a la inhabilitaci贸n para administrar los bienes ajenos durante un per铆odo de DOSA脩OS, as铆 como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo per铆odo; y a la p茅rdida de cualquier derecho quetuviera como acreedor concursal o de la masa. 135542847G 17092015. 20000 2GOMEZ ARAUJO HORACIO. Por Sentencia 80/2011,de 30 de.junio de 2011, que adquiri贸 firmeza el d铆a 17-09-2013, se condena al afectado por la calificaci贸n, Don Horacio G贸mez Ara煤jo,
18 de Diciembre de 2015Reelecciones. Consejero: AVENDA脩O OTERO MARIA DEL CARMEN;BARROS HERMIDA RICARDO;MOURI脩O ATANESMANUEL-CARLOS;ROSENDO MARTINEZ ANTONIO;POSADA MARTINEZ PEDRO;FERRO RIBADULLA PRIMITIVO. Datosregistrales. T 1659, L 1659, F 188, S 8, H PO 7073, I/A 50 (10.12.15).
Reelecciones. Vicepresid.: POSADA MARTINEZ PEDRO. Con.Delegado: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Miem.Com.Ej.:MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS;POSADA MARTINEZ PEDRO;BARROS HERMIDA RICARDO. Pres.Com.Ej.: MOURI脩OATANES MANUEL-CARLOS. Vicepresid.: BARROS HERMIDA RICARDO. Presidente: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS.Sec.Com.Ej.: BARROS HERMIDA RICARDO. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 188, S 8, H PO 7073, I/A 51 (10.12.15).
30 de Marzo de 2015Otros conceptos: Acta de requerimiento de identidad de la firma mecanica con la que el se帽or Presidente, don Manuel CarlosMouri帽o Atanes, estampa en el t铆tulo que se emita en sustituci贸n del t铆tulo m煤ltiple nominativo n潞 30.123, representativo de las 3.332acciones, n煤meros 320.184 a 323.515, ambos inclusive. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 188, S 8, H PO 7073, I/A 49 (23.03.15).
15 de Enero de 2014Reelecciones. Con.Delegado: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Presidente: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS.Vicepresid.: BARROS HERMIDA RICARDO;POSADA MARTINEZ PEDRO. Miem.Com.Ej.: POSADA MARTINEZ PEDRO;MOURI脩OATANES MANUEL-CARLOS;BARROS HERMIDA RICARDO. Pres.Com.Ej.: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Sec.Com.Ej.:BARROS HERMIDA RICARDO. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 169, S 8, H PO 7073, I/A 48 ( 7.01.14).
14 de Enero de 2014Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: ACCOUNTIA AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: AURENAUDITORES VGO SL. Reelecciones. Consejero: AVENDA脩O OTERO MARIA DEL CARMEN;MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS;POSADA MARTINEZ PEDRO;FERRO RIBADULLA PRIMITIVO;ROSENDO MARTINEZ ANTONIO;BARROS HERMIDARICARDO. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 168, S 8, H PO 7073, I/A 47 ( 3.01.14).
05 de Febrero de 2013Otros conceptos: modificaci贸n del art铆culo 15 de los estatutos sociales relativo a la convocatoria de la Junta. P谩gina web de lasociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.celtavigo.net. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 168, S 8, H PO 7073, I/A46 (28.01.13).
16 de Enero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: LAGOS SUAREZ-LLANOS GABRIELA. Revocaciones. Con.Delegado: MOURI脩O ATANESMANUEL-CARLOS. Nombramientos. Con.Delegado: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Reelecciones. Consejero:MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS;BARROS HERMIDA RICARDO;POSADA MARTINEZ PEDRO;ROSENDO MARTINEZANTONIO;FERRO RIBADULLA PRIMITIVO;AVENDA脩O OTERO MARIA DEL CARMEN. Presidente: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Vicepresid.: BARROS HERMIDA RICARDO;POSADA MARTINEZ PEDRO. Miem.Com.Ej.: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Sec.Com.Ej.: BARROS HERMIDA RICARDO. Miem.Com.Ej.: POSADA MARTINEZ PEDRO;BARROS HERMIDA RICARDO.Pres.Com.Ej.: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Otros conceptos: Se acuerda la modificaci贸n de los art铆culos 5, 6, 10, 14,15, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 39 de los Estatutos Sociales y la derogaci贸n del art铆culo 26, as铆 como la refundici贸nde los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 165, S 8, H PO 7073, I/A 45 ( 3.01.12).
20 de Octubre de 2011Nombramientos. Miem.Com.Ej.: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Sec.Com.Ej.: BARROS HERMIDA RICARDO.Miem.Com.Ej.: POSADA MARTINEZ PEDRO;BARROS HERMIDA RICARDO. Pres.Com.Ej.: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS.Otros conceptos: REGLAMENTO DE LA COMISION EJECUTIVA: 1. La Comisi贸n Ejecutiva estar谩 integrada por un n煤mero de tren(3) Consejeros y designar谩 en su seno un Presidente, que ser谩 el Presidente del Consejo de Administraci贸n, y un Secretario. 2. LaComisi贸nEjecutiva se reunir谩 cuando la convoque su Presidente, se. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 164, S 8, H PO 7073, I/A44 ( 6.10.11).
19 de Septiembre de 2011Otros conceptos: Certificaci贸n haciendo constar la p谩gina www.celtavigo.net como p谩gina de la sociedad, la cual se utilizar谩 para darpublicidad a sus convocatorias de Juntas Generales de conformidad con el art铆culo 173 de la Ley de Sociedades de Capital. Datosregistrales. T 1659, L 1659, F 164, S 8, H PO 7073, I/A 43 ( 6.09.11).
24 de Agosto de 2011Reelecciones. Auditor: ACCOUNTIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 164, S 8, H PO 7073, I/A 42 (10.08.11).
23 de Abril de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 18.889.208,37 Euros. Resultante Suscrito: 3.770.210,00 Euros. Datos registrales. T 1659,L 1659, F 163, S 8, H PO 7073, I/A 41 (12.04.10).
29 de Diciembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 13.588.643,18 Euros. Resultante Suscrito: 22.659.418,37 Euros. Datos registrales. T 1659, L 1659,F 218, S 8, H PO 7073, I/A 40 (16.12.09).
09 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: FERRO RIBADULLA PRIMITIVO. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Presidente:MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Consejero: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS. Con.Delegado: MOURI脩O ATANESMANUEL-CARLOS. Consejero: BARROS HERMIDA RICARDO. Vicepresid.: BARROS HERMIDA RICARDO. Consejero: POSADAMARTINEZ PEDRO. Vicepresid.: POSADA MARTINEZ PEDRO. Consejero: LAGOS SUAREZ-LLANOS GABRIELA;AVENDA脩OOTERO MARIA DEL CARMEN;ROSENDO MARTINEZ ANTONIO. Nombramientos. Consejero: MOURI脩O ATANES MANUEL-CARLOS;BARROS HERMIDA RICARDO;POSADA MARTINEZ PEDRO;ROSENDO MARTINEZ ANTONIO;FERRO RIBADULLAPRIMITIVO;AVENDA脩O OTERO MARIA DEL CARMEN;LAGOS SUAREZ-LLANOS GABRIELA. Datos registrales. T 1659, L 1659, F217, S 8, H PO 7073, I/A 38 (27.11.09).
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ COBAS FRANCISCO XAVIER. Nombramientos. Presidente: MOURI脩O ATANESMANUEL-CARLOS. Vicepresid.: BARROS HERMIDA RICARDO;POSADA MARTINEZ PEDRO. Con.Delegado: MOURI脩O ATANES
29 de Octubre de 2009Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 250/2008. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 20/07/2009. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 250/2008. Fecha de resoluci贸n 4/07/2008. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 1JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN. Administrador Concursal. Fecha 20/07/2009, NIF/CIF36066272H. PEREZ-BOUZADA GONZALEZ CARLOS MANUEL. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 250/2008. Fecha deresoluci贸n 4/07/2008. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: JOSE LUISGUTIERREZ MARTIN. Administrador Concursal. Fecha 20/07/2009, NIF/CIF 34550143A. PRADA GAYOSO FRANCISCO. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 250/2008. Fecha de resoluci贸n 4/07/2008. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado:num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN. Administrador Concursal. Fecha 20/07/2009, NIF/CIFQ2826000H. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. Datos registrales. T 1659, L 1659, F 217, S 8, H PO 7073,I/A 37 (16.10.09).