Actos BORME de Real Racing Club De Santander Sad
29 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLA MILLER ALVARO;GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO-JOSE;PE脩A MAROTIASMONTSERRAT;SANCHEZ CASTILLO MARIA DE LOS ANGELES;PEREZ FERNANDEZ ALFREDO;CRIADO LAVIN JOSEEMILIO;ORTIZ ORTIZ PEDRO JOAQUIN. Presidente: PEREZ FERNANDEZ ALFREDO. Cons.Del.Sol: PEREZ FERNANDEZALFREDO. Vicepresid.: ORTIZ ORTIZ PEDRO JOAQUIN. Cons.Del.Sol: ORTIZ ORTIZ PEDRO JOAQUIN. Consejero: GONZALEZPESCADOR DAVID;GOMEZ ARROYO MANUEL. Secretario: GONZALEZ PESCADOR DAVID. Nombramientos. Consejero:HIGUERA SANCHO MANUEL;URIEL TORRE JUAN JOSE;LOPEZ-TAFALL BASCU脩ANA ALEJANDRO;CERIA BLANCOSEBASTIAN. Presidente: HIGUERA SANCHO MANUEL. Vicepresid.: URIEL TORRE JUAN JOSE. Secretario: LOPEZ-TAFALLBASCU脩ANA ALEJANDRO. Con.Delegado: HIGUERA SANCHO MANUEL. Consejero: ROYANO GUTIERREZ FRANCISCO;PE脩AMACARRO MIRIAM;CANO FERNANDEZ JAIME;BERASATEGUI DIEZ DANIEL;FERNANDEZ COBO EVA MARIA. Datos registrales.T 1195 , F 104, S 8, H S 2401, I/A 137 (21.09.23).
16 de Marzo de 2023Reelecciones. Auditor: SOCIEDAD GENERAL DE AUDITORIA NORTE SOCIEDAD LIMIT. Datos registrales. T 1195 , F 104, S 8, HS 2401, I/A 134 ( 2.03.23).
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012/2013 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 1195 , F 104, S 8, H S 2401, I/A 135 ( 2.03.23).
Reelecciones. Auditor: SOCIEDAD GENERAL DE AUDITORIA NORTE SOCIEDAD LIMIT. Datos registrales. T 1195 , F 104, S 8, HS 2401, I/A 136 ( 2.03.23).
07 de Enero de 2022Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012/2013 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 1195 , F 104, S 8, H S 2401, I/A 133 (27.12.21).
03 de Diciembre de 2021Otros conceptos: La sentencia de aprobaci贸n judicial de la modificaci贸n de convenio de fecha 23 de junio de 2021 ha cobradofirmeza el d铆a 27 de octubre de 2021.- Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 279/2011. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n23/06/2021. Sentencia de aprobaci贸n del convenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE SANTANDER.Juez: CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ. Datos registrales. T 1195 , F 104, S 8, H S 2401, I/A 132 (25.11.21).
30 de Julio de 2021Otros conceptos: Se aprueba judicialmente la modificaci贸n del convenio aprobado por sentencia de 29/06/12 y modificado porsentencia de 4/12/15, de conformidad con la propuesta de Modificaci贸n del Convenio presentada en fecha 28 de diciembre de 2020,con las modificaciones presentadas en su escrito de fecha 22/02/21. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 279/2011.FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 23/06/2021. Sentencia de aprobaci贸n del convenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 1 DE SANTANDER. Juez: CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ. Datos registrales. T 1195 , F 103, S 8, HS 2401, I/A F (21.07.21).
25 de Febrero de 2021Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012/2013 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 1195 , F 102, S 8, H S 2401, I/A 130 (10.02.21).
19 de Febrero de 2021Reelecciones. Consejero: GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO-JOSE;CRIADO LAVIN JOSE EMILIO;PEREZ FERNANDEZALFREDO;ORTIZ ORTIZ PEDRO JOAQUIN. Presidente: PEREZ FERNANDEZ ALFREDO. Vicepresid.: ORTIZ ORTIZ PEDROJOAQUIN. Consejero: GOMEZ ARROYO MANUEL;VILLA MILLER ALVARO;PE脩A MAROTIAS MONTSERRAT. Secretario:GONZALEZ PESCADOR DAVID. Cons.Del.Sol: ORTIZ ORTIZ PEDRO JOAQUIN. Consejero: SANCHEZ CASTILLO MARIA DE LOSANGELES;GONZALEZ PESCADOR DAVID. Cons.Del.Sol: PEREZ FERNANDEZ ALFREDO. Otros conceptos: Se modifica elart铆culo 16, el art铆culo 17 -relativos a la asistencia y a las reuniones a las Juntas- los art铆culos 22 y 23 -relativos al Consejo deAdministraci贸n- se suprime el art铆culo 26 y se modifica el art. 31 a efectos de eliminar la figura del Defensor del Abonado.- Datosregistrales. T 1195 , F 102, S 8, H S 2401, I/A 131 (12.02.21).
10 de Marzo de 2020Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.000.000,00 Euros. Desembolsado: 2.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.917.720,00 Euros.Resultante Desembolsado: 5.917.720,00 Euros. Datos registrales. T 1195 , F 101, S 8, H S 2401, I/A 129 ( 2.03.20).
04 de Febrero de 2020Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012/2013 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 1195 , F 101, S 8, H S 2401, I/A 128 (23.01.20).
27 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: URIEL TORRE JUAN JOSE. Apo.Manc.: HIGUERA SANCHO MANUEL;URIEL TORRE JUAN JOSE;ORTIZORTIZ PEDRO JOAQUIN. Apoderado: ORTIZ ORTIZ PEDRO JOAQUIN. Nombramientos. Cons.Del.Sol: ORTIZ ORTIZ PEDROJOAQUIN. Datos registrales. T 1195 , F 101, S 8, H S 2401, I/A 127 (19.12.19).
01 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: DIEGO CARRERA RUBEN. SecreNoConsj: GONZALEZ PESCADOR DAVID. Nombramientos.Consejero: GONZALEZ PESCADOR DAVID. Secretario: GONZALEZ PESCADOR DAVID. Datos registrales. T 1195 , F 100, S 8, HS 2401, I/A 126 (23.09.19).
13 de Agosto de 2019Nombramientos. Auditor: SOCIEDAD GENERAL DE AUDITORIA NORTE SOCIEDAD LIMIT. Modificaciones estatutarias. 29. Semodifica el art. 29 de los Estatutos Sociales de forma que el consejo pueda delegar sus facultades de representaci贸n en m谩s de unconsejero delegado.-. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.realracingclub.es. Datosregistrales. T 1195 , F 99, S 8, H S 2401, I/A 124 ( 5.08.19).
Ceses/Dimisiones. Consejero: PALACIO RUIZ CRISTOBAL. Secretario: PALACIO RUIZ CRISTOBAL. Nombramientos. Consejero:SANCHEZ CASTILLO MARIA DE LOS ANGELES. SecreNoConsj: GONZALEZ PESCADOR DAVID. Datos registrales. T 1195 , F100, S 8, H S 2401, I/A 125 ( 5.08.19).
18 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: ORTIZ ORTIZ PEDRO JOAQUIN. Datos registrales. T 894 , F 15, S 8, H S 2401, I/A 123 (10.12.18).
07 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: LOPEZ TAFALL BASCU脩ANA ALEJANDRO. Nombramientos. Secretario: PALACIO RUIZCRISTOBAL. Consejero: GOMEZ ARROYO MANUEL. Datos registrales. T 894 , F 14, S 8, H S 2401, I/A 121 (28.11.18).
Ceses/Dimisiones. Consejero: BERASATEGUI DIEZ DANIEL;HIGUERA SANCHO MANUEL. Presidente: HIGUERA SANCHOMANUEL. Consejero: URIEL TORRE JUAN JOSE;PE脩A MACARRO MIRIAM;DIEGO ALVARADO VICTOR-MANUEL. Vicepresid.:DIEGO ALVARADO VICTOR-MANUEL. Nombramientos. Presidente: PEREZ FERNANDEZ ALFREDO. Consejero: VILLA MILLERALVARO. Vicepresid.: ORTIZ ORTIZ PEDRO JOAQUIN. Con.Delegado: PEREZ FERNANDEZ ALFREDO. Consejero: PE脩AMAROTIAS MONTSERRAT;DIEGO CARRERA RUBEN. Datos registrales. T 894 , F 15, S 8, H S 2401, I/A 122 (28.11.18).
12 de Febrero de 2018Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 894 , F 14, S 8, H S 2401, I/A 120 (29.01.18).
06 de Febrero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: INMOARRABI PROMOCIONES DOS SL. Datos registrales. T 894 , F 14, S 8, H S 2401, I/A 119(29.01.18).
13 de Julio de 2017Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 279/2011. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 26/02/2016. Sentencia de calificaci贸n delconcurso. Fortuito. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTANDER. Juez: CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTAMENENDEZ. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 279/2011. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 14/10/2016. Sentencia decalificaci贸n del concurso. Culpable. Juzgado: num. 4 AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA. Juez: MARIA DEL MARHERNANDEZ RODRIGUEZ. Resoluciones: En recurso de apelaci贸n, rollo de la Sala 258/2016, Se inhabilita a WESTERN GULFADVISORY SPORTS HOLDING BV para administrar los bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier persona durante elper铆odo de cinco a帽os. Fecha de inhabilitaci贸n: 14/10/2016.- Inhabilitados: Fecha 14/10/2021. Tiempo: A帽os 5, meses 00, dias 00, NIFY1732586X. SYED ASHAN ALI. Causas/Observaciones: Se le inhabilita para administrar los bienes ajenos y para representar oadministrar a cualquier persona durante el per铆odo de cinco a帽os. Datos registrales. T 894 , F 14, S 8, H S 2401, I/A 118 ( 5.07.17).
15 de Junio de 2017Nombramientos. Consejero: GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE;CRIADO LAVIN JOSE EMILIO. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 1.200.000,00 Euros. Desembolsado: 1.200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.917.720,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 3.917.720,00 Euros. Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion decuentas del ejercicio 2012 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 894 , F 12, S 8, H S 2401, I/A 116( 6.06.17).
Revocaciones. Apo.Manc.: ANTONIO FARI脩A VARELA. Nombramientos. Apo.Manc.: ORTIZ ORTIZ PEDRO. Datos registrales.T 894 , F 13, S 8, H S 2401, I/A 117 ( 6.06.17).
Ceses/Dimisiones. Consejero: OSET ALONSO JUAN ALBERTO;FERNANDEZ YLLAN RAUL;ANTONIO FARI脩A VARELA.Nombramientos. Consejero: PEREZ FERNANDEZ ALFREDO;PALACIO RUIZ CRISTOBAL;ORTIZ ORTIZ PEDRO. Datosregistrales. T 894 , F 13, S 8, H S 2401, I/A 116 ( 6.06.17).
27 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA PASCUAL AGUSTIN. Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA PASCUAL AGUSTIN.Nombramientos. Consejero: OSET ALONSO JUAN ALBERTO. Apo.Manc.: ANTONIO FARI脩A VARELA. Auditor: SOCIEDADGENERAL DE AUDITORIA NORTE SOCIEDAD LIMIT. Datos registrales. T 894 , F 12, S 8, H S 2401, I/A 115 (18.07.16).
22 de Junio de 2016Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 894 , F 12, S 8, H S 2401, I/A 114 (14.06.16).
06 de Abril de 2016Otros conceptos: El auto de fecha 30 de julio de 2012 que acord贸 el cese de los administradores concursales ha cobrado firmeza eld铆a 2 de octubre de 2012.- Datos registrales. T 894 , F 12, S 8, H S 2401, I/A 112 (30.03.16).
Otros conceptos: La sentencia de fecha 4 de diciembre de 2015 que aprob贸 judicialmente la modificaci贸n del convenio -aprobadomediante sentencia de 29 de junio de 2012- ha cobrado firmeza el d铆a 15 de enero de 2016.- Situaci贸n concursal. Procedimientoconcursal 279/2011. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 4/12/2015. Sentencia de aprobaci贸n del convenio. Juzgado: num. 1 JUZGADODE LO MERCANTIL DE SANTANDER. Juez: CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ. Datos registrales. T 894 , F 12, S8, H S 2401, I/A 113 (30.03.16).
28 de Enero de 2016Otros conceptos: Se aprueba judicialmente la modificaci贸n del convenio aprobado mediante Sentencia del Juzgado de lo Mercantilde 29 de junio de 2012.- Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 279/2011. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 4/12/2015.Sentencia de aprobaci贸n del convenio. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTANDER. Juez: MARIA DEL MARHERNANDEZ RODRIGUEZ. Datos registrales. T 894 , F 11, S 8, H S 2401, I/A E (21.01.16).
03 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ PESCADOR DAVID;URIEL TORRE JUAN JOSE;SA脩UDO HERRERO JUANANTONIO;DIEGO ALVARADO VICTOR-MANUEL;HIGUERA SANCHO MANUEL;BERASATEGUI DIEZ DANIEL. Secretario:GONZALEZ PESCADOR DAVID. Presidente: SA脩UDO HERRERO JUAN ANTONIO. Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZPESCADOR DAVID;SA脩UDO HERRERO JUAN ANTONIO. Nombramientos. Consejero: HIGUERA SANCHO MANUEL. Presidente:HIGUERA SANCHO MANUEL. Consejero: DIEGO ALVARADO VICTOR-MANUEL. Vicepresid.: DIEGO ALVARADO VICTOR-MANUEL. Consejero: BERASATEGUI DIEZ DANIEL;URIEL TORRE JUAN JOSE;ANTONIO FARI脩A VARELA;GARCIA PASCUALAGUSTIN;PE脩A MACARRO MIRIAM;INMOARRABI PROMOCIONES DOS SL;FERNANDEZ YLLAN RAUL. SecreNoConsj: LOPEZTAFALL BASCU脩ANA ALEJANDRO. Apo.Manc.: HIGUERA SANCHO MANUEL;URIEL TORRE JUAN JOSE;GARCIA PASCUALAGUSTIN. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 621.170,00 Euros. Desembolsado: 621.170,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.717.720,00Euros. Resultante Desembolsado: 2.717.720,00 Euros. Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de noaprobacion de cuentas del ejercicio 2013 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 894 , F 10, S 8, HS 2401, I/A 111 (19.10.15).
27 de Octubre de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.809.177,79 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:2.096.550,00 Euros. Desembolsado: 2.096.550,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.096.550,00 Euros. Resultante Desembolsado:2.096.550,00 Euros. Datos registrales. T 829 , F 75, S 8, H S 2401, I/A 110 (19.10.15).
Modificaciones estatutarias. 21. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 829 , F 75, S 8, H S 2401, I/A 109(19.10.15).
07 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: DIEZ DE VELASCO MARTINEZ ENRIQUE;CASTRO COBO LUIS;PERAL GARCIA FERNANDO.Revocaciones. Apo.Sol.: TRAPAGA SANCHEZ SERAFIN;DIEZ DE VELASCO MARTINEZ ENRIQUE;CASTRO COBO LUIS;PERALGARCIA FERNANDO. Nombramientos. Consejero: DIEGO ALVARADO VICTOR-MANUEL;BERASATEGUI DIEZ DANIEL. Datosregistrales. T 829 , F 74, S 8, H S 2401, I/A 108 (30.06.15).
26 de Junio de 2015Modificaciones estatutarias. 16. Asistencia a las juntas. Derecho de informaci贸n.-. 31. El abonado racinguista.-. Datos registrales.T 829 , F 74, S 8, H S 2401, I/A 105 (18.06.15).
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 829 , F 74, S 8, H S 2401, I/A 106 (18.06.15).
Nombramientos. Consejero: HIGUERA SANCHO MANUEL. Datos registrales. T 829 , F 74, S 8, H S 2401, I/A 107 (18.06.15).
09 de Abril de 2015Reelecciones. Auditor: OLSZEWSKI AUDITORES SL. Datos registrales. T 829 , F 73, S 8, H S 2401, I/A 103 (25.03.15).
Ceses/Dimisiones. Consejero: TRAPAGA SANCHEZ SERAFIN. Revocaciones. Apo.Manc.: HUERTA CASTILLOMANUEL;FERNANDEZ ORTIZ JOSE RAMON;DIAZ DIAZ MIGUEL ANGEL;BOLADO CUESTA CARLOS;DIAZ DIAZFERNANDO;REDA MORENO JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 829 , F 73, S 8, H S 2401, I/A 104 (25.03.15).
06 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: SA脩UDO HERRERO JUAN ANTONIO;TRAPAGA SANCHEZ SERAFIN;DIEZ DE VELASCO MARTINEZENRIQUE;CASTRO COBO LUIS;PERAL GARCIA FERNANDO;GONZALEZ PESCADOR DAVID;URIEL TORRE JUAN JOSE. Datosregistrales. T 829 , F 73, S 8, H S 2401, I/A 102 (26.02.15).
03 de Diciembre de 2014Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 829 , F 72, S 8, H S 2401, I/A 97 (26.11.14).
Nombramientos. Auditor: OLSZEWSKI AUDITORES SL. Datos registrales. T 829 , F 72, S 8, H S 2401, I/A 98 (26.11.14).
Nombramientos. Auditor: OLSZEWSKI AUDITORES SL. Datos registrales. T 829 , F 72, S 8, H S 2401, I/A 99 (26.11.14).
Nombramientos. Consejero: SA脩UDO HERRERO JUAN ANTONIO. Presidente: SA脩UDO HERRERO JUAN ANTONIO. Consejero:GONZALEZ PESCADOR DAVID. Secretario: GONZALEZ PESCADOR DAVID. Consejero: DIEZ DE VELASCO MARTINEZENRIQUE;PERAL GARCIA FERNANDO;URIEL TORRE JUAN JOSE;CASTRO COBO LUIS;TRAPAGA SANCHEZ SERAFIN. Datosregistrales. T 829 , F 72, S 8, H S 2401, I/A 100 (26.11.14).
Reelecciones. Auditor: OLSZEWSKI AUDITORES SL. Datos registrales. T 829 , F 73, S 8, H S 2401, I/A 101 (26.11.14).
07 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ QUIROGA TORRES ALVARO. Datos registrales. T 829 , F 71, S 8, H S 2401, I/A 95(31.07.14).
Ceses/Dimisiones. Consejero: LAVIN IGLESIAS ANGEL;CAMPOS GARCIA JOSE ANTONIO;SYED ASHAN ALI;HORST WILHELMWEBER;MIRZA SHAHEREYAR ALI BAIG;ALDAILMI HUSAIN AHMED MOHAMED. Presidente: LAVIN IGLESIAS ANGEL.Con.Delegado: LAVIN IGLESIAS ANGEL. SecreNoConsj: BERDEJO VIDAL JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 829 , F 71, S 8, HS 2401, I/A 96 (31.07.14).
03 de Julio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: SAIZ BALBAS MANUEL. Datos registrales. T 829 , F 71, S 8, H S 2401, I/A 94 (27.06.13).
24 de Mayo de 2013Modificaciones estatutarias. 15. Convocatoria junta general..21. Administraci贸n y Representacion.-.23. Administraci贸n yRepresentacion.-. Datos registrales. T 829 , F 71, S 8, H S 2401, I/A 93 (14.05.13).
01 de Marzo de 2013Nombramientos. Presidente: LAVIN IGLESIAS ANGEL. Con.Delegado: LAVIN IGLESIAS ANGEL. Consejero: RODRIGUEZQUIROGA TORRES ALVARO. SecreNoConsj: BERDEJO VIDAL JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 829 , F 71, S 8, H S 2401, I/A92 (21.02.13).
20 de Noviembre de 2012Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 279/2011. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 14/09/2012. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTANDER. Juez: MARIA DEL MAR HERNANDEZ RODRIGUEZ.Datos registrales. T 829 , F 70, S 8, H S 2401, I/A 91 ( 6.11.12).
16 de Octubre de 2012Nombramientos. Consejero: MIRZA SHAHEREYAR ALI BAIG;ALDAILMI HUSAIN AHMED MOHAMED. Datos registrales. T 829 , F70, S 8, H S 2401, I/A 90 ( 4.10.12).
19 de Septiembre de 2012Nombramientos. Consejero: SYED ASHAN ALI;HORST WILHELM WEBER. Datos registrales. T 829 , F 70, S 8, H S 2401, I/A 89(10.09.12).
22 de Agosto de 2012Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 279/2011. Fecha de resoluci贸n 8/07/2011. Revocaci贸n de administradoresconcursales. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTANDER. Juez: MARIA DEL MAR HERNANDEZ RODRIGUEZ.Administrador Concursal. Fecha 30/07/2012, NIF/CIF 13092736D. RUIZ ASENJO SANTIAGO. Situaci贸n concursal. Procedimientoconcursal 279/2011. Fecha de resoluci贸n 8/07/2011. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LOMERCANTIL DE SANTANDER. Juez: MARIA DEL MAR HERNANDEZ RODRIGUEZ. Administrador Concursal. Fecha 30/07/2012,NIF/CIF 00000000. ALVARGONZALEZ TREMOLS ALEJANDRO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 279/2011. Fecha deresoluci贸n 8/07/2011. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DESANTANDER. Juez: MARIA DEL MAR HERNANDEZ RODRIGUEZ. Administrador Concursal. Fecha 30/07/2012, NIF/CIFQ28260000H. AGENCIA ESTATAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA. Datos registrales. T 829 , F 70, S 8, H S 2401, I/A D(10.08.12).
09 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: GOROSTEGUI CEBALLOS ANTONIO. Nombramientos. Consejero: LAVIN IGLESIASANGEL;CAMPOS GARCIA JOSE ANTONIO;SAIZ BALBAS MANUEL;GOROSTEGUI CEBALLOS ANTONIO. Datos registrales. T829 , F 70, S 8, H S 2401, I/A 88 (31.07.12).
27 de Julio de 2012Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 279/2011. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 29/06/2012. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTANDER. Juez: MARIA DEL MAR HERNANDEZ RODRIGUEZ.Datos registrales. T 829 , F 69, S 8, H S 2401, I/A C (16.07.12).
10 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: PERNIA CALVO JOSE-FRANCISCO. Presidente: PERNIA CALVO JOSE-FRANCISCO. Cons.Del.Sol:PERNIA CALVO JOSE-FRANCISCO. Consejero: PERNIA CALVO JOSE-FRANCISCO;BEDOYA ARROYO ROBERTO. Secretario:BEDOYA ARROYO ROBERTO. Consejero: GILARRANZ MARTIN SANTIAGO;RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ALBERTO;VELADOCASAR CARLOS;VELADO CASAR CARLOS;GONZALEZ IGLESIAS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 829 , F 69, S 8, H S2401, I/A 87 (30.06.12).
29 de Mayo de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.706.457,09 Euros. Resultante Suscrito: 9.542,71 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 1.799.635,08 Euros. Desembolsado: 1.799.635,08 Euros. Resultante Suscrito: 1.809.177,79 Euros. ResultanteDesembolsado: 1.809.177,79 Euros. Datos registrales. T 829 , F 68, S 8, H S 2401, I/A 86 (16.05.12).
23 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: DUMVIRO VENTURES SL. Cons.Del.Sol: DUMVIRO VENTURES SL. Datos registrales. T 829 , F67, S 8, H S 2401, I/A 85 (10.05.12).
28 de Febrero de 2012Otros conceptos: Aceptaci贸n del cargo de del acreedor nombrado administradorconcursal, la AEAT, designando este 煤ltima a DonRam贸n Camarena Garcia como su representante pesona f铆sica.Aceptaci贸n del cargo del administrador concursal Don Santiago RuizAsenjo. Datos registrales. T 829 , F 67, S 8, H S 2401, I/A 84 (16.02.12).
19 de Enero de 2012Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 279/2011. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 22/12/2011. Resoluciones acordando laintervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LOMERCANTIL DE SANTANDER. Juez: MARIA DEL MAR HERNANDEZ RODRIGUEZ. Datos registrales. T 829 , F 67, S 8, H S 2401,I/A B ( 9.01.12).
04 de Octubre de 2011Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 279/2011. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 8/07/2011. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTANDER. Juez: MARIA DEL MAR HERNANDEZRODRIGUEZ. Datos registrales. T 829 , F 67, S 8, H S 2401, I/A 83 (23.09.11).
26 de Julio de 2011Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 279/2011. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 8/07/2011. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTANDER. Juez: MARIA DEL MAR HERNANDEZRODRIGUEZ. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 279/2011. Fecha de resoluci贸n 8/07/2011. Nombramiento deadministradores. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTANDER. Juez: MARIA DEL MAR HERNANDEZRODRIGUEZ. Administrador Concursal. Fecha 8/07/2011, NIF/CIF 00000000. ALVARGONZALEZ TREMOLS ALEJANDRO.Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 279/2011. Fecha de resoluci贸n 8/07/2011. Nombramiento de administradores.Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SANTANDER. Juez: MARIA DEL MAR HERNANDEZ RODRIGUEZ.Administrador Concursal. Fecha 8/07/2011, NIF/CIF 13092736D. RUIZ ASENJO SANTIAGO. Situaci贸n concursal. Procedimientoconcursal 279/2011. Fecha de resoluci贸n 8/07/2011. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LOMERCANTIL DE SANTANDER. Juez: MARIA DEL MAR HERNANDEZ RODRIGUEZ. Administrador Concursal. Fecha 8/07/2011,NIF/CIF Q28260000H. AGENCIA ESTATAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA. Datos registrales. T 829 , F 66, S 8, H S 2401, I/A A(13.07.11).
03 de Marzo de 2011Reelecciones. Auditor: OLSZEWSKI AUDITORES SL. Datos registrales. T 829 , F 66, S 8, H S 2401, I/A 82 (21.02.11).
27 de Diciembre de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.101.081,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.715.999,80 Euros. Datos registrales. T 829 , F66, S 8, H S 2401, I/A 81 (14.12.10).
10 de Marzo de 2010Reelecciones. Auditor: OLSZEWSKI AUDITORES SL. Datos registrales. T 829 , F 65, S 8, H S 2401, I/A 80 ( 1.03.10).
23 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: BELLIDO AMOROS ALVARO. Nombramientos. Consejero: VELADO CASAR CARLOS. Datosregistrales. T 829 , F 65, S 8, H S 2401, I/A 77 ( 9.06.09).
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPOS GARCIA JOSE ANTONIO;SERRANO MINCHAN JOSE. Nombramientos. Consejero:VELADO CASAR CARLOS;RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ALBERTO;GONZALEZ IGLESIAS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T829 , F 65, S 8, H S 2401, I/A 78 ( 9.06.09).
Reelecciones. Auditor: OLSZEWSKI AUDITORES SL. Datos registrales. T 829 , F 65, S 8, H S 2401, I/A 79 ( 9.06.09).