Buscador CIF Logo

Actos BORME Real Sitio De Ventosilla Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Real Sitio De Ventosilla Sa

Actos BORME Real Sitio De Ventosilla Sa - A80626252

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Real Sitio De Ventosilla Sa con CIF A80626252

馃敊 Perfil de Real Sitio De Ventosilla Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Real Sitio De Ventosilla Sa

18 de Abril de 2023
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 3.795.250,00 Euros. Desembolsado: 3.795.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.220.250,00 Euros.Resultante Desembolsado: 4.220.250,00 Euros. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 5潞 Y 6潞 DELOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 27321 , F 205, S 8, H M 111887, I/A 39 (11.04.23).

04 de Noviembre de 2022
Reelecciones. Auditor: STARK AUDIT SLP. Datos registrales. T 27321 , F 204, S 8, H M 111887, I/A 38 (27.10.22).

18 de Febrero de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: GRAVELINAS RENOVABLES SL;MONDUBER SA;BARCILES FORRAJES SL. Presidente:GRAVELINAS RENOVABLES SL. Representan: CREMADES CARCELLER CARLOS;CREMADES DE ADARO JAVIER;CREMADESCARCELLER MARIA DE LOS ANGELES. Nombramientos. Representan: CREMADES CARCELLER CARLOS;CREMADESCARCELLER MARIA DE LOS ANGELES;GONZALEZ BERRUEZO JOSE. Consejero: RUSTICAS SA;MONDUBER SA;GRAVELINASRENOVABLES SL. Presidente: RUSTICAS SA. SecreNoConsj: LOPEZ GONZALEZ CRISTINA. Datos registrales. T 27321 , F 202, S8, H M 111887, I/A 37 (11.02.22).

22 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ DE RIVERA CREMADES FERNANDO MARIA;CREMADES CARCELLERCARLOS;CREMADES CARCELLER MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 27321 , F 201, S 8, H M 111887, I/A 36(15.02.21).

20 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: CREMADES DE ADARO FRANCISCO JAVIER;CREMADES CARCELLER CARLOS. Presidente:CREMADES DE ADARO FRANCISCO JAVIER. Consejero: CARCELLER COLL MARIA. Vicepresid.: CARCELLER COLL MARIA.Consejero: CREMADES CARCELLER MARIA DE LOS ANGELES;CREMADES CARCELLER MARIA JOSE. Cons.Del.Man:CREMADES DE ADARO FRANCISCO JAVIER;CARCELLER COLL MARIA;CREMADES CARCELLER MARIA DE LOSANGELES;CREMADES CARCELLER MARIA JOSE;CREMADES CARCELLER CARLOS. Nombramientos. Consejero:GRAVELINAS RENOVABLES SL;MONDUBER SA;BARCILES FORRAJES SL. Presidente: GRAVELINAS RENOVABLES SL.Representan: CREMADES DE ADARO JAVIER;CREMADES CARCELLER CARLOS;CREMADES CARCELLER MARIA DE LOSANGELES. Datos registrales. T 27321 , F 200, S 8, H M 111887, I/A 35 (13.12.19).

05 de Julio de 2019
Nombramientos. Auditor: STARK AUDIT SLP. Datos registrales. T 27321 , F 200, S 8, H M 111887, I/A 34 (28.06.19).

28 de Julio de 2017
Cambio de domicilio social. C/ ANTONIO MAURA 16 (MADRID). Datos registrales. T 27321 , F 120, S 8, H M 111887, I/A 33(20.07.17).

16 de Enero de 2017
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 425.000,00 Euros. Desembolsado: 425.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 425.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 425.000,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 7.352.700,00 Euros. Resultante Suscrito:0,00 Euros. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 5 Y 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datosregistrales. T 27321 , F 117, S 8, H M 111887, I/A 32 ( 9.01.17).

24 de Agosto de 2016
Ceses/Dimisiones. Secretario: MONEREO VELASCO ANDRES. Nombramientos. SecreNoConsj: LOPEZ GONZALEZ CRISTINA.Datos registrales. T 27321 , F 117, S 8, H M 111887, I/A 31 (17.08.16).

12 de Abril de 2016
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EL NUMERO DE INSCRIPCION DE FECHA 2/12/2015, SIENDO EL CORRECTO ELNUMERO 29. Datos registrales. T 27321 , F 116, S 8, H M 111887, I/A 29 ( 2.12.15).

Reelecciones. Auditor: AUDITSEGAR SLP. Datos registrales. T 27321 , F 117, S 8, H M 111887, I/A 30 ( 5.04.16).

10 de Diciembre de 2015
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 5.152.700,00 Euros. Desembolsado: 5.152.700,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.352.700,00 Euros.Resultante Desembolsado: 7.352.700,00 Euros. Datos registrales. T 27321 , F 116, S 8, H M 111887, I/A 28 ( 2.12.15).

24 de Julio de 2015
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ DE RIVERA CREMADES FERNANDO MARIA. Datos registrales. T 27321 , F 114, S 8,H M 111887, I/A 28 (16.07.15).

01 de Julio de 2015
Revocaciones. Apo.Manc.: RODRIGUEZ DE RIVERA CREMADES FERNANDO MARIA;RIOS APARICIO MARIA DEL CARMEN.Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ DE RIVERA CREMADES FERNANDO MARIA;CREMADES CANCELLER MARIA DELOS ANGELES;CREMADES CARCELLER MARIA JOSE;CARCELLER COLL MARIA;CREMADES CARCELLERCARLOS;CREMADES DE ADARO JAVIER. Datos registrales. T 27321 , F 113, S 8, H M 111887, I/A 27 (24.06.15).

22 de Octubre de 2014
Reelecciones. Secretario: MONEREO VELASCO ANDRES. Consejero: CREMADES DE ADARO FRANCISCO JAVIER;CREMADESCARCELLER CARLOS. Presidente: CREMADES DE ADARO FRANCISCO JAVIER. Consejero: CARCELLER COLL MARIA.Vicepresid.: CARCELLER COLL MARIA. Consejero: CREMADES CARCELLER MARIA DE LOS ANGELES;CREMADES CARCELLERMARIA JOSE. Cons.Del.Man: CREMADES DE ADARO FRANCISCO JAVIER;CARCELLER COLL MARIA;CREMADES CARCELLERMARIA DE LOS ANGELES;CREMADES CARCELLER MARIA JOSE;CREMADES CARCELLER CARLOS. Datos registrales. T27321 , F 113, S 8, H M 111887, I/A 26 (14.10.14).

15 de Marzo de 2013
Nombramientos. Auditor: AUDITSEGAR SL. Datos registrales. T 27321 , F 113, S 8, H M 111887, I/A 25 ( 6.03.13).

14 de Marzo de 2012
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ SOBRINO JESUS MARIA;RODRIGUEZ DE RIVERA CREMADES FERNANDO MARIA.Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUEZ DE RIVERA CREMADES FERNANDO MARIA;RIOS APARICIO MARIA DEL CARMEN.Datos registrales. T 27321 , F 112, S 8, H M 111887, I/A 24 ( 5.03.12).

05 de Marzo de 2012
Reelecciones. Auditor: COMPTO AUDITORES SL. Datos registrales. T 27321 , F 112, S 8, H M 111887, I/A 23 (22.02.12).

16 de Febrero de 2011
Otros conceptos: RECTIFICACION DEL APODERAMIENTO CONFERIDO EN LA ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION20&, EN CUANTO AL NOMBRE DE UNO DE LOS NOMBRADOS, SIENDO EL CORRECTO "TOMAS LAGUNA GOMEZ". Datosregistrales. T 27321 , F 112, S 8, H M 111887, I/A 22 ( 4.02.11).

19 de Enero de 2011
Reelecciones. Auditor: COMPTO AUDITORES SL. Datos registrales. T 27321 , F 112, S 8, H M 111887, I/A 21 (10.01.11).

09 de Diciembre de 2010
Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUEZ DE RIVERA CREMADES FERNANDO MARIA;LAGUNA LOPEZ TOMAS. Datosregistrales. T 27321 , F 111, S 8, H M 111887, I/A 20 (26.11.10).

16 de Noviembre de 2010
Cambio de domicilio social. C/ ALFONSO XII 30 6潞 (MADRID). Datos registrales. T 27321 , F 111, S 8, H M 111887, I/A 19 (3.11.10).

04 de Febrero de 2010
Reelecciones. Auditor: COMPTO AUDITORES SL. Datos registrales. T 6871 , F 133, S 8, H M 111887, I/A 18 (25.01.10).

17 de Septiembre de 2009
Reelecciones. Consejero: CREMADES DE ADARO FRANCISCO JAVIER;CREMADES CARCELLER CARLOS. Presidente:CREMADES DE ADARO FRANCISCO JAVIER. Consejero: CARCELLER COLL MARIA. Vicepresid.: CARCELLER COLL MARIA.Consejero: CREMADES CARCELLER MARIA DE LOS ANGELES;CREMADES CARCELLER MARIA JOSE. Cons.Del.Man:

23 de Marzo de 2009
Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDEZ SOBRINO JESUS MARIA;RODRIGUEZ DE RIVERA CREMADES FERNANDO MARIA.Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ SOBRINO JESUS MARIA;RODRIGUEZ DE RIVERA CREMADES FERNANDO MARIA.Datos registrales. T 6871 , F 132, S 8, H M 111887, I/A 16 (10.03.09).

11 de Marzo de 2009
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: CREMADES CARCELLER CARLOS. Cons.Del.Sol: CREMADES DE ADARO FRANCISCOJAVIER. Cons.Del.Man: CREMADES CARCELLER MARIA DE LOS ANGELES;CREMADES CARCELLER MARIA JOSE;CARCELLERCOLL MARIA. Nombramientos. Cons.Del.Man: CREMADES DE ADARO FRANCISCO JAVIER;CARCELLER COLL

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n