Buscador CIF Logo

Actos BORME Real Zaragoza Sad

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Real Zaragoza Sad

Actos BORME Real Zaragoza Sad - A50034107

Tenemos registrados 56 Actos BORME del Registro Mercantil de Zaragoza para Real Zaragoza Sad con CIF A50034107

馃敊 Perfil de Real Zaragoza Sad
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Zaragoza

Actos BORME de Real Zaragoza Sad

24 de Abril de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: FORCEN MARQUEZ JUAN;DE YARZA LOPEZ-MADRAZO FERNANDO. Datos registrales. T 4036 , F189, S 8, H Z 5671, I/A 111 (17.04.23).

05 de Enero de 2023
Reelecciones. Auditor: ADYTUM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4036 , F 189, S 8, H Z 5671, I/A 109 (30.12.22).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 6.700.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 27.674.572,00 Euros. Datos registrales. T 4036 , F 189, S8, H Z 5671, I/A 110 (30.12.22).

22 de Agosto de 2022
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: LLOP VELASCO MARIA CRISTINA. Nombramientos. Consejero: LLOP VELASCO CRISTINA.Secretario: LLOP VELASCO CRISTINA. Reelecciones. Consejero: MAS JORGE. Presidente: MAS JORGE. Consejero: SERPAPRECIADO GUSTAVO ADOLFO;AGUILAR LOPEZ MARIANO;CRUZ ROLDAN EMILIO;COOK LAURENCE. Datos registrales. T4036 , F 187, S 8, H Z 5671, I/A 107 (12.08.22).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 14.613.421,00 Euros. Resultante Suscrito: 20.974.572,00 Euros. Datos registrales. T 4036 , F 188,S 8, H Z 5671, I/A 108 (12.08.22).

22 de Junio de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: SANLLEHI COLOM RAUL;AURED GUALLAR MARIANO. Datos registrales. T 4036 , F 186, S 8, H Z5671, I/A 106 (15.06.22).

21 de Junio de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: AGUILAR LOPEZ MARIANO;FORCEN MARQUEZ JUAN. Datos registrales. T 4036 , F 185, S 8, H Z5671, I/A 105 (14.06.22).

07 de Junio de 2022
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA LAPUENTE ANTONIO. VsecrNoConsj: TOMAS RIC MARA. Consejero: SAINZ DEVARANDA ALIERTA FERNANDO;UGUET DE RESAYRE ALIERTA JUAN ANTONIO. Cons.Del.Sol: SAINZ DE VARANDA ALIERTAFERNANDO. Vicepresid.: SAINZ DE VARANDA ALIERTA FERNANDO. Consejero: BLASCO BOSQUED LUIS;DE YARZA LOPEZ-MADRAZO FERNANDO. Cons.Del.Sol: BLASCO BOSQUED LUIS. Revocaciones. Apo.Manc.: SAINZ DE VARANDA ALIERTAFERNANDO;UGUET DE RESAYRE ALIERTA JUAN ANTONIO;BLASCO BOSQUED LUIS;LAPETRA LOREN CHRISTIAN.Nombramientos. Consejero: MAS JORGE. Presidente: MAS JORGE. SecreNoConsj: LLOP VELASCO MARIA CRISTINA. Consejero:COOK LAURENCE;SERPA PRECIADO GUSTAVO ADOLFO;CRUZ ROLDAN EMILIO;AGUILAR LOPEZ MARIANO. Datosregistrales. T 4036 , F 183, S 8, H Z 5671, I/A 104 ( 1.06.22).

04 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. Presidente: LAPETRA LOREN CHRISTIAN. Consejero: LAPETRA LOREN CHRISTIAN. Datos registrales. T4036 , F 183, S 8, H Z 5671, I/A 103 (29.03.22).

28 de Enero de 2022
Reelecciones. Auditor: ADYTUM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4036 , F 183, S 8, H Z 5671, I/A 102 (24.01.22).

26 de Octubre de 2021
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 207/2011. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 20/07/2021. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ZARAGOZA. Juez: MARIA DEL CARMEN VILLELLASSANCHO. Resoluciones: Aprobada la propuesta de modificaci贸n del convenio de acreedores presentada por.la Sociedad "REALZARAGOZA SAD".- Datos registrales. T 4036 , F 182, S 8, H Z 5671, I/A 101 (20.10.21).

16 de Marzo de 2021
Reelecciones. Auditor: ADYTUM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4036 , F 182, S 8, H Z 5671, I/A 100 ( 8.03.21).

02 de Marzo de 2021
Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 37, 38, 39,40, 41 Y 42, LA ELIMINACION DE LOS ARTICULOS 8 Y 33, LA INCORPORACION DE UN NUEVO ARTICULO 20 BIS, Y LARENUMERACION DE ARTICULOS Datos registrales. T 4036 , F 178, S 8, H Z 5671, I/A 99 (23.02.21).

12 de Febrero de 2020
Reelecciones. Auditor: ADYTUM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4036 , F 178, S 8, H Z 5671, I/A 98 ( 5.02.20).

20 de Agosto de 2019
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: IRIBARREN OLAORTUA CARLOS-MARIA. Consejero: IRIBARREN OLAORTUA CARLOS-MARIA;RODRIGO ROBA FERNANDO. Nombramientos. Consejero: UGUET DE RESAYRE ALIERTA JUAN ANTONIO;BLASCOBOSQUED LUIS;FORCEN MARQUEZ JUAN. Reelecciones. Consejero: LAPETRA LOREN CHRISTIAN;SAINZ DE VARANDAALIERTA FERNANDO;DE YARZA LOPEZ-MADRAZO FERNANDO. Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.860.492,00 Euros. ResultanteSuscrito: 6.361.151,00 Euros. Datos registrales. T 3559 , F 103, S 8, H Z 5671, I/A 94 ( 9.08.19).

Nombramientos. Cons.Del.Sol: SAINZ DE VARANDA ALIERTA FERNANDO;BLASCO BOSQUED LUIS. Reelecciones. Presidente:LAPETRA LOREN CHRISTIAN. Vicepresid.: SAINZ DE VARANDA ALIERTA FERNANDO. Datos registrales. T 3559 , F 104, S 8, HZ 5671, I/A 95 ( 9.08.19).

Revocaciones. Apo.Manc.: SAINZ DE VARANDA ALIERTA FERNANDO;IRIBARREN OLAORTUA CARLOS-MARIA;LAPETRALOREN CHRISTIAN;RODRIGO ROBA FERNANDO. Apoderado: DE YARZA LOPEZ-MADRAZO FERNANDO. Datos registrales. T3559 , F 105, S 8, H Z 5671, I/A 96 (12.08.19).

Nombramientos. Apo.Manc.: LAPETRA LOREN CHRISTIAN;SAINZ DE VARANDA ALIERTA FERNANDO;DE YARZA LOPEZ-MADRAZO FERNANDO;BLASCO BOSQUED LUIS;UGUET DE RESAYRE ALIERTA JUAN ANTONIO;FORCEN MARQUEZ JUAN.Datos registrales. T 3559 , F 105, S 8, H Z 5671, I/A 97 (12.08.19).

25 de Febrero de 2019
Reelecciones. Auditor: ADYTUM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3559 , F 103, S 8, H Z 5671, I/A 93 (18.02.19).

03 de Mayo de 2018
Reelecciones. Auditor: ADYTUM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3559 , F 103, S 8, H Z 5671, I/A 92 (19.04.18).

22 de Marzo de 2017
Cambio de domicilio social. C/ EDUARDO IBARRA 6 (ZARAGOZA). Datos registrales. T 3559 , F 103, S 8, H Z 5671, I/A 90(14.03.17).

Nombramientos. Auditor: ADYTUM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3559 , F 103, S 8, H Z 5671, I/A 91 (14.03.17).

23 de Febrero de 2017
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 207/2011. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 4/11/2016. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA. Juez: MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO.Resoluciones: Aprobada la propuesta de modificaci贸n del convenio de acreedores presentada por.la Sociedad REAL ZARAGOZASAD. Datos registrales. T 3559 , F 102, S 8, H Z 5671, I/A 89 (14.02.17).

23 de Abril de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.500.659,00 Euros. Datos registrales. T 3559 , F 102, S8, H Z 5671, I/A 88 (16.04.15).

19 de Febrero de 2015
Reelecciones. Consejero: LAPETRA LOREN CHRISTIAN;IRIBARREN OLAORTUA CARLOS-MARIA;DE YARZA LOPEZ-MADRAZOFERNANDO;SAINZ DE VARANDA ALIERTA FERNANDO;RODRIGO ROBA FERNANDO. Datos registrales. T 3559 , F 100, S 8, HZ 5671, I/A 85 ( 4.02.15).

12 de Febrero de 2015
Nombramientos. Cons.Del.Sol: IRIBARREN OLAORTUA CARLOS-MARIA;SAINZ DE VARANDA ALIERTA FERNANDO.Reelecciones. Vicepresid.: SAINZ DE VARANDA ALIERTA FERNANDO. Presidente: LAPETRA LOREN CHRISTIAN. Datosregistrales. T 3559 , F 101, S 8, H Z 5671, I/A 86 ( 4.02.15).

Nombramientos. Apoderado: DE YARZA LOPEZ-MADRAZO FERNANDO. Datos registrales. T 3559 , F 101, S 8, H Z 5671, I/A 87 (4.02.15).

16 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Consejero: DE YARZA LOPEZ-MADRAZO FERNANDO. Datos registrales. T 3559 , F 100, S 8, H Z 5671, I/A 84 (9.12.14).

24 de Octubre de 2014
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: GARCIA LAPUENTE ANTONIO. Secretario: SAINZ DE VARANDA ALIERTA FERNANDO.Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA LAPUENTE ANTONIO. VsecrNoConsj: TOMAS RIC MARA. Vicepresid.: SAINZ DEVARANDA ALIERTA FERNANDO. Datos registrales. T 3559 , F 100, S 8, H Z 5671, I/A 83 (15.10.14).

19 de Septiembre de 2014
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ DE LA FUENTE JOSE ANTONIO;CHECA GONZALEZ FRANCISCO JOSE. Apo.Sol.: PARDEZAPICHARDO MIGUEL;HERRERA SANCRISTOBAL PEDRO. Apo.Manc.: CHECA GONZALEZ FRANCISCO JOSE;GUERRA ALVAREZJOSE. Apo.Sol.: GUERRA ALVAREZ JOSE. Apo.Manc.: GARCIA-PITARCH MARCO JESUS-VICENTE;CHECA GONZALEZFRANCISCO JOSE;GUERRA ALVAREZ JOSE. Apoderado: CUARTERO LAFORGA LUIS CARLOS. Apo.Manc.: IGLESIAS GARCIAAGAPITO. Datos registrales. T 2094 , F 83, S 8, H Z 5671, I/A 81 (11.09.14).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MARCELLAN ALBACAR DANIEL. Consejero: GUERRA ALVAREZ JOSE. Cons.Del.Man:GUERRA ALVAREZ JOSE. Revocaciones. Apo.Manc.: GUERRA ALVAREZ JOSE. Nombramientos. Secretario: SAINZ DEVARANDA ALIERTA FERNANDO. Cons.Del.Sol: SAINZ DE VARANDA ALIERTA FERNANDO;IRIBARREN OLAORTUA CARLOS-MARIA. Datos registrales. T 2094 , F 83, S 8, H Z 5671, I/A 82 (11.09.14).

07 de Agosto de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: GAMON VIDAL LUIS VICENTE;MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO. Cons.Del.Man: GAMON VIDALLUIS VICENTE. Presidente: GAMON VIDAL LUIS VICENTE. Cons.Del.Man: MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO. Nombramientos.VsecrNoConsj: GARCIA LAPUENTE ANTONIO. Presidente: LAPETRA LOREN CHRISTIAN. Consejero: LAPETRA LORENCHRISTIAN;RODRIGO ROBA FERNANDO;IRIBARREN OLAORTUA CARLOS-MARIA;SAINZ DE VARANDA ALIERTA FERNANDO.Datos registrales. T 2094 , F 82, S 8, H Z 5671, I/A 79 (30.07.14).

Nombramientos. Apo.Manc.: LAPETRA LOREN CHRISTIAN;RODRIGO ROBA FERNANDO;IRIBARREN OLAORTUA CARLOS-MARIA;SAINZ DE VARANDA ALIERTA FERNANDO;GUERRA ALVAREZ JOSE. Datos registrales. T 2094 , F 82, S 8, H Z 5671, I/A80 (30.07.14).

28 de Julio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: MOLINOS GRANADA EMILIO FERNANDO. Presidente: MOLINOS GRANADA EMILIO FERNANDO.Consejero: CHECA GONZALEZ FRANCISCO JOSE;CUARTERO LAFORGA LUIS CARLOS. Cons.Del.Sol: CHECA GONZALEZFRANCISCO JOSE. Nombramientos. Consejero: GAMON VIDAL LUIS VICENTE;MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO. Presidente:GAMON VIDAL LUIS VICENTE. Datos registrales. T 2094 , F 81, S 8, H Z 5671, I/A 77 (21.07.14).

Nombramientos. Cons.Del.Man: GUERRA ALVAREZ JOSE;GAMON VIDAL LUIS VICENTE;MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO.Datos registrales. T 2094 , F 81, S 8, H Z 5671, I/A 78 (21.07.14).

25 de Julio de 2014
Ceses/Dimisiones. Auditor: MORELLON BERNAD JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 2094 , F 81, S 8, H Z 5671, I/A 76

08 de Julio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: IGLESIAS GARCIA AGAPITO CARMELO. Cons.Del.Sol: IGLESIAS GARCIA AGAPITO CARMELO.Datos registrales. T 2094 , F 81, S 8, H Z 5671, I/A 75 ( 1.07.14).

08 de Mayo de 2014
Nombramientos. Auditor: MORELLON BERNAD JUAN FRANCISCO. Aud.Supl.: ADYTUM AUDITORES SLP. Datos registrales. T2094 , F 81, S 8, H Z 5671, I/A 74 (28.04.14).

12 de Septiembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: CUARTERO LAFORGA LUIS CARLOS. Datos registrales. T 2094 , F 80, S 8, H Z 5671, I/A 73 (5.09.13).

11 de Septiembre de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA-PITARCH MARCO JESUS-VICENTE;CHECA GONZALEZ FRANCISCO JOSE;GUERRAALVAREZ JOSE;IGLESIAS GARCIA AGAPITO. Datos registrales. T 2094 , F 78, S 8, H Z 5671, I/A 72 ( 3.09.13).

09 de Mayo de 2013
Modificaciones estatutarias. Art铆culo 18潞. 1. Las Juntas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias deber谩n ser convocadasmediante anuncio publicado en la p谩gina web de la sociedad, www.realzaragoza.com, con al menos un mes de antelaci贸n a la fechapara su celebraci贸n. 2. El anuncio expresar谩 el nombre de la Sociedad. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina webcorporativa: realzaragoza.com. Datos registrales. T 2094 , F 78, S 8, H Z 5671, I/A 71 (29.04.13).

30 de Abril de 2013
Ceses/Dimisiones. Presidente: IGLESIAS GARCIA AGAPITO CARMELO. Nombramientos. Presidente: MOLINOS GRANADA

Nombramientos. Apo.Manc.: CHECA GONZALEZ FRANCISCO JOSE;GUERRA ALVAREZ JOSE. Apo.Sol.: GUERRA ALVAREZJOSE. Datos registrales. T 2094 , F 77, S 8, H Z 5671, I/A 70 (18.04.13).

01 de Abril de 2013
Revocaciones. Apoderado: PORQUERA PEREZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2094 , F 77, S 8, H Z 5671, I/A 68(19.03.13).

18 de Febrero de 2013
Nombramientos. Consejero: GUERRA ALVAREZ JOSE;MOLINOS GRANADA EMILIO FERNANDO;CUARTERO LAFORGA LUISCARLOS Reelecciones. Consejero: IGLESIAS GARCIA AGAPITO CARMELO;CHECA GONZALEZ FRANCISCO JOSE. Presidente:IGLESIAS GARCIA AGAPITO CARMELO. Datos registrales. T 2094 , F 76, S 8, H Z 5671, I/A 67 ( 6.02.13).

15 de Febrero de 2013
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: PORQUERA PEREZ FRANCISCO JAVIER. Consejero: PORQUERA PEREZ FRANCISCOJAVIER. Datos registrales. T 2094 , F 76, S 8, H Z 5671, I/A 66 ( 6.02.13).

20 de Julio de 2012
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 207/2011. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 9/05/2012. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA. Juez: MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO.Resoluciones: Aprobaci贸n judicial del convenio, cese de todos los efectos de la declaraci贸n de concurso y cese de la administraci贸nconcursal. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 207/2011. Fecha de resoluci贸n 13/06/2011. Revocaci贸n deadministradores concursales. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA. Juez: MARIA DEL CARMENVILLELLAS SANCHO. Administrador Concursal. Fecha 9/05/2012, NIF/CIF 25426356V. TERREU LACORT CARLOS. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 207/2011. Fecha de resoluci贸n 13/06/2011. Revocaci贸n de administradores concursales.Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA. Juez: MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO. AdministradorConcursal. Fecha 9/05/2012, NIF/CIF 15240691V. JIMENEZ LENGUAS JULIAN ANDRES. Situaci贸n concursal. Procedimientoconcursal 207/2011. Fecha de resoluci贸n 13/06/2011. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LOMERCANTIL DE ZARAGOZA. Juez: MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO. Administrador Concursal. Fecha 9/05/2012, NIF/CIFB50570951. INDUSTRIAS GRAFICAS LA MODERNA SL. Datos registrales. T 2094 , F 76, S 8, H Z 5671, I/A 65 ( 7.07.12).

10 de Octubre de 2011
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 207/2011. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 13/06/2011. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA. Resoluciones: Convertida en inscripci贸n laanotaci贸n A de declaraci贸n de concurso voluntario,.al haber quedado FIRME el auto que la motiv贸, y los administradoresconcursales.aceptan el cargo. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 207/2011. Fecha de resoluci贸n 13/06/2011.Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA. Juez: MARIA DEL CARMENVILLELLAS SANCHO. Administrador Concursal. Fecha 13/06/2011, NIF/CIF 15240691V. JIMENEZ LENGUAS JULIAN ANDRES.Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 207/2011. Fecha de resoluci贸n 13/06/2011. Nombramiento de administradores.Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA. Juez: MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO. AdministradorConcursal. Fecha 13/06/2011, NIF/CIF 25426356V. TERREU LACORT CARLOS. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal207/2011. Fecha de resoluci贸n 13/06/2011. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DEZARAGOZA. Juez: MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO. Administrador Concursal. Fecha 13/06/2011, NIF/CIF B50570951.INDUSTRIAS GRAFICAS LA MODERNA SL. Datos registrales. T 2094 , F 75, S 8, H Z 5671, I/A 64 (29.09.11).

29 de Junio de 2011
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 207/2011. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 13/06/2011. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA. Juez: MARIA DEL CARMEN VILLELLASSANCHO. Resoluciones: Se declara en concurso voluntario al deudor REAL ZARAGOZA SAD, se determina que.las facultades deadministraci贸n y disposici贸n sobre su patrimonio del deudor quedan intervenidas por la administraci贸n concursal, mediante suautorizaci贸n o conformidad. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 207/2011. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 13/06/2011.Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado:num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA. Juez: MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO. Datos registrales. T2094 , F 75, S 8, H Z 5671, I/A A (16.06.11).

09 de Mayo de 2011
Otros conceptos: Autorizaci贸n para firma mec谩nica de los t铆tulos. Datos registrales. T 2094 , F 75, S 8, H Z 5671, I/A 62 N(27.04.11).

23 de Febrero de 2011
Nombramientos. Auditor: RUIZ-APILANEZ MEHAVE LUIS. Aud.Supl.: VIAMONTE FERNANDO JOSE-FRANCISCO. Datosregistrales. T 2094 , F 75, S 8, H Z 5671, I/A 63 (11.02.11).

24 de Noviembre de 2010
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 659,00 Euros. Desembolsado: 659,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.000.659,00 Euros. Resultante

30 de Abril de 2010
Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: CHECA GONZALEZ FRANCISCO JOSE. Consejero: ZAMORA MARTINEZ FERNANDO JOSE.Secretario: ZAMORA MARTINEZ FERNANDO JOSE. Vicepresid.: TERUEL IZQUIERDO MANUEL. Consejero: TERUEL IZQUIERDOMANUEL;MELERO RIVAS JOSE LUIS;SERRANO SANZ JOSE MARIA;UBIETO ARTETA AGUSTIN. Cons.Del.Sol: BANDRESMOLINE EDUARDO MARTIN. Consejero: BANDRES MOLINE EDUARDO MARTIN. Presidente: BANDRES MOLINE EDUARDOMARTIN. Nombramientos. SecreNoConsj: MARCELLAN ALBACAR DANIEL. Presidente: IGLESIAS GARCIA AGAPITO CARMELO.Consejero: CHECA GONZALEZ FRANCISCO JOSE;PORQUERA PEREZ FRANCISCO JAVIER. Cons.Del.Sol: IGLESIAS GARCIAAGAPITO CARMELO;CHECA GONZALEZ FRANCISCO JOSE;PORQUERA PEREZ FRANCISCO JAVIER. Reelecciones.Consejero: IGLESIAS GARCIA AGAPITO CARMELO. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 24潞.- Composici贸n y nombramientodel Consejo de Administraci贸n. 1. El Consejo de Administraci贸n del "Real Zaragoza S.A.D." estar谩 formado por un n煤mero deConsejeros, que podr谩n no ser accionistas, no inferior a tres ni superior a veinticinco, elegidos por la Junta General de Accionistas y.Datos registrales. T 2094 , F 74, S 8, H Z 5671, I/A 61 (21.04.10).

04 de Marzo de 2010
Reelecciones. Auditor: MORELLON BERNAD JUAN FRANCISCO. Aud.Supl.: PORRAS JURADO JESUS. Datos registrales. T2094 , F 74, S 8, H Z 5671, I/A 60 (23.02.10).

28 de Septiembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: FABRE MARQUES JUAN RAMON;GOMEZ DE LA FUENTE JOSE ANTONIO. Datos registrales. T2094 , F 74, S 8, H Z 5671, I/A 59 (16.09.09).

09 de Enero de 2009
Reelecciones. Auditor: MORELLON BERNAD JUAN FRANCISCO. Aud.Supl.: PORRAS JURADO JESUS. Datos registrales. T2094 , F 73, S 8, H Z 5671, I/A 58 (24.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n