Buscador CIF Logo

Actos BORME Recambios Autodiesel Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Recambios Autodiesel Sa

Actos BORME Recambios Autodiesel Sa - A08560179

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Recambios Autodiesel Sa con CIF A08560179

馃敊 Perfil de Recambios Autodiesel Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Recambios Autodiesel Sa

17 de Febrero de 2023
Revocaciones. APODERAD.SOL: MOHEDANO BLASCO SOFIA;LERMA SANZ VICTOR;MOHEDANO BLASCO EVA. Datosregistrales. T 46761 , F 45, S 8, H B 17431, I/A 51 (10.02.23).

19 de Septiembre de 2022
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 695.533,27 Euros. Desembolsado: 695.533,27 Euros. Resultante Suscrito: 3.133.040,07 Euros.Resultante Desembolsado: 3.133.040,07 Euros. Datos registrales. T 46761 , F 44, S 8, H B 17431, I/A 50 (12.09.22).

12 de Agosto de 2022
Nombramientos. APODERAD.SOL: NOMDEDEU DOMENECH RAMON. Datos registrales. T 46761 , F 44, S 8, H B 17431, I/A 49 (4.08.22).

13 de Mayo de 2021
Revocaciones. ADM.UNICO: RAYO ROMERO ANTONIO. Nombramientos. ADM.UNICO: MOHEDANO SANCHEZ MANUEL.Datos registrales. T 46761 , F 44, S 8, H B 17431, I/A 48 ( 5.05.21).

17 de Junio de 2020
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.803.036,30 Euros. Desembolsado: 1.803.036,30 Euros. Resultante Suscrito: 2.437.506,80 Euros.Resultante Desembolsado: 2.437.506,80 Euros. Datos registrales. T 46761 , F 43, S 8, H B 17431, I/A 47 ( 9.06.20).

24 de Octubre de 2019
Nombramientos. AUDIT.INDIV.: AUDILEGALIA SLP. AUDT.CTS.CON: AUDILEGALIA SLP. Datos registrales. T 46761 , F 43, S 8,H B 17431, I/A 46 (16.10.19).

18 de Julio de 2019
Otros conceptos: RECTIFICACION DE LA INSCRIPCION 41 EN CUANTO A LA REDACCION DEL ARTICULO 24 DE LOSESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 46761 , F 43, S 8, H B 17431, I/A 45 (10.07.19).

07 de Junio de 2019
Nombramientos. APODERAD.SOL: MOHEDANO HABAS MANUEL. Datos registrales. T 46761 , F 42, S 8, H B 17431, I/A 42(29.05.19).

Nombramientos. APODERAD.SOL: MOHEDANO BLASCO EVA. Datos registrales. T 46761 , F 42, S 8, H B 17431, I/A 43(29.05.19).

Revocaciones. APODERADO: FERNANDEZ SORIANO JOSE LUIS. APODERAD.SOL: DOMINGUEZ FERNANDEZ BENITO JOSE.Datos registrales. T 46761 , F 43, S 8, H B 17431, I/A 44 (29.05.19).

23 de Mayo de 2019
Revocaciones. CONSEJERO: MOHEDANO HABAS MANUEL. PRESIDENTE: MOHEDANO HABAS MANUEL. CONS. DELEG.:MOHEDANO HABAS MANUEL. CONSEJERO: BLASCO ANTOLIN ISABEL;FERNANDEZ SORIANO JOSE LUIS. SECRETARIO:FERNANDEZ SORIANO JOSE LUIS. Nombramientos. ADM.UNICO: RAYO ROMERO ANTONIO. Modificaciones estatutarias.MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 16,18,24,25,28,29,30,31 Y 33 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN

25 de Febrero de 2019
Nombramientos. APODERAD.SOL: DOMINGUEZ FERNANDEZ BENITO JOSE. Datos registrales. T 31232 , F 135, S 8, H B

27 de Diciembre de 2018
Nombramientos. APODERAD.SOL: RAYO ROMERO ANTONIO. Datos registrales. T 31232 , F 134, S 8, H B 17431, I/A 39(17.12.18).

24 de Mayo de 2018
Revocaciones. APODERADO: MOHEDANO BLASCO ISABEL. Datos registrales. T 31232 , F 134, S 8, H B 17431, I/A 38(17.05.18).

26 de Diciembre de 2017
Revocaciones. CONSEJERO: MOURELO ALVAREZ RAMON. SECRETARIO: MOURELO ALVAREZ RAMON. APODERADO:MOURELO ALVAREZ RAMON. Nombramientos. CONSEJERO: FERNANDEZ SORIANO JOSE LUIS. SECRETARIO: FERNANDEZSORIANO JOSE LUIS. Datos registrales. T 31232 , F 133, S 8, H B 17431, I/A 37 (13.12.17).

22 de Junio de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: LERMA SANZ VICTOR. Datos registrales. T 31232 , F 133, S 8, H B 17431, I/A 36 (13.06.17).

31 de Mayo de 2017
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ROSES AUDITORES ASOCIADOS SLP. AUDT.CTS.CON: ROSES AUDITORES ASOCIADOSSLP. Datos registrales. T 31232 , F 133, S 8, H B 17431, I/A 35 (24.05.17).

22 de Diciembre de 2016
Nombramientos. APODERAD.SOL: MOHEDANO BLASCO SOFIA. Datos registrales. T 31232 , F 132, S 8, H B 17431, I/A 34(15.12.16).

09 de Febrero de 2016
Nombramientos. CONSEJERO: MOHEDANO HABAS MANUEL. PRESIDENTE: MOHEDANO HABAS MANUEL. CONS. DELEG.:MOHEDANO HABAS MANUEL. CONSEJERO: MOURELO ALVAREZ RAMON. SECRETARIO: MOURELO ALVAREZ RAMON.CONSEJERO: BLASCO ANTOLIN ISABEL. Datos registrales. T 31232 , F 132, S 8, H B 17431, I/A 33 ( 1.02.16).

17 de Julio de 2015
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 3.407,79 Euros. Desembolsado: 3.407,79 Euros. Resultante Suscrito: 634.470,50 Euros. ResultanteDesembolsado: 634.470,50 Euros. Datos registrales. T 31232 , F 131, S 8, H B 17431, I/A 32 ( 9.07.15).

27 de Octubre de 2014
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ROSES AUDITORES ASOCIADOS SLP. Datos registrales. T 31232 , F 131, S 8, H B 17431, I/A31 (17.10.14).

25 de Octubre de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ROSES AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 31232 , F 130, S 8, H B 17431, I/A30 (13.10.11).

23 de Febrero de 2011
Nombramientos. CONSEJERO: MOHEDANO HABAS MANUEL. PRESIDENTE: MOHEDANO HABAS MANUEL. CONS. DELEG.:MOHEDANO HABAS MANUEL. CONSEJERO: MOURELO ALVAREZ RAMON. SECRETARIO: MOURELO ALVAREZ RAMON.CONSEJERO: BLASCO ANTOLIN ISABEL. Datos registrales. T 31232 , F 130, S 8, H B 17431, I/A 29 (11.02.11).

13 de Enero de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ROSES AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 31232 , F 130, S 8, H B 17431, I/A28 (30.12.10).

04 de Enero de 2010
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ROSES AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 31232 , F 129, S 8, H B 17431, I/A27 (21.12.09).

07 de Mayo de 2009
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ROSES AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 31232 , F 129, S 8, H B 17431, I/A26 (24.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n