Actos BORME de Recreativos Union 94 Sa
24 de Diciembre de 2020Revocaciones. Auditor: ADADE AUDITORES SA. Datos registrales. T 762, L 553, F 129, S 8, H BU 4134, I/A 21 (18.12.20).
24 de Septiembre de 2020Nombramientos. Auditor: ADADE AUDITORES SA. Datos registrales. T 762, L 553, F 129, S 8, H BU 4134, I/A 20 (18.09.20).
12 de Septiembre de 2019Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GONZALEZ GOMEZ ANTONIO. Consejero: GONZALEZ GOMEZ ANTONIO. Presidente:GONZALEZ GOMEZ ANTONIO. Consejero: RUIZ FERNANDEZ ALFONSO;DE AGUEDA ALVARO FRANCISCO JAVIER. Secretario:JARAIZ MARTIN JOSE MANUEL. Nombramientos. Adm. Unico: GONZALEZ GOMEZ ANTONIO. Otros conceptos: Art铆culo de losestatutos: Cambio de estructura del 贸rgano de administraci贸n siendo ahora el de un administrador 煤nico, modific谩ndose lossiguientes:ARTICULO 13潞- Duraci贸n del cargo de administrador y Fijaci贸n de la Retribuci贸n en el 贸rgano de administraci贸n.ARTICULO 14潞- Funcionamiento del. Datos registrales. T 528, L 319, F 101, S 8, H BU 4134, I/A 19 ( 5.09.19).
29 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: MINGUITO PINEDO JESUS AMANDO;LLORENTE IBA脩EZ MARIA INMACULADA. Datos registrales. T528, L 319, F 101, S 8, H BU 4134, I/A 18 (22.11.16).
12 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: LLORENTE IBA脩EZ JUAN CARLOS;GONZALEZ GOMEZ ANTONIO;RUIZ FERNANDEZALFONSO;ORTEGA SANZ ABEL. Presidente: LLORENTE IBA脩EZ JUAN CARLOS. Con.Delegado: GONZALEZ GOMEZ ANTONIO.Nombramientos. Consejero: GONZALEZ GOMEZ ANTONIO. Presidente: GONZALEZ GOMEZ ANTONIO. Consejero: RUIZFERNANDEZ ALFONSO;DE AGUEDA ALVARO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 528, L 319, F 100, S 8, H BU 4134, I/A16 ( 5.08.14).
Nombramientos. Con.Delegado: GONZALEZ GOMEZ ANTONIO. Datos registrales. T 528, L 319, F 101, S 8, H BU 4134, I/A 17 (5.08.14).
22 de Enero de 2014Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 897.562,52 Euros. Desembolsado: 897.562,52 Euros. Resultante Suscrito: 2.283.278,35 Euros.Resultante Desembolsado: 2.283.278,35 Euros. Datos registrales. T 528, L 319, F 100, S 8, H BU 4134, I/A 15 (15.01.14).
26 de Julio de 2012Cambio de domicilio social. AVDA DE LA PAZ 31 BAJO (BURGOS). Datos registrales. T 528, L 319, F 100, S 8, H BU 4134, I/A14 (17.07.12).
16 de Julio de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 158,05 Euros. Desembolsado: 158,05 Euros. Resultante Suscrito: 1.080.837,91 Euros. ResultanteDesembolsado: 1.080.837,91 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 304.877,92 Euros. Desembolsado: 304.877,92 Euros.Resultante Suscrito: 1.385.715,83 Euros. Resultante Desembolsado: 1.385.715,83 Euros. Datos registrales. T 528, L 319, F 99, S 8,H BU 4134, I/A 13 ( 5.07.12).
18 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: LLORENTE IBA脩EZ JUAN CARLOS. Presidente: LLORENTE IBA脩EZ JUAN CARLOS. Consejero:SAN MIGUEL OROZCO JULIAN. Cons.Del.Sol: SAN MIGUEL OROZCO JULIAN. Consejero: GONZALEZ GOMEZ ANTONIO.Cons.Del.Sol: GONZALEZ GOMEZ ANTONIO. Consejero: RUIZ FERNANDEZ ALFONSO;ORTEGA SANZ ABEL. Nombramientos.Consejero: LLORENTE IBA脩EZ JUAN CARLOS;GONZALEZ GOMEZ ANTONIO;RUIZ FERNANDEZ ALFONSO;ORTEGA SANZABEL. Presidente: LLORENTE IBA脩EZ JUAN CARLOS. Con.Delegado: GONZALEZ GOMEZ ANTONIO. Reelecciones. Secretario:JARAIZ MARTIN JOSE MANUEL. Datos registrales. T 528, L 319, F 97, S 8, H BU 4134, I/A 12 ( 9.03.11).