Buscador CIF Logo

Actos BORME Recuperacion Ambiental Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Recuperacion Ambiental Sl

Actos BORME Recuperacion Ambiental Sl - B31510035

Tenemos registrados 7 Actos BORME del Registro Mercantil de Navarra para Recuperacion Ambiental Sl con CIF B31510035

🔙 Perfil de Recuperacion Ambiental Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Navarra

Actos BORME de Recuperacion Ambiental Sl

23 de Junio de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: MUNARRIZ MORENO LUIS. Nombramientos. Consejero: ZOCO HUARTE ALBERTO. Datosregistrales. T 413 , F 101, S 8, H NA 9114, I/A 22 (15.06.23).

29 de Septiembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: SAGARDOY LIZUAIN FRANCISCO JAVIER. Presidente: SAGARDOY LIZUAIN FRANCISCO JAVIER.Revocaciones. Apoderado: SAGARDOY LIZUAIN FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apoderado: IRIGUIBEL LOPEZ JOSE.Consejero: IRIGUIBEL LOPEZ JOSE. Presidente: IRIGUIBEL LOPEZ JOSE. Datos registrales. T 413 , F 101, S 8, H NA 9114, I/A 21(15.09.21).

09 de Mayo de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ DE ALDA RODRIGUEZ FERNANDO;LECUMBERRI VILLAREAL RAFAEL;LIRIA FRANCHFRANCISCO JAVIER. Presidente: LIRIA FRANCH FRANCISCO JAVIER. Revocaciones. Apoderado: LIRIA FRANCH FRANCISCOJAVIER. Nombramientos. Apoderado: SAGARDOY LIZUAIN FRANCISCO JAVIER. Consejero: SAGARDOY LIZUAIN FRANCISCOJAVIER. Presidente: SAGARDOY LIZUAIN FRANCISCO JAVIER. Consejero: MARIEZCURRENA ECHEVERRIA JAVIER;LAS NAVASLACALLE JUAN. Datos registrales. T 413 , F 100, S 8, H NA 9114, I/A 20 (30.04.18).

02 de Julio de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ TRUEBA JOSE IGNACIO. Secretario: SANCHEZ TRUEBA JOSE IGNACIO.Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ TRUEBA JOSE IGNACIO. Nombramientos. Secretario: GUILLEN URTASUN ALVARO.Apoderado: LIRIA FRANCH FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 413 , F 100, S 8, H NA 9114, I/A 19 (24.06.13).

28 de Mayo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: LESACA MOMO CARMELO JAVIER. Nombramientos. Consejero: ASTIZ LIZARRAGAJOKIN;MUNARRIZ MORENO LUIS. Datos registrales. T 413 , F 100, S 8, H NA 9114, I/A 18 (16.05.12).

17 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRES RUIZ VICTOR. Presidente: TORRES RUIZ VICTOR. Nombramientos. Consejero: LIRIAFRANCH FRANCISCO JAVIER. Presidente: LIRIA FRANCH FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 413 , F 99, S 8, HNA009114, I/A00017 ( 6.08.10).

18 de Mayo de 2009
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ TRUEBA JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 413 , F 99, S 8, H NA009114, I/A00016 (6.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información