Buscador CIF Logo

Actos BORME Red Logistica 2004 Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Red Logistica 2004 Sl

Actos BORME Red Logistica 2004 Sl - B84069830

Tenemos registrados 16 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Red Logistica 2004 Sl con CIF B84069830

馃敊 Perfil de Red Logistica 2004 Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Red Logistica 2004 Sl

20 de Mayo de 2016
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GABILONDO EGA脩A IGNACIO. VsecrNoConsj: BURGOS SAINZ ANA. Consejero: LIENHARDTJEAN;PANCHARTEK JAN;ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER. Presidente: LIENHARDT JEAN. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n.Datos registrales. T 32283 , F 148, S 8, H M 394533, I/A 18 (10.05.16).

26 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: LE TOUZE JEROME SACHA;WAMS NANNE WILLEM CORNELIS;SHAW MARK. Presidente: SHAWMARK. Nombramientos. Consejero: LIENHARDT JEAN;PANCHARTEK JAN;ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER. Presidente:LIENHARDT JEAN. Datos registrales. T 32283 , F 146, S 8, H M 394533, I/A 16 (14.08.15).

Revocaciones. Apo.Manc.: LE TOUZE JEROME SACHA;WAMS NANNE WILLEM CORNELIS;SHAW MARK. Nombramientos.Apoderado: PAR UMBERT JUAN PABLO;ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER;LIENHARDT JEAN;PANCHARTEK JAN;PAR UMBERTJUAN PABLO;ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER;LIENHARDT JEAN;PANCHARTEK JAN. Datos registrales. T 32283 , F 146, S 8,H M 394533, I/A 17 (14.08.15).

08 de Mayo de 2015
Revocaciones. Apo.Manc.: FAURE WALKER WILLIAM MARK. Nombramientos. Apo.Manc.: ORTEGA RAMOS CARLOSJAVIER;ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER;PAR UMBERT JUAN PABLO;PAR UMBERT JUAN PABLO. Datos registrales. T 32283, F 145, S 8, H M 394533, I/A 15 (27.04.15).

15 de Abril de 2015
Revocaciones. Apo.Manc.: BAYALLER PASCAL RENE MARCEL. Nombramientos. Apo.Manc.: RENESES BARCENA JORDIMIGUEL. Datos registrales. T 32283 , F 144, S 8, H M 394533, I/A 14 ( 1.04.15).

16 de Marzo de 2015
Otros conceptos: Rectificaci贸n de la inscripci贸n 11& en la sociedad de esta hoja. Datos registrales. T 32283 , F 144, S 8, H M394533, I/A 13 ( 3.03.15).

10 de Marzo de 2015
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 11& EL NOMBRAMIENTO DE SHAW MARK COMO CONSEJERODELEGADO SOLIDARIO, DEBIENDO QUEDAR ANULADO. Datos registrales. T 32283 , F 142, S 8, H M 394533, I/A 11 (12.02.15).

02 de Marzo de 2015
Revocaciones. Apoderado: ROMANI ALBAREDA JOSE;ROMANI ALBAREDA JOSE. Nombramientos. Apo.Manc.: BAYALLERPASCAL RENE MARCEL;LE TOUZE JEROME SACHA;WAMS NANNE WILLEM CORNELIS;SHAW MARK;LUCEA RONCAL JESUSJAVIER;FAURE WALKER WILLIAM MARK;ROMEO ERRUZ MARIA CARMEN;ROMANI ALBAREDA GEMMA. Datos registrales. T32283 , F 143, S 8, H M 394533, I/A 12 (19.02.15).

24 de Febrero de 2015
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: DS SMITH PACKAGING HOLDING SLU. Ceses/Dimisiones. Consejero: NUEVOS

04 de Diciembre de 2014
Revocaciones. Apoderado: MARTI MU脩OZ DE ARENILLAS JESUS MARIA. Datos registrales. T 32283 , F 142, S 8, H M 394533,I/A 10 (26.11.14).

20 de Noviembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: IFM INTERNACIONAL SA. Representan: MORA DELGADO VICENTE. Datos registrales. T 32283 ,F 142, S 8, H M 394533, I/A 9 (12.11.14).

25 de Junio de 2014
Nombramientos. Apoderado: CENTELLES AYORA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 22116 , F 144, S 8, H M 394533, I/A 8(16.06.14).

14 de Abril de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ROMANI FORN JOSE. Nombramientos. Consejero: NUEVOS PROYECTOS ONDULADOS SL.Presidente: NUEVOS PROYECTOS ONDULADOS SL. Consejero: PROYECTOS INDUSTRIALES DE ANDORRA SL. Secretario:PROYECTOS INDUSTRIALES DE ANDORRA SL. Consejero: IFM INTERNACIONAL SA;INICIATIVA INDUSTRIAL DE ANDORRA SL.Cons.Del.Sol: NUEVOS PROYECTOS ONDULADOS SL;PROYECTOS INDUSTRIALES DE ANDORRA SL. Representan: ROMANIALBAREDA GEMMA;ROMANI ALBAREDA MARIA DOLORES;MORA DELGADO VICENTE;ROMANI ALBAREDA JUAN.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datosregistrales. T 22116 , F 143, S 8, H M 394533, I/A 7 ( 3.04.14).

25 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: MARTI MU脩OZ DE ARENILLAS JESUS MARIA. Datos registrales. T 22116 , F 143, S 8, H M394533, I/A 6 (15.11.11).

02 de Junio de 2011
Cambio de domicilio social. AVDA DE VI脩UELAS 25, 1潞 A (TRES CANTOS). Datos registrales. T 22116 , F 143, S 8, H M 394533,I/A 5 (20.05.11).

03 de Agosto de 2010
Nombramientos. Apoderado: ROMANI ALBAREDA JOSE. Datos registrales. T 22116 , F 142, S 8, H M 394533, I/A 4 (22.07.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n