Actos BORME de Red Logistica De Andalucia Sa
22 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: ARIAS PALMA FELIPE. Reelecciones. Auditor: BRAINSTORMING AUDIT SLP. Consejero:MERINO LOPEZ RAFAEL;MUÑOZ ATANET SANCHEZ MARIO;LANDALUCE CALLEJA GERARDO. Vicepresid.: MERINO LOPEZRAFAEL. Con.Delegado: MERINO LOPEZ RAFAEL. Presidente: MUÑOZ ATANET SANCHEZ MARIO. Consejero: SANCHEZCASTAÑO ONOFRE;RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE MARIA;MOLINA ROMERO ENCARNACION.Secretario: RODRIGUEZGUTIERREZ JOSE MARIA. Consejero: AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA;AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIADE ALGECIRAS;AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA. Datos registrales. T 6715 , F 209, S 8, H SE 1799,I/A 93 (15.11.23).
17 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA TORRE LOPEZ ANABEL;RAYNAUD SOTO JAIME. VsecrNoConsj: DEL HOYO ROMERONIEVES. Consejero: CABEZA SEVIEL INMACULADA. Nombramientos. Consejero: SAINZ DE BARANDA PIÑERO MARIADOLORES. Auditor: BRAINSTORMING AUDIT SLP. Vicesecret.: SAINZ DE BARANDA PIÑERO MARIA DOLORES. Consejero:ARIAS PALMA FELIPE. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-. 27. Emisión del voto por mediostelemáticos. . 43. De la Dirección Gerencia. . 23. Junta General telemática.- . 35. Reuniones y adopción de acuerdos del Consejo deAdministración.- . Cambio de objeto social. Constituye el objeto social de la entidad la realización y desarrollo de las actividadesencaminadas a la promoción, gestión y prestación de servicios en materia de áreas logísticas, transporte de mercancías einfraestructuras de transporte, incluidos el de viajeros, así como a la promoción,. Datos registrales. T 6715 , F 207, S 8, H SE 1799,I/A 91 ( 8.03.23).
Reducción de capital. Importe reducción: 25.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 90.447.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. Artículo de los estatutos: 6.Numeración de las acciones. . Datos registrales. T 6715 , F209, S 8, H SE 1799, I/A 92 ( 8.03.23).
07 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Presidente: RAYNAUD SOTO JAIME. Nombramientos. Presidente: MUÑOZ ATANET SANCHEZ MARIO.Datos registrales. T 6715 , F 207, S 8, H SE 1799, I/A 90 (26.03.21).
12 de Marzo de 2020Ampliación de capital. Suscrito: 2.500.000,00 Euros. Desembolsado: 2.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 90.472.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 90.472.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. 6.Numeracion de las acciones.. Datos registrales. T 6715 , F 206, S 8, H SE 1799, I/A 89 ( 3.03.20).
03 de Marzo de 2020Ceses/Dimisiones. Secretario: DE LA TORRE LOPEZ ANABEL. Nombramientos. Secretario: RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSEMARIA. Datos registrales. T 6715 , F 205, S 8, H SE 1799, I/A 88 (25.02.20).
19 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: MOLINA ROMERO MARIA ENCARNACION. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ BERMEJOMARIA EULALIA;GARCIA GUIRADO MANUEL;CABEZA SEVIEL INMACULADA. Datos registrales. T 6105 , F 88, S 8, H SE 1799,I/A 83 (21.05.18).
05 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: LUCENA HIDALGO PABLO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA GUIRADO MANUEL.Apo.Sol.: ZAFRA MENGUAL ROSA MARIA. Apoderado: ZAFRA MENGUAL ROSA MARIA. Nombramientos. VsecrNoConsj: DELHOYO ROMERO NIEVES. Apo.Man.Soli: SANCHEZ CASTAÑO ONOFRE;VILANA ESPEJO GUILLERMO. Apoderado: RODRIGUEZGUTIERREZ JOSE MARIA. D. Gerente: SANCHEZ CASTAÑO ONOFRE. Otros conceptos: Amplia las facultades dispositivas delConsejero Delegado, Don Rafael Merino López.- Datos registrales. T 6715 , F 203, S 8, H SE 1799, I/A 87 (28.10.19).
04 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA GUIRADO MANUEL. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ CASTAÑOONOFRE;RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE MARIA;MOLINA ROMERO ENCARNACION. Reelecciones. Consejero: AGENCIAPUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA;AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA;AUTORIDAD PORTUARIADE LA BAHIA DE ALGECIRAS. Datos registrales. T 6715 , F 202, S 8, H SE 1799, I/A 86 (23.10.19).
07 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: MASEGOSA MARTOS MARIA NIEVES;FERNANDEZ BERMEJO MARIA EULALIA;CHACONSANCHEZ RAFAEL;MORON LEDRO MANUEL. Presidente: MASEGOSA MARTOS MARIA NIEVES. Vicepresid.: FERNANDEZBERMEJO MARIA EULALIA. Co.De.Ma.So: FERNANDEZ BERMEJO MARIA EULALIA. Revocaciones. Apo.Manc.: MASEGOSAMARTOS MARIA NIEVES. Apo.Man.Soli: GARCIA GUIRADO MANUEL;SANCHEZ CASTAÑO ONOFRE. Apo.Sol.: ZAFRA MENGUALROSA MARIA;LASSO DE LA VEGA MACHO JAVIER;MARTINEZ TORRES MANUEL FRANCISCO;GARRATON JULIA JOSE LUIS.Nombramientos. Apo.Manc.: RAYNAUD SOTO JAIME. Consejero: RAYNAUD SOTO JAIME;MERINO LOPEZ RAFAEL;MUÑOZATANET SANCHEZ MARIO;LANDALUCE CALLEJA GERARDO. Presidente: RAYNAUD SOTO JAIME. Vicepresid.: MERINO LOPEZRAFAEL. Con.Delegado: MERINO LOPEZ RAFAEL. Apo.Man.Soli: GARCIA GUIRADO MANUEL;SANCHEZ CASTAÑO ONOFRE.Apo.Sol.: ZAFRA MENGUAL ROSA MARIA;LASSO DE LA VEGA MACHO JAVIER;ZAMBRANA MARTIN JOSE LUIS;GARRATONJULIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 6105 , F 91, S 8, H SE 1799, I/A 85 (31.05.19).
06 de Julio de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: ZAFRA MENGUAL ROSA MARIA. Datos registrales. T 6105 , F 88, S 8, H SE 1799, I/A 83 (21.05.18).
Fe de erratas: Se rectifica la inscripción 83ª, al objeto de hacer constar que el número correcto de D.N.I. de doña Rosa María ZafraMengual es el 30.491.425-A. Datos registrales. T 6105 , F 91, S 8, H SE 1799, I/A 84 (29.06.18).
31 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: MASEGOSA MARTOS MARIA NIEVES. Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA GUIRADOMANUEL;GARCIA GUIRADO MANUEL. Apo.Manc.: MASEGOSA MARTOS MARIA NIEVES. Apo.Man.Soli: GARCIA GUIRADOMANUEL;SANCHEZ CASTAÑO ONOFRE. Apo.Sol.: SAINZ DE BARANDA PIÑERO MARIA DOLORES;DE LA TORRE LOPEZ ANAISABEL. Apo.Manc.: LINARES FERNANDEZ FERNANDO. Apo.Man.Soli: SANCHEZ CASTAÑO ONOFRE. Nombramientos.Vicepresid.: FERNANDEZ BERMEJO MARIA EULALIA. Co.De.Ma.So: FERNANDEZ BERMEJO MARIA EULALIA. Apo.Manc.:MASEGOSA MARTOS MARIA NIEVES. Apo.Man.Soli: GARCIA GUIRADO MANUEL;SANCHEZ CASTAÑO ONOFRE. Apo.Sol.:ZAFRA MENGUAL ROSA MARIA;LASSO DE LA VEGA MACHO JAVIER;MARTINEZ TORRES MANUEL FRANCISCO;GARRATONJULIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 6105 , F 88, S 8, H SE 1799, I/A 83 (21.05.18).
01 de Diciembre de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA GUIRADO MANUEL. Apo.Manc.: MASEGOSA MARTOS MARIA NIEVES. Datosregistrales. T 6105 , F 86, S 8, H SE 1799, I/A 82 (24.11.17).
28 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE MARIA;RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE MARIA. Nombramientos.Apoderado: DE LA TORRE LOPEZ ANA ISABEL. Datos registrales. T 6105 , F 86, S 8, H SE 1799, I/A 81 (21.11.17).
10 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ GOMEZ DE CELIS ALFONSO. Vicepresid.: RODRIGUEZ GOMEZ DE CELISALFONSO. Co.De.Ma.So: RODRIGUEZ GOMEZ DE CELIS ALFONSO. Datos registrales. T 6105 , F 86, S 8, H SE 1799, I/A 79(31.10.17).
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 4. Se modifica el párrafo numero uno. Relativo al domicilio social. . Cambiode domicilio social. C/ PABLO PICASSO 6 - SEDE DE LA AGENCIA PUBLICA DE (SEVILLA). Datos registrales. T 6105 , F 86, S8, H SE 1799, I/A 80 (31.10.17).
05 de Septiembre de 2017Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6105 , F 85, S 8, H SE 1799, I/A 78 (29.08.17).
01 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE MARIA. SecreNoConsj: DE LA TORRE LOPEZ ANABEL.Nombramientos. Consejero: DE LA TORRE LOPEZ ANABEL. Secretario: DE LA TORRE LOPEZ ANABEL. Datos registrales. T6105 , F 85, S 8, H SE 1799, I/A 77 (21.07.17).
21 de Julio de 2017Ceses/Dimisiones. Secretario: RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE MARIA. VsecrNoConsj: DE LA TORRE LOPEZ ANA ISABEL.Nombramientos. SecreNoConsj: DE LA TORRE LOPEZ ANABEL. VsecrNoConsj: LUCENA HIDALGO PABLO. Datos registrales. T6105 , F 85, S 8, H SE 1799, I/A 76 (13.07.17).
12 de Diciembre de 2016Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: ADECUACION DEL ARTICULO 4º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.Cambio de domicilio social. C/ PABLO PICASSO S/N - 41018 (SEVILLA). Datos registrales. T 6105 , F 84, S 8, H SE 1799, I/A 75(30.11.16).
12 de Agosto de 2016Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE MARIA. Secretario: RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE MARIA. Datosregistrales. T 6105 , F 84, S 8, H SE 1799, I/A 74 ( 5.08.16).
18 de Julio de 2016Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 1.322.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos:5. Capital social.-. Datos registrales. T 6105 , F 84, S 8, H SE 1799, I/A 73 ( 6.07.16).
11 de Mayo de 2016Reelecciones. Consejero: CHACON SANCHEZ RAFAEL;AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA. Datosregistrales. T 5315 , F 24, S 8, H SE 1799, I/A 71 (26.11.15).
28 de Marzo de 2016Ampliación de capital. Suscrito: 6.263.000,00 Euros. Desembolsado: 4.941.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 87.972.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 86.650.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: MODIFICADOS LOSARTICULOS 5 Y 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- . Datos registrales. T 6105 , F 82, S 8, H SE 1799, I/A 72 (16.03.16).
04 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ-OSSORIO RAMOS IGNACIO;ORDOÑEZ FERNANDEZ JOSE LUIS. D. Gerente:ALVAREZ-OSSORIO RAMOS IGNACIO. Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ-OSSORIO RAMOS IGNACIO. Apo.Sol.: ALVAREZ-OSSORIO RAMOS IGNACIO. Nombramientos. Consejero: CHACON SANCHEZ RAFAEL. Presidente: MASEGOSA MARTOSMARIA NIEVES. Cons.Del.Man: MASEGOSA MARTOS MARIA NIEVES. Vicepresid.: RODRIGUEZ GOMEZ DE CELIS ALFONSO.Co.De.Ma.So: RODRIGUEZ GOMEZ DE CELIS ALFONSO. Gerente: GARCIA GUIRADO MANUEL. Apo.Man.Soli: GARCIA GUIRADOMANUEL. Apo.Sol.: DE LA TORRE LOPEZ ANA ISABEL;SAINZ DE BARANDA PIÑERO MARIA DOLORES. Apo.Man.Soli: SANCHEZCASTAÑO ONOFRE;GARCIA GUIRADO MANUEL. Reelecciones. Consejero: ALVAREZ-OSSORIO RAMOS IGNACIO;MORONLEDRO MANUEL;MOLINA ROMERO MARIA ENCARNACION;AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA;AUTORIDADPORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS. Modificación de poderes. Apo.Man.Soli: SANCHEZ CASTAÑO ONOFRE. Otrosconceptos: Se sustituyen los actuales poderes del Director Técnico de la entidad, Don Onofre Sánchez Castaño, por las facultadesque seguidamente se reseñan: a. Gestión de obras, proyectos y servicios: suscribir actas de replanteo, de comprobación de replanteo,de viabilidad, de ocupación, de recepción provisi. Datos registrales. T 5315 , F 24, S 8, H SE 1799, I/A 71 (26.11.15).
12 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA CEBRIAN JOSE ANTONIO;PANEQUE SOSA MIGUEL ANGEL. Presidente: GARCIACEBRIAN JOSE ANTONIO. Vicepresid.: PANEQUE SOSA MIGUEL ANGEL. Co.De.Ma.So: PANEQUE SOSA MIGUEL ANGEL.Nombramientos. Consejero: MASEGOSA MARTOS MARIA NIEVES;RODRIGUEZ GOMEZ DE CELIS ALFONSO. Datosregistrales. T 5315 , F 23, S 8, H SE 1799, I/A 69 (28.05.15).
05 de Junio de 2015Ampliación de capital. Suscrito: 4.500.000,00 Euros. Desembolsado: 4.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 86.209.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 86.209.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital.- 5. Capital.-. 6.Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 5315 , F 23, S 8, H SE 1799, I/A 70 (28.05.15).
19 de Febrero de 2015Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 5315 , F 23, S 8, H SE 1799, I/A 68 (11.02.15).
14 de Agosto de 2014Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ-OSSORIO RAMOS IGNACIO;RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE MARIA. Datos registrales.T 5315 , F 22, S 8, H SE 1799, I/A 67 ( 4.08.14).
02 de Julio de 2014Otros conceptos: se amplian la facultades dispositivas del Consejero Delegado Don Miguel Angel Paneque Sosa.- Datosregistrales. T 5315 , F 21, S 8, H SE 1799, I/A 66 (25.06.14).
18 de Diciembre de 2013Ampliación de capital. Suscrito: 5.257.000,00 Euros. Desembolsado: 5.257.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 81.709.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 81.709.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital.-.6. Numeraciónde lasacciones.. Datos registrales. T 5315 , F 21, S 8, H SE 1799, I/A 65 (11.12.13).
13 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ TORRES MANUEL FRANCISCO;ZAFRA MENGUAL ROSA MARIA. Otros conceptos: LaSociedad REVOCA el PODER NO INSCRITO, conferido a favor de DON JOSE LUIS GARRATON JULIA, en escritura otorgada enSevilla, el día trece de julio de dos mil once, ante el NotarioDon Javier Feás Costilla, número 104 de su protocol.-o. Datos registrales.T 5315 , F 18, S 8, H SE 1799, I/A 60 ( 2.12.13).
Nombramientos. Apoderado: LASSO DE LA VEGA MACHO JAVIER. Datos registrales. T 5315 , F 18, S 8, H SE 1799, I/A 61 (3.12.13).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ TORRES MANUEL FRANCISCO. Datos registrales. T 5315 , F 19, S 8, H SE 1799, I/A 62( 3.12.13).
Nombramientos. Apoderado: ZAFRA MENGUAL ROSA MARIA. Datos registrales. T 5315 , F 19, S 8, H SE 1799, I/A 63 ( 3.12.13).
Nombramientos. Apoderado: GARRATON JULIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 5315 , F 20, S 8, H SE 1799, I/A 64 ( 3.12.13).
22 de Julio de 2013Revocaciones. Apoderado: CLAVERO SALVADOR JOSE;CLAVERO SALVADOR JOSE. Apo.Sol.: CLAVERO SALVADOR JOSE.Datos registrales. T 5315 , F 17, S 8, H SE 1799, I/A 59 (15.07.13).
26 de Abril de 2013Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 5315 , F 17, S 8, H SE 1799, I/A 58 (15.04.13).
08 de Marzo de 2013Ampliación de capital. Suscrito: 5.000.000,00 Euros. Desembolsado: 5.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 76.452.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 76.452.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: MODIFICADOS LOSARTICULO 5º Y 6ºDE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- . Datos registrales. T 5315 , F 16, S 8, H SE 1799, I/A 57 (26.02.13).
05 de Febrero de 2013Modificaciones estatutarias. 19. Funcionamiento Junta Gral.-.32. Administración y Representacion.-. Datos registrales. T 5315 , F15, S 8, H SE 1799, I/A 56 (29.01.13).
25 de Enero de 2013Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.redlogisticadeandalucia.es. Datos registrales. T 5315 , F14, S 8, H SE 1799, I/A 53 ( 1.06.12).
05 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: SALGUEIRO CARMONA JOSE. Presidente: SALGUEIRO CARMONA JOSE. Vicepresid.: SERGIOMORENO MONROVE. Consejero: SERGIO MORENO MONROVE. Con.Delegado: SERGIO MORENO MONROVE. Consejero:LOPEZ PEREZ JOSEFA;FERNANDEZ NAVARRO DANIEL. Nombramientos. Consejero: GARCIA CEBRIAN JOSE ANTONIO.Presidente: GARCIA CEBRIAN JOSE ANTONIO. Consejero: PANEQUE SOSA MIGUEL ANGEL. Vicepresid.: PANEQUE SOSAMIGUEL ANGEL. Co.De.Ma.So: PANEQUE SOSA MIGUEL ANGEL. Consejero: ORDOÑEZ FERNANDEZ JOSE LUIS;RODRIGUEZGUTIERREZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 5315 , F 15, S 8, H SE 1799, I/A 55 (23.10.12).
25 de Junio de 2012Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. AVDA SAN FRANCISCOJAVIER 20 2& - SEDE DE LA AGENC (SEVILLA). Datos registrales. T 5315 , F 14, S 8, H SE 1799, I/A 54 (13.06.12).
03 de Febrero de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ-OSSORIO RAMOS IGNACIO;RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE MARIA. Modificacionesestatutarias. 2. También modifica el apartado primero del Artículo 35º de los Estatutos Sociales.- . Datos registrales. T 5315 , F 13,S 8, H SE 1799, I/A 51 (24.01.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: REBOLLO PUIG ANGEL. Datos registrales. T 5315 , F 14, S 8, H SE 1799, I/A 52 (24.01.12).
11 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: BERJANO ARENADO JOSE MANUEL. Consejero: CLAVERO SALVADOR JOSE;SANTANA DABRIOSALUD. Presidente: SANTANA DABRIO SALUD. Consejero: SALGUEIRO CARMONA JOSE. Vicepresid.: SALGUEIRO CARMONAJOSE. Consejero: ALVAREZ-OSSORIO RAMOS IGNACIO;MOLINA ROMERO MARIA ENCARNACION. Nombramientos.SecreNoConsj: RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE MARIA. VsecrNoConsj: DE LA TORRE LOPEZ ANA ISABEL. D. Gerente: ALVAREZ-OSSORIO RAMOS IGNACIO. Apo.Man.Soli: SANCHEZ CASTAÑO ONOFRE. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE MARIA.Consejero: SALGUEIRO CARMONA JOSE;SERGIO MORENO MONROVE;ALVAREZ-OSSORIO RAMOS IGNACIO;MORON LEDROMANUEL;FERNANDEZ NAVARRO DANIEL;LOPEZ PEREZ JOSEFA;MOLINA ROMERO MARIA ENCARNACION;REBOLLO PUIGANGEL;AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA;AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS;AGENCIA DEINNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA. Apo.Manc.: LINARES FERNANDEZ FERNANDO. Apo.Sol.: ZAFRA MENGUALROSA MARIA;CLAVERO SALVADOR JOSE;MARTINEZ TORRES MANUEL FRANCISCO.Presidente: SALGUEIRO CARMONAJOSE. Vicepresid.: SERGIO MORENO MONROVE. Con.Delegado: SERGIO MORENO MONROVE. Datos registrales. T 5315 , F 7,S 8, H SE 1799, I/A 48 (25.02.11).