Buscador CIF Logo

Actos BORME Redext Imagen Digital Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Redext Imagen Digital Sl

Actos BORME Redext Imagen Digital Sl - B84781566

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Redext Imagen Digital Sl con CIF B84781566

馃敊 Perfil de Redext Imagen Digital Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Redext Imagen Digital Sl

17 de Julio de 2023
Nombramientos. Adm. Solid.: ALLARD PHILIP HENRIK. Datos registrales. T 23170 , F 223, S 8, H M 415242, I/A 23 (10.07.23).

Revocaciones. Apo.Sol.: VAREZ GONZALEZ PEDRO. Apoderado: DURAN RUIZ JOSE LUIS;VAREZ GONZALEZ PEDRO;ORTIZDE URBINA GUTIERREZ GONZALO;VAREZ GONZALEZ PEDRO. Nombramientos. Apoderado: VAREZ GONZALEZPEDRO;MU脩OZ CAMACHO JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 23170 , F 223, S 8, H M 415242, I/A 24 (10.07.23).

07 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: CASAS THIO JORDI;TORRAS DE LA SERNA PATRICIA;BOIX POU ANA;LAO MARZOMARTA;GARCIA VIVES SANTIAGO;MUR ROCAFORT ANA. Datos registrales. T 23170 , F 222, S 8, H M 415242, I/A 21 (28.10.22).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTGOMERY JEFFREY DAVIS;DURAN RUIZ JOSE LUIS;GREEN TIMOTHY SIMON;TALBOTJEAN SEBASTIEN ROMAIN;VAREZ GONZALEZ PEDRO. Presidente: DURAN RUIZ JOSE LUIS. Secretario: VAREZ GONZALEZPEDRO. Nombramientos. Adm. Solid.: COX DAMIAN;LYN SMITH JENNIFER;CHANDLER JONATHAN. Otros conceptos: Cambiodel Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 23170 , F 223, S 8, H M415242, I/A 22 (28.10.22).

21 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apoderado: DOMINGUEZ CONCEJERO EVA. Apo.Sol.: DOMINGUEZ CONCEJERO EVA. Datos registrales. T23170 , F 222, S 8, H M 415242, I/A 20 (14.02.22).

07 de Abril de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: DE JUAN GALA CARMEN. Datos registrales. T 23170 , F 222, S 8, H M 415242, I/A 19 (29.03.21).

13 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: DE JUAN GALA CARMEN;DOMINGUEZ CONCEJERO EVA. Datos registrales. T 23170 , F 221, S 8, HM 415242, I/A 18 ( 6.03.20).

06 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apoderado: VAREZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 23170 , F 221, S 8, H M 415242, I/A 17 (31.01.20).

22 de Diciembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: SANJUAN LANSAC RAQUEL;SANJUAN LANSAC RAQUEL. Nombramientos. Apoderado:DOMINGUEZ CONCEJERO EVA. Datos registrales. T 23170 , F 220, S 8, H M 415242, I/A 16 (14.12.16).

10 de Marzo de 2016
Nombramientos. Apoderado: ORTIZ DE URBINA GUTIERREZ GONZALO. Datos registrales. T 23170 , F 220, S 8, H M 415242,I/A 15 ( 2.03.16).

01 de Marzo de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ DE LEON COTONER ANTONIO. SecreNoConsj: VAREZ GONZALEZ PEDRO. Presidente:SANCHEZ DE LEON COTONER ANTONIO. Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ DE LEON COTONER ANTONIO;SANTOS SANJULIAN CARLOS JOSE. Nombramientos. Consejero: VAREZ GONZALEZ PEDRO. Presidente: DURAN RUIZ JOSE LUIS.Secretario: VAREZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 23170 , F 40, S 8, H M 415242, I/A 13 (23.02.16).

Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. AVDA DE LOS PIRINEOS 7 2 -OFICINA 1 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES). Datos registrales. T 23170 , F 220, S 8, H M 415242, I/A 14 (23.02.16).

16 de Enero de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: FRANSSEN STEFAN. Nombramientos. Consejero: TALBOT JEAN SEBASTIEN ROMAIN. Datosregistrales. T 23170 , F 40, S 8, H M 415242, I/A 12 ( 9.01.15).

28 de Abril de 2014
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ DE LEON COTONER ANTONIO;DURAN RUIZ JOSE LUIS;VAREZ GONZALEZPEDRO;SANJUAN LANSAC RAQUEL;SANTOS SAN JULIAN CARLOS JOSE. Datos registrales. T 23170 , F 37, S 8, H M 415242,I/A 10 (11.04.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n