Actos BORME de Redur Malaga Sa
21 de Julio de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLALOBOS GUERRERO GABRIEL. Presidente: VILLALOBOS GUERRERO GABRIEL.Cons.Del.Sol: VILLALOBOS GUERRERO GABRIEL. Nombramientos. Consejero: GABIMA PARTICIPADAS SL. Presidente:GABIMA PARTICIPADAS SL. Cons.Del.Sol: GABIMA PARTICIPADAS SL. Datos registrales. T 5520, L 4427, F 34, S 8, H MA 8241,I/A 23 (12.07.23).
08 de Noviembre de 2022Reelecciones. Consejero: VILLALOBOS GUERRERO GABRIEL;ORDO脩EZ GARCIA MARGARITA;VAZQUEZ BLASCO ANGELAMARINA;LOZANO VAZQUEZ ANGEL ALBERTO. Presidente: VILLALOBOS GUERRERO GABRIEL. Secretario: ORDO脩EZ GARCIAMARGARITA. Cons.Del.Sol: VILLALOBOS GUERRERO GABRIEL;VAZQUEZ BLASCO ANGELA MARINA. Datos registrales. T5520, L 4427, F 34, S 8, H MA 8241, I/A 22 (24.10.22).
23 de Junio de 2022Cambio de domicilio social. C/ FERNANDO SOR 4 (MALAGA). Datos registrales. T 5520, L 4427, F 33, S 8, H MA 8241, I/A 21(13.06.22).
22 de Febrero de 2022Reelecciones. Auditor: CARLOS FERNANDEZ AUDITORES S.L.P. Datos registrales. T 5520, L 4427, F 33, S 8, H MA 8241, I/A 20(10.02.22).
14 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: CARLOS FERNANDEZ AUDITORES S.L.P. Datos registrales. T 5520, L 4427, F 32, S 8, H MA 8241, I/A 17(28.12.18).
21 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLALOBOS GUERRERO GABRIEL. Presidente: VILLALOBOS GUERRERO GABRIEL. Consejero:ORDO脩EZ GARCIA MARGARITA. Secretario: ORDO脩EZ GARCIA MARGARITA. Consejero: VAZQUEZ BLASCO ANGELA MARINA.Cons.Del.Sol: VAZQUEZ BLASCO ANGELA MARINA. Consejero: LOZANO VAZQUEZ ANGEL ALBERTO. Cons.Del.Sol:VILLALOBOS GUERRERO GABRIEL. Nombramientos. Consejero: VILLALOBOS GUERRERO GABRIEL;ORDO脩EZ GARCIAMARGARITA;VAZQUEZ BLASCO ANGELA MARINA;LOZANO VAZQUEZ ANGEL ALBERTO. Presidente: VILLALOBOS GUERREROGABRIEL. Secretario: ORDO脩EZ GARCIA MARGARITA. Cons.Del.Sol: VILLALOBOS GUERRERO GABRIEL;VAZQUEZ BLASCOANGELA MARINA. Datos registrales. T 5520, L 4427, F 31, S 8, H MA 8241, I/A 16 (10.11.17).
15 de Marzo de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1,21 Euros. Resultante Suscrito: 60.100,00 Euros. Desembolso de dividendos pasivos.Desembolsado: 30.050,00 Euros. Datos registrales. T 5520, L 4427, F 31, S 8, H MA 8241, I/A 15 ( 7.03.17).
03 de Junio de 2016Otros conceptos: se modifican los articulos 11, 17 y 18 de los estatutos sociales y se dejan sin contenido los articulos 19 a 21inclusives. Datos registrales. T 1282, L 195, F 64, S 8, H MA 8241, I/A 14 (25.05.16).
31 de Mayo de 2016Nombramientos. Auditor: CARLOS FERNANDEZ AUDITORES S.L.P. Datos registrales. T 1282, L 195, F 64, S 8, H MA 8241, I/A13 (20.05.16).
27 de Marzo de 2015Ampliacion del objeto social. La gesti贸n de archivos documentales. Datos registrales. T 1282, L 195, F 64, S 8, H MA 8241, I/A 12(19.03.15).
26 de Diciembre de 2014Cambio de objeto social. El negocio de transportes, almacenaje y distribuci贸n de mercanc铆as en toda su amplitud, utilizando mediospropios y/o ajenos, e interviniendo como Agencia de Transportes, transitorio, consignatario, comisionista o mediador de toda clase deoperaciones o servicios relacionados con el transporte, alam. Datos registrales. T 1282, L 195, F 64, S 8, H MA 8241, I/A 11(17.12.14).
11 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLALOBOS GUERRERO GABRIEL. Presidente: VILLALOBOS GUERRERO GABRIEL.Cons.Del.Sol: VILLALOBOS GUERRERO GABRIEL. Consejero: ORDO脩EZ GARCIA MARGARITA. Secretario: ORDO脩EZ GARCIAMARGARITA. Consejero: VAZQUEZ BLASCO ANGELA MARINA. Cons.Del.Sol: VAZQUEZ BLASCO ANGELA MARINA. Consejero:LOZANO VAZQUEZ ANGEL ALBERTO. Nombramientos. Consejero: VILLALOBOS GUERRERO GABRIEL. Presidente:VILLALOBOS GUERRERO GABRIEL. Consejero: ORDO脩EZ GARCIA MARGARITA. Secretario: ORDO脩EZ GARCIA MARGARITA.Consejero: VAZQUEZ BLASCO ANGELA MARINA. Cons.Del.Sol: VAZQUEZ BLASCO ANGELA MARINA. Consejero: LOZANOVAZQUEZ ANGEL ALBERTO. Cons.Del.Sol: VILLALOBOS GUERRERO GABRIEL. Datos registrales. T 1282, L 195, F 64, S 8, HMA 8241, I/A 10 ( 3.04.13).