Buscador CIF Logo

Actos BORME Refresco Iberia Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Refresco Iberia Sa

Actos BORME Refresco Iberia Sa - A83745695

Tenemos registrados 64 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Refresco Iberia Sa con CIF A83745695

🔙 Perfil de Refresco Iberia Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Refresco Iberia Sa

27 de Diciembre de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 119, S 8, H V 101615, I/A 85 (19.12.23).

07 de Noviembre de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: SALVADOR PAVIA JONATHAN. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 117, S 8, H V 101615, I/A 82(30.10.23).

Nombramientos. Apo.Manc.: ALCOCER ROGER TERESA. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 117, S 8, H V 101615, I/A 83(30.10.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: CATALA CANET BORJA. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 118, S 8, H V 101615, I/A 84 (30.10.23).

30 de Octubre de 2023
Reelecciones. Adm. Unico: REFRESCO EUROPE BV. Otros conceptos: DON ROGER HUBERT MARIE SONNEVILLE con NIEnúmero M0254781X, ha sido designado persona fisica representante de la entidad "REFRESCO EUROPE B.V." que ha sido reelegidacomo administradora única de la sociedad de ésta hoja. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 117, S 8, H V 101615, I/A 81(23.10.23).

19 de Abril de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 117, S 8, H V 101615, I/A 80 (12.04.23).

31 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: TOVAR OSCAR EDUARDO. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 115, S 8, H V 101615, I/A 78(24.10.22).

17 de Octubre de 2022
Otros conceptos: D. Adee Monia Packer ha sido sustituido por Don Roger Hubert Marie Sonneville como representante delAdministrador único la mercantil REFRESCO EUROPE B.V, en la sociedad REFRESCO IBERIA SA. Datos registrales. T 10183, L7465, F 63, S 8, H V 101615, I/A 49 M ( 7.10.22).

04 de Abril de 2022
Fe de erratas: Los datos correctos de inscripción son: TOMO 10.529 LIBRO 7.810 FOLIO 112 INSCRIPCION 76, y no los que porerror se publicaron en el Boletín 51 de fecha 15/03/22 y referencia 01146892022. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 112, S 8, H V101615, I/A 76 ( 8.03.22).

Nombramientos. Apo.Manc.: PAISAN RUIZ LUIS. Apo.Sol.: PAISAN RUIZ LUIS. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 112, S 8, HV 101615, I/A 77 (28.03.22).

15 de Marzo de 2022
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 5.- Capital social.. Otros conceptos: Se decide la emisión de un título múltiplenominativo, a favor del Accionista Unico de la sociedad. Dicho título representará la totalidad del capital social, 4.982.336 Euros,representado por 4.982.336 acciones nominativas de 1 euro de valor nominal cada una, de una sola clase y serie. Datos registrales.T 10183, L 7465, F 112, S 8, H V 101615, I/A 76 ( 8.03.22).

08 de Marzo de 2022
Otros conceptos: Don Aart Cornelis Duijzer persona física representante del Administrador Unico la mercantil "REFRESCO EUROPEBV" con NIF 28098370, ha sido sustituido por DON ADEE MONIA PACKER, con NIE número Y9300748-E. Datos registrales. T10183, L 7465, F 64, S 8, H V 101615, I/A 49 A ( 1.03.22).

07 de Marzo de 2022
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 112, S 8, H V 101615, I/A 74 (28.02.22).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 112, S 8, H V 101615, I/A 75 (28.02.22).

14 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: DE CASTRO GONZALEZ ALVARO. Apo.Sol.: DE CASTRO GONZALEZ ALVARO. Apo.Manc.: DECASTRO GONZALEZ ALVARO. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 112, S 8, H V 101615, I/A 73 ( 7.02.22).

29 de Abril de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: ASUNCION MASIA MARIA JESUS;ASUNCION MASIA MARIA JESUS. Apo.Sol.: ASUNCION MASIAMARIA JESUS;ASUNCION MASIA MARIA JESUS. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 111, S 8, H V 101615, I/A 72 (22.04.21).

25 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: SALVADOR PAVIA JONATHAN. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 110, S 8, H V 101615, I/A 71(18.02.21).

16 de Diciembre de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GUAITA BACHILLER PATRICIA. Nombramientos. Apo.Sol.: CISNEROS PABLO ANGEL LUIS.Apo.Manc.: CISNEROS PABLO ANGEL LUIS. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 110, S 8, H V 101615, I/A 70 ( 9.12.20).

16 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apo.Manc.: REIG CALDERON MARIA. Apoderado: REIG CALDERON MARIA. Datos registrales. T 10529, L 7810,F 109, S 8, H V 101615, I/A 69 ( 9.11.20).

02 de Junio de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: VAZQUEZ GOMEZ RAFAEL;ATAUN ARMENDARIZ JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 10529, L7810, F 108, S 8, H V 101615, I/A 68 (26.05.20).

16 de Abril de 2020
Fe de erratas: Los datos correctos de la inscripción 67 son: TOMO 10529 LIBRO 7810 FOLIO 107, no los que por error se publicaronen el Boletín 63 de fecha 31/03/20 y referencia 01371172020. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 107, S 8, H V 101615, I/A 67(24.03.20).

31 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUAITA BACHILLER PATRICIA. Datos registrales. T 10183, L 7465, F 107, S 8, H V 101615, I/A67 (24.03.20).

12 de Febrero de 2020
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 10183, L 7465, F 107, S 8, H V 101615, I/A 66 ( 5.02.20).

13 de Noviembre de 2019
Otros conceptos: La sociedad "REFRESCO BV" con NIF 28098370, administradora única y socia única de la mercantil "REFRESCOIBERIA SA" con CIF A83745695, ha cambiado su denominación por la de "REFRESCO EUROPE BV". Datos registrales. T 10183, L7465, F 63, S 8, H V 101615, I/A 49M ( 6.11.19).

20 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ GASPAR JOSE LUIS;PEREZ AMURRIO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T10529, L 7810, F 107, S 8, H V 101615, I/A 65 (10.05.19).

03 de Abril de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: BELLVER PORTA MACARENA. Nombramientos. Apo.Sol.: ASUNCION MASIA MARIA JESUS.Apo.Manc.: ASUNCION MASIA MARIA JESUS;ASUNCION MASIA MARIA JESUS. Apo.Sol.: ASUNCION MASIA MARIA JESUS.Apo.Manc.: PENALBA FUSTER LAURA PATRICIA. Apo.Sol.: CASTELLO GINESTAR LILIANA;PENALBA FUSTER LAURA PATRICIA.Datos registrales. T 10529, L 7810, F 104, S 8, H V 101615, I/A 64 (27.03.19).

25 de Marzo de 2019
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 104, S 8, H V 101615, I/A 63 (18.03.19).

03 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apoderado: ESTEPA ALMODOVAR JOSE MARIA. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 103, S 8, H V 101615,I/A 62 (26.09.18).

21 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: GREGORI COLOM SUSANNA. Datos registrales. T 10183, L 7465, F 70, S 8, H V 101615, I/A 60(14.09.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: UNZALU AUSIN IGOR. Apo.Manc.: UNZALU AUSIN IGOR;UNZALU AUSIN IGOR. Apo.Sol.: UNZALUAUSIN IGOR. Datos registrales. T 10529, L 7810, F 101, S 8, H V 101615, I/A 61 (14.09.18).

12 de Junio de 2018
Revocaciones. Apo.Manc.: AMAT IBAÑEZ MANUEL;DE CASTRO GONZALEZ ALVARO;CASTELLO GINESTAR LILIANA;TOMASCRESPO ISMAEL;REIG CALDERON MARIA. Apoderado: REIG CALDERON MARIA. Datos registrales. T 10183, L 7465, F 69, S 8,H V 101615, I/A 58 ( 5.06.18).

Nombramientos. Apo.Manc.: AMAT IBAÑEZ MANUEL;DE CASTRO GONZALEZ ALVARO;CASTELLO GINESTAR LILIANA;TOMASCRESPO ISMAEL;REIG CALDERON MARIA;BELLVER PORTA MACARENA. Apoderado: REIG CALDERON MARIA. Datosregistrales. T 10183, L 7465, F 69, S 8, H V 101615, I/A 59 ( 5.06.18).

28 de Marzo de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: DE CASTRO GONZALEZ ALVARO;CASTELLO GINESTAR LILIANA;MIRET ROMAN JUAN JOSE;DECASTRO GONZALEZ ALVARO;CASTELLO GINESTAR LILIANA. Apo.Manc.: AMAT IBAÑEZ MANUEL;DE CASTRO GONZALEZALVARO;CASTELLO GINESTAR LILIANA;MIRET ROMAN JUAN JOSE;TOMAS CRESPO ISMAEL. Apo.Sol.: MIRET ROMAN JUANJOSE. Datos registrales. T 10183, L 7465, F 68, S 8, H V 101615, I/A 56 (21.03.18).

Nombramientos. Apo.Manc.: AMAT IBAÑEZ MANUEL;DE CASTRO GONZALEZ ALVARO;CASTELLO GINESTAR LILIANA;TOMASCRESPO ISMAEL;REIG CALDERON MARIA. Apoderado: REIG CALDERON MARIA. Datos registrales. T 10183, L 7465, F 68, S 8,H V 101615, I/A 57 (21.03.18).

18 de Enero de 2018
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 10183, L 7465, F 67, S 8, H V 101615, I/A 55 (11.01.18).

21 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: RODRIGUEZ SOLANES VICENT. Apo.Sol.: RODRIGUEZ SOLANES VICENT. Datos registrales. T10183, L 7465, F 66, S 8, H V 101615, I/A 53 (14.11.17).

Nombramientos. Apoderado: CASTELLO LLORET PEDRO FIDEL. Datos registrales. T 10183, L 7465, F 66, S 8, H V 101615, I/A54 (14.11.17).

30 de Octubre de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: REFRESCO BV. Nombramientos. Adm. Unico: REFRESCO BV. Otros conceptos: A los efectosdel Art. 143 del RRM la persona física designada por la Entidad "REFRESCO BV", para que la represente en el desempeño de lasfunciones como ADMINISTRADOR UNICO es Don Aart Cornelis Duijzer, con NIE X-09555917-S. Datos registrales. T 10183, L 7465,F 63, S 8, H V 101615, I/A 49 (23.10.17).

Revocaciones. Apo.Manc.: PAÑOS MANGRANE ANTONIO;AMAT IBAÑEZ MANUEL;DE CASTRO GONZALEZALVARO;CASTELLO GINESTAR LILIANA;MIRET ROMAN JUAN JOSE. Apo.Sol.: MIRET ROMAN JUAN JOSE;RODRIGUEZSOLANES VICENT. Apo.Manc.: RODRIGUEZ SOLANES VICENT. Apo.Sol.: PAÑOS MANGRANE ANTONIO. Apo.Manc.: PAÑOSMANGRANE ANTONIO. Apo.Sol.: AMAT IBAÑEZ MANUEL. Apo.Manc.: AMAT IBAÑEZ MANUEL;DE CASTRO GONZALEZALVARO;CASTELLO GINESTAR LILIANA. Modificación de poderes. Apo.Sol.: CASTELLO GINESTAR LILIANA;DE CASTROGONZALEZ ALVARO. Datos registrales. T 10183, L 7465, F 64, S 8, H V 101615, I/A 50 (23.10.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: AMAT IBAÑEZ MANUEL;DE CASTRO GONZALEZ ALVARO;CASTELLO GINESTAR LILIANA;TOMASCRESPO ISMAEL. Apo.Manc.: AMAT IBAÑEZ MANUEL;DE CASTRO GONZALEZ ALVARO;CASTELLO GINESTAR LILIANA;TOMASCRESPO ISMAEL. Datos registrales. T 10183, L 7465, F 64, S 8, H V 101615, I/A 51 (23.10.17).

Nombramientos. Apo.Manc.: AMAT IBAÑEZ MANUEL;DE CASTRO GONZALEZ ALVARO;CASTELLO GINESTAR LILIANA;MIRETROMAN JUAN JOSE;RODRIGUEZ SOLANES VICENT;TOMAS CRESPO ISMAEL. Apo.Sol.: MIRET ROMAN JUANJOSE;RODRIGUEZ SOLANES VICENT. Datos registrales. T 10183, L 7465, F 65, S 8, H V 101615, I/A 52 (23.10.17).

07 de Septiembre de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: PAÑOS MANGRANE ANTONIO;AMAT IBAÑEZ MANUEL;DE CASTRO GONZALEZALVARO;CASTELLO GINESTAR LILIANA;MIRET ROMAN JUAN JOSE. Apo.Sol.: DE CASTRO GONZALEZ ALVARO;MIRETROMAN JUAN JOSE. Apo.Manc.: PAÑOS MANGRANE ANTONIO. Apo.Sol.: PAÑOS MANGRANE ANTONIO;AMAT IBAÑEZMANUEL. Apo.Manc.: AMAT IBAÑEZ MANUEL. Modificación de poderes. Apo.Sol.: DE CASTRO GONZALEZALVARO;CASTELLO GINESTAR LILIANA;MIRET ROMAN JUAN JOSE. Datos registrales. T 10183, L 7465, F 61, S 8, H V 101615,I/A 46 (31.08.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: PAÑOS MANGRANE ANTONIO;AMAT IBAÑEZ MANUEL;DE CASTRO GONZALEZ ALVARO;CASTELLOGINESTAR LILIANA. Apo.Manc.: PAÑOS MANGRANE ANTONIO;AMAT IBAÑEZ MANUEL;DE CASTRO GONZALEZALVARO;CASTELLO GINESTAR LILIANA. Datos registrales. T 10183, L 7465, F 61, S 8, H V 101615, I/A 47 (31.08.17).

Nombramientos. Apo.Manc.: PAÑOS MANGRANE ANTONIO;AMAT IBAÑEZ MANUEL;DE CASTRO GONZALEZALVARO;CASTELLO GINESTAR LILIANA;MIRET ROMAN JUAN JOSE;RODRIGUEZ SOLANES VICENT. Apo.Sol.: MIRET ROMANJUAN JOSE;RODRIGUEZ SOLANES VICENT. Datos registrales. T 10183, L 7465, F 62, S 8, H V 101615, I/A 48 (31.08.17).

20 de Julio de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: HERRAIZ VENANCIO JOSE MANUEL;HERRAIZ VENANCIO JOSE MANUEL. Apo.Sol.: HERRAIZ

27 de Octubre de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: BLASCO SALVADOR DARIO;BLASCO SALVADOR DARIO. Apo.Sol.: BLASCO SALVADOR DARIO.Apo.Manc.: PAÑOS MANGRANE ANTONIO;AMAT IBAÑEZ MANUEL;HERRAIZ VENANCIO JOSE MANUEL;DE CASTROGONZALEZ ALVARO;MIRET ROMAN JUAN JOSE. Datos registrales. T 8934, L 6219, F 193, S 8, H V 101615, I/A 43 (20.10.16).

Nombramientos. Apo.Manc.: PAÑOS MANGRANE ANTONIO;AMAT IBAÑEZ MANUEL;HERRAIZ VENANCIO JOSE MANUEL;DECASTRO GONZALEZ ALVARO;CASTELLO GINESTAR LILIANA;MIRET ROMAN JUAN JOSE. Apo.Sol.: DE CASTRO GONZALEZALVARO;CASTELLO GINESTAR LILIANA;MIRET ROMAN JUAN JOSE. Datos registrales. T 10183, L 7465, F 60, S 8, H V 101615,I/A 44 (20.10.16).

25 de Febrero de 2016
Fe de erratas: Por error no se publicó la revocación de poder de D. Alvaro de Castro González y D. Luis Alberto Hernández Videla enel Boletín 243 de fecha 22/12/15 y referencia 05191432015. Datos registrales. T 8934, L 6219, F 193, S 8, H V 101615, I/A 41(15.12.15).

Revocaciones. Apo.Sol.: DE CASTRO GONZALEZ ALVARO;HERNANDEZ VIDELA LUIS ALBERTO;MIRET ROMAN JUAN JOSE.Apo.Manc.: HERNANDEZ VIDELA LUIS ALBERTO. Apo.Sol.: HERNANDEZ VIDELA LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 8934, L6219, F 193, S 8, H V 101615, I/A 42 (18.02.16).

22 de Diciembre de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: DE CASTRO GONZALEZ ALVARO;HERNANDEZ VIDELA LUIS ALBERTO. Apo.Manc.: PAÑOSMANGRANE ANTONIO. Apo.Sol.: PAÑOS MANGRANE ANTONIO. Apo.Manc.: AMAT IBAÑEZ MANUEL. Apo.Sol.: AMAT IBAÑEZMANUEL. Apo.Manc.: HERRAIZ VENANCIO JOSE MANUEL. Apo.Sol.: HERRAIZ VENANCIO JOSE MANUEL. Apo.Manc.: PAÑOSMANGRANE ANTONIO;AMAT IBAÑEZ MANUEL;HERRAIZ VENANCIO JOSE MANUEL;DE CASTRO GONZALEZALVARO;HERNANDEZ VIDELA LUIS ALBERTO;MIRET ROMAN JUAN JOSE. Datos registrales. T 8934, L 6219, F 193, S 8, H V101615, I/A 41 (15.12.15).

21 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: PAÑOS MANGRANE ANTONIO;AMAT IBAÑEZ MANUEL;HERRAIZ VENANCIO JOSEMANUEL;BLASCO SALVADOR DARIO;DE CASTRO GONZALEZ ALVARO;HERNANDEZ VIDELA LUIS ALBERTO;MIRET ROMANJUAN JOSE. Apo.Sol.: DE CASTRO GONZALEZ ALVARO;HERNANDEZ VIDELA LUIS ALBERTO;MIRET ROMAN JUAN JOSE.Datos registrales. T 8934, L 6219, F 133, S 8, H V 101615, I/A 39 (14.12.15).

Nombramientos. Apo.Manc.: PAÑOS MANGRANE ANTONIO;AMAT IBAÑEZ MANUEL;HERRAIZ VENANCIO JOSEMANUEL;BLASCO SALVADOR DARIO. Apo.Sol.: PAÑOS MANGRANE ANTONIO;AMAT IBAÑEZ MANUEL;HERRAIZ VENANCIOJOSE MANUEL;BLASCO SALVADOR DARIO. Datos registrales. T 8934, L 6219, F 191, S 8, H V 101615, I/A 40 (14.12.15).

21 de Octubre de 2015
Nombramientos. Apoderado: PEREZ AMURRIO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 8934, L 6219, F 133, S 8, H V 101615,I/A 38 (14.10.15).

18 de Septiembre de 2015
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ CEBRIAN ANDRES. Datos registrales. T 8934, L 6219, F 133, S 8, H V 101615, I/A 37(11.09.15).

22 de Mayo de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: LUNA TUDELA DOMINIQUE FRANCISCO. Apo.Manc.: LUNA TUDELA DOMINIQUE FRANCISCO;LUNATUDELA DOMINIQUE FRANCISCO. Datos registrales. T 8934, L 6219, F 132, S 8, H V 101615, I/A 36 (14.05.15).

23 de Octubre de 2014
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 8934, L 6219, F 132, S 8, H V 101615, I/A 35 (16.10.14).

15 de Enero de 2014
Nombramientos. Apo.Manc.: LUNA TUDELA DOMINIQUE FRANCISCO;PAÑOS MANGRANE ANTONIO;AMAT IBAÑEZMANUEL;HERRAIZ VENANCIO JOSE MANUEL. Apoderado: DE CASTRO GONZALEZ ALVARO;HERNANDEZ VIDELA LUISALBERTO;MIRET ROMAN JUAN JOSE. Datos registrales. T 8934, L 6219, F 131, S 8, H V 101615, I/A 33 ( 8.01.14).

Revocaciones. Apo.Manc.: LUNA TUDELA DOMINIQUE FRANCISCO;PAÑOS MANGRANE ANTONIO;AMAT IBAÑEZMANUEL;HERRAIZ VENANCIO JOSE MANUEL;DE CASTRO GONZALEZ ALVARO;HERNANDEZ VIDELA LUIS ALBERTO. Datosregistrales. T 8934, L 6219, F 131, S 8, H V 101615, I/A 34 ( 8.01.14).

25 de Noviembre de 2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SL. Datos registrales. T 8934, L 6219, F 131, S 8, H V 101615, I/A 32(18.11.13).

06 de Junio de 2013
Revocaciones. Apo.Manc.: DE CASTRO GONZALEZ ALVARO;HERNANDEZ VIDELA LUIS ALBERTO;LUNA TUDELA DOMINIQUEFRANCISCO;PAÑOS MANGRANE ANTONIO;AMAT IBAÑEZ MANUEL;HERRAIZ VENANCIO JOSE MANUEL. Apoderado: LUNATUDELA DOMINIQUE FRANCISCO;PAÑOS MANGRANE ANTONIO;AMAT IBAÑEZ MANUEL;HERRAIZ VENANCIO JOSE MANUEL.Datos registrales. T 8933, L 6218, F 92, S 8, H V 101615, I/A 29 (30.05.13).

Nombramientos. Apo.Manc.: LUNA TUDELA DOMINIQUE FRANCISCO;PAÑOS MANGRANE ANTONIO;AMAT IBAÑEZMANUEL;HERRAIZ VENANCIO JOSE MANUEL;DE CASTRO GONZALEZ ALVARO;HERNANDEZ VIDELA LUIS ALBERTO. Apo.Sol.:DE CASTRO GONZALEZ ALVARO;HERNANDEZ VIDELA LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 8933, L 6218, F 92, S 8, H V101615, I/A 30 (30.05.13).

Nombramientos. Apo.Sol.: LUNA TUDELA DOMINIQUE FRANCISCO;PAÑOS MANGRANE ANTONIO;AMAT IBAÑEZMANUEL;HERRAIZ VENANCIO JOSE MANUEL. Apo.Manc.: LUNA TUDELA DOMINIQUE FRANCISCO;PAÑOS MANGRANEANTONIO;AMAT IBAÑEZ MANUEL;HERRAIZ VENANCIO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 8934, L 6219, F 130, S 8, H V101615, I/A 31 (30.05.13).

12 de Abril de 2012
Revocaciones. Apoderado: RICOU FUSTAGUERAS JORDI. Apo.Manc.: RICOU FUSTAGUERAS JORDI. Apoderado: GARCIA DELHOYO VICENTE;PARTAL SAMPE MIGUEL. Datos registrales. T 8933, L 6218, F 91, S 8, H V 101615, I/A 28 (30.03.12).

07 de Marzo de 2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SL. Datos registrales. T 8933, L 6218, F 89, S 8, H V 101615, I/A 27(27.02.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información