Buscador CIF Logo

Actos BORME Regal Beloit Spain Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Regal Beloit Spain Sa

Actos BORME Regal Beloit Spain Sa - A20034278

Tenemos registrados 16 Actos BORME del Registro Mercantil de Guipuzcoa para Regal Beloit Spain Sa con CIF A20034278

🔙 Perfil de Regal Beloit Spain Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Guipuzcoa

Actos BORME de Regal Beloit Spain Sa

03 de Marzo de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: MORTON JERRALD RAY;MANZONI MARCO. SecreNoConsj: DE HAAN JAN WILLEM. Presidente:MORTON JERRALD RAY. Vicesecret.: MANZONI MARCO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: CALVO GOLDARACENA JUANANTONIO. Apo.Sol.: MORTON JERRALD RAY. Nombramientos. Consejero: GREVING JORG STEFAN;BASU GARIMA. Presidente:BASU GARIMA. Secretario: GREVING JORG STEFAN. Reelecciones. Vicepresid.: VALENTINO MASSIMILIANO DEMETRIO.Datos registrales. T 2934 , F 3, S 8, H SS 3574, I/A 57 (21.02.23).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2934 , F 3, S 8, H SS 3574, I/A 58 (21.02.23).

Nombramientos. Apoderado: RODL & PARTNER ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP. Datos registrales. T 2934 , F 3,S 8, H SS 3574, I/A 56 (21.02.23).

01 de Julio de 2022
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: ROTOR BEHEER BV. Datos registrales. T 2934 , F 2, S 8, H SS3574, I/A 55 (23.06.22).

08 de Octubre de 2020
Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: GREENSBURG SL. Datos registrales. T 2934 , F 1, S 8, H SS 3574, I/A 54(30.09.20).

24 de Junio de 2020
Otros conceptos: Modificación de los párrafos 3º y 4º del Artículo 18º de los Estatutos Sociales, referente a la forma de regir laSociedad. Datos registrales. T 2934 , F 1, S 8, H SS 3574, I/A 53 (11.06.20).

30 de Enero de 2020
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2934 , F 1, S 8, H SS 3574, I/A 52 (21.01.20).

07 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: CHARLES RONALD JOSEPH. Vicesecret.: CHARLES RONALD JOSEPH. Nombramientos.Consejero: MANZONI MARCO. Vicesecret.: MANZONI MARCO. Datos registrales. T 1175 , F 113, S 8, H SS 3574, I/A 51 (29.05.19).

31 de Enero de 2019
Nombramientos. Con.Delegado: VALENTINO MASSIMILIANO DEMETRIO. Reelecciones. Consejero: VALENTINOMASSIMILIANO DEMETRIO. Vicepresid.: VALENTINO MASSIMILIANO DEMETRIO. Datos registrales. T 1175 , F 113, S 8, H SS3574, I/A 49 (22.01.19).

Nombramientos. Apoderado: BREGON CAMPOS PETULIA. Datos registrales. T 1175 , F 113, S 8, H SS 3574, I/A 50 (22.01.19).

15 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Presidente: PAJK ANTHONY EDWARD. Consejero: PAJK ANTHONY EDWARD. Nombramientos. Consejero:MORTON JERRALD RAY. Apo.Sol.: ERDMAN DANIEL THOMAS. Presidente: MORTON JERRALD RAY. Vicepresid.: VALENTINOMASSIMILIANO DEMETRIO. Apo.Sol.: HINRICHS CHARLES ALBERT;MORTON JERRALD RAY. Vicesecret.: CHARLES RONALDJOSEPH. Datos registrales. T 1175 , F 112, S 8, H SS 3574, I/A 48 ( 6.06.17).

19 de Agosto de 2016
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1175 , F 112, S 8, H SS 3574, I/A 47 (10.08.16).

02 de Junio de 2016
Ceses/Dimisiones. Secretario: TMF SOCIEDAD DE DIRECCION SL. Nombramientos. Secretario: DE HAAN JAN WILLEM. Datosregistrales. T 1175 , F 112, S 8, H SS 3574, I/A 46 (26.05.16).

30 de Marzo de 2016
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1175 , F 111, S 8, H SS 3574, I/A 43 (15.03.16).

Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 1175 , F 111, S 8, H SS 3574, I/A 44(15.03.16).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1175 , F 111, S 8, H SS 3574, I/A 45 (15.03.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información