Actos BORME de Rehabilitcat Sl
12 de Marzo de 2021Revocaciones. ADM.UNICO: TORRES SANCHEZ JULIO. Nombramientos. ADM.UNICO: ARQUES CINTAS SILVIA. Datosregistrales. T 44747 , F 47, S 8, H B 465207, I/A 9 ( 4.03.21).
Nombramientos. APODERAD.SOL: YAÑEZ GARCIA SERGIO;SAMPEDRO GONZALEZ VANESSA;TORRES SANCHEZ JULIO.Datos registrales. T 44747 , F 47, S 8, H B 465207, I/A 10 ( 4.03.21).
27 de Noviembre de 2019Cambio de domicilio social. CL VILAMARI 86-88 (BARCELONA). Datos registrales. T 44747 , F 46, S 8, H B 465207, I/A 8(19.11.19).
20 de Marzo de 2018Nombramientos. APODERAD.SOL: SAMPEDRO GONZALEZ VANESSA. Datos registrales. T 44747 , F 45, S 8, H B 465207, I/A 7(12.03.18).
06 de Marzo de 2018Nombramientos. ADM.UNICO: TORRES SANCHEZ JULIO. Cambio de domicilio social. CL ORIENTE NUM.78-84 EDIFICIOINBISA P.1 (SANT CUGAT DEL VALLES). Cambio de objeto social. LAS REFORMAS,REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEEDIFICIOS Y LA COMPRA VENTA DE INMUEBLES YA SEAN RUSTICOS O URBANOS. Datos registrales. T 44747 , F 45, S 8, H B465207, I/A 6 (27.02.18).
05 de Febrero de 2018Revocaciones. ADM.UNICO: YAÑEZ GARCIA SERGIO. Datos registrales. T 44747 , F 45, S 8, H B 465207, I/A 5 (29.01.18).