Actos BORME de Rehac Sa
21 de Abril de 2023Revocaciones. APODERAD.SOL: OSORIO MONTEJO JOAQUIN;ALONSO SANZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 47212 , F103, S 8, H B 23558, I/A 81 (13.04.23).
11 de Octubre de 2022Revocaciones. APODERAD.SOL: TRILLO ATAN JOSE LUIS. Datos registrales. T 47212 , F 103, S 8, H B 23558, I/A 80 ( 3.10.22).
10 de Marzo de 2022Nombramientos. AUDIT.INDIV.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 47212 , F 103, S 8, H B 23558, I/A 79 ( 3.03.22).
22 de Marzo de 2021Nombramientos. AUDIT.INDIV.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 47212 , F 102, S 8, H B 23558, I/A 78 (11.03.21).
26 de Noviembre de 2020Nombramientos. APOD.MANCOMU: ROMERO HERRADOR MARIA;ZAMORANO PALACIOS LUIS MIGUEL. Datos registrales. T47212 , F 102, S 8, H B 23558, I/A 77 (18.11.20).
19 de Febrero de 2020Revocaciones. APODERADO: TRILLO ATAN JOSE LUIS. Datos registrales. T 47212 , F 101, S 8, H B 23558, I/A 75 (12.02.20).
Nombramientos. APODERAD.SOL: MARIN LOZANO ALBERTO. Datos registrales. T 47212 , F 101, S 8, H B 23558, I/A 76(12.02.20).
04 de Febrero de 2020Revocaciones. APODERAD.SOL: RUIZ HERNANDEZ JOSE. Datos registrales. T 47212 , F 101, S 8, H B 23558, I/A 73 (28.01.20).
Nombramientos. APODERAD.SOL: ALONSO SANZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 47212 , F 101, S 8, H B 23558, I/A 74(28.01.20).
27 de Diciembre de 2019Nombramientos. ADM.UNICO: ROMERO GAMERO JUAN LUIS. Datos registrales. T 43511 , F 180, S 8, H B 23558, I/A 72(17.12.19).
11 de Junio de 2019Revocaciones. APOD.MANCOMU: GONZALEZ NAVARRO EDUARDO. Nombramientos. APOD.MANCOMU: BERASTEGUIGARCIA INMACULADA DE LOS DOLORES. Datos registrales. T 43511 , F 180, S 8, H B 23558, I/A 71 ( 3.06.19).
04 de Marzo de 2019Revocaciones. APODERAD.SOL: ROMERO GAMERO ISABEL MARIA. Datos registrales. T 43511 , F 179, S 8, H B 23558, I/A 69(21.02.19).
Revocaciones. APOD.MANCOMU: RODRIGUEZ MAS VICTOR. Nombramientos. APOD.MANCOMU: GONZALEZ NAVARROEDUARDO. Datos registrales. T 43511 , F 179, S 8, H B 23558, I/A 70 (21.02.19).
01 de Febrero de 2019Nombramientos. APOD.MANCOMU: ZAMORANO PALACIOS MIGUEL;CENCERRADO DOMINGUEZ ANNA;RODRIGUEZ MASVICTOR. Datos registrales. T 43511 , F 179, S 8, H B 23558, I/A 68 (24.01.19).
24 de Diciembre de 2018Nombramientos. AUDIT.INDIV.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 43511 , F 179, S 8, H B 23558, I/A 67 (14.12.18).
28 de Marzo de 2018Nombramientos. APODERAD.SOL: RUIZ HERNANDEZ JOSE. Datos registrales. T 43511 , F 178, S 8, H B 23558, I/A 66(21.03.18).
22 de Junio de 2016Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 356/2013, AUTOFIRME DE FECHA 20/05/2016, POR EL QUE SE CALIFICA EL CONCURSO COMO FORTUITO Y SE ARCHIVA LA PIEZA DECALIFICACION. Datos registrales. T 43511 , F 178, S 8, H B 23558, I/A 65 (14.06.16).
25 de Marzo de 2015Revocaciones. APODERADO: GRANDES GARCIA JOAN. Datos registrales. T 43511 , F 178, S 8, H B 23558, I/A 64 (16.03.15).
05 de Febrero de 2015Revocaciones. APODERADO: TRILLO ATAN JOSE LUIS. Datos registrales. T 43511 , F 174, S 8, H B 23558, I/A 57 (29.01.15).
Nombramientos. APODERAD.SOL: ROMERO GAMERO ISABEL MARIA. Datos registrales. T 43511 , F 174, S 8, H B 23558, I/A58 (29.01.15).
Nombramientos. APODERAD.SOL: OSORIO MONTEJO JOAQUIN. Datos registrales. T 43511 , F 175, S 8, H B 23558, I/A 59(29.01.15).
Nombramientos. APODERAD.SOL: URDA LUMBRERAS FRANCISCA. Datos registrales. T 43511 , F 176, S 8, H B 23558, I/A 60(29.01.15).
Nombramientos. APODERAD.SOL: ZAMORANO PALACIOS LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 43511 , F 176, S 8, H B 23558,I/A 61 (29.01.15).
Nombramientos. APODERAD.SOL: TRILLO ATAN JOSE LUIS. Datos registrales. T 43511 , F 177, S 8, H B 23558, I/A 62(29.01.15).
Nombramientos. APODERAD.SOL: ROCARRUIG GIL MARIA CARMEN. Datos registrales. T 43511 , F 177, S 8, H B 23558, I/A 63(29.01.15).
26 de Enero de 2015Revocaciones. ADM.UNICO: GASSIOT MATAS JOSEP. Nombramientos. ADM.UNICO: ROMERO GAMERO JUAN LUIS. Otrosconceptos: SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: ROMERO GAMERO SA. Cambio de domicilio social. CL OSONA,1,PARC DE NEGOCIS "MAS BLAU" (PRAT DE LLOBREGAT (EL)). Datos registrales. T 43511 , F 173, S 8, H B 23558, I/A 56(19.01.15).
07 de Enero de 2015Revocaciones. ADM.CONCURS.: LLULL CASANELLAS BASSOLS RAIMON. Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 7 DEBARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 356/2013, SENTENCIA FIRME DE FECHA 24/07/2014, APROBACIONDEL CONVENIO. Datos registrales. T 43511 , F 172, S 8, H B 23558, I/A 55 (29.12.14).
26 de Agosto de 2014Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDITIA INTERNATIONAL SL. Datos registrales. T 43511 , F 172, S 8, H B 23558, I/A 54(14.08.14).
19 de Julio de 2013Nombramientos. ADM.CONCURS.: LLULL CASANELLAS BASSOLS RAIMON. Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 7 DEBARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 356/2013, AUTO FIRME DE FECHA 04/06/2013,DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 43511 , F 171, S 8, H B 23558, I/A 53(12.07.13).
05 de Febrero de 2013Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: GASSIOT MATAS JOSEP;OKDA 2007 SL. REPR.143 RRM: TRILLO ATAN JOSE LUIS.Nombramientos. ADM.UNICO: GASSIOT MATAS JOSEP. Datos registrales. T 43511 , F 171, S 8, H B 23558, I/A 51 (28.01.13).
Revocaciones. APODERADO: GRANDES GARCIA JOAN. Datos registrales. T 43511 , F 171, S 8, H B 23558, I/A 52 (28.01.13).
11 de Enero de 2013Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 45.075,91 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 60.101,21Euros. Resultante Suscrito: 540.910,89 Euros. Datos registrales. T 38297 , F 160, S 8, H B 23558, I/A 50 ( 2.01.13).
15 de Junio de 2012Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDITIA INTERNATIONAL SL. Datos registrales. T 38297 , F 160, S 8, H B 23558, I/A 49 (6.06.12).
10 de Noviembre de 2011Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDITIA INTERNATIONAL SL. Datos registrales. T 38297 , F 160, S 8, H B 23558, I/A 48(28.10.11).
05 de Febrero de 2010Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: REHACSA PROMOCIONES SL. Datos registrales. T 38297 , F 158, S 8, H B23558, I/A 47 (25.01.10).
16 de Febrero de 2009Revocaciones. APODERADO: LUESMA FERNANDEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 38297 , F 158, S 8, H B 23558, I/A 46 (3.02.09).